KING AUTOMOTIVE SYSTEMS LIMITED

KING AUTOMOTIVE SYSTEMS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameKING AUTOMOTIVE SYSTEMS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 00966412
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von KING AUTOMOTIVE SYSTEMS LIMITED?

    • Zerspanung (25620) / Verarbeitendes Gewerbe

    Wo befindet sich KING AUTOMOTIVE SYSTEMS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Central Square
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von KING AUTOMOTIVE SYSTEMS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    CAMFORD AUTOMOTIVE SYSTEMS LIMITED29. Nov. 199329. Nov. 1993
    GEO. W. KING (STEVENAGE) LIMITED31. Dez. 197631. Dez. 1976
    KING (T.I.) LIMITED18. Nov. 196918. Nov. 1969

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von KING AUTOMOTIVE SYSTEMS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2015

    Welche sind die letzten Einreichungen für KING AUTOMOTIVE SYSTEMS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    26 SeitenLIQ14

    Insolvenzmeldung

    Insolvency:form LIQ2 - secretary of state's release of liquidator
    4 SeitenLIQ MISC

    Abberufung des Liquidators durch Gerichtsbeschluss

    17 SeitenLIQ10

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    4 Seiten600

    Mitteilung über den Übergang vom Verwaltungsfall zur freiwilligen Liquidation der Gläubiger

    33 SeitenAM22

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    34 SeitenAM10

    Vermögensübersicht mit Formular AM02SOA

    16 SeitenAM02

    Ergebnis der Gläubigerversammlung

    6 SeitenAM07

    Ergebnis der Gläubigerversammlung

    6 SeitenAM07

    Geänderte Geschäftsanschrift vom King Automotive Systems, Chelmarsh, Daimler Green Coventry CV6 3LT zum Central Square 29 Wellington Street Leeds LS1 4DL am 06. Sept. 2017

    2 SeitenAD01

    Vorschlag des Verwalters

    57 SeitenAM03

    Ernennung eines Verwalters

    4 SeitenAM01

    Ernennung von Stuart David Maddison als Direktor am 11. Mai 2017

    3 SeitenAP01

    Ernennung von Mr Malcolm Michael Hayes als Direktor am 11. Mai 2017

    3 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Sanjay Tiku als Geschäftsführer am 11. Mai 2017

    2 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Kunal Sabharwal als Geschäftsführer am 11. Mai 2017

    2 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Anubhav Dham als Geschäftsführer am 11. Mai 2017

    2 SeitenTM01

    Eintragung der Belastung 009664120023, erstellt am 02. März 2017

    16 SeitenMR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2015

    66 SeitenAA

    Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 29. Sept. 2016

    • Kapital: GBP 5,000,004
    3 SeitenSH01

    Bestätigungserklärung erstellt am 15. Sept. 2016 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2014

    40 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 15. Sept. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital29. Sept. 2015

    Kapitalaufstellung am 29. Sept. 2015

    • Kapital: GBP 4
    SH01

    Rücktritt des Auditors

    1 SeitenAUD

    Wer sind die Geschäftsführer von KING AUTOMOTIVE SYSTEMS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    HAYES, Malcolm Michael
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square
    Geschäftsführer
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square
    EnglandBritish138129480001
    MADDISON, Stuart David
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square
    Geschäftsführer
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square
    United KingdomBritish233362190001
    BISHOP, Phillipa Lucy
    King Automotive Systems,
    Chelmarsh, Daimler Green
    CV6 3LT Coventry
    Sekretär
    King Automotive Systems,
    Chelmarsh, Daimler Green
    CV6 3LT Coventry
    British101086280001
    DAVIDSON, Alan Neil Ramsay, Captain
    Waterside
    Curlew Drive West Charleton
    TQ7 2AA Kingsbridge
    Devon
    Sekretär
    Waterside
    Curlew Drive West Charleton
    TQ7 2AA Kingsbridge
    Devon
    British63313000002
    DRURY, Richard Anthony
    14 Queen Street
    SG5 4NX Stotfold
    Bedfordshire
    Sekretär
    14 Queen Street
    SG5 4NX Stotfold
    Bedfordshire
    British15235520001
    KERRIGAN, Mark Thomas Farby
    52 Rowlatt Drive
    AL3 4NB St Albans
    Hertfordshire
    Sekretär
    52 Rowlatt Drive
    AL3 4NB St Albans
    Hertfordshire
    British7677530002
    MARTIN, Jonathan George
    King Automotive Systems,
    Chelmarsh, Daimler Green
    CV6 3LT Coventry
    Sekretär
    King Automotive Systems,
    Chelmarsh, Daimler Green
    CV6 3LT Coventry
    190561910001
    PATEL, Ashok Ravjibhai
    Chelmarsh
    Daimler Green
    CV6 3LT Coventry
    King Automotive Systems Limited
    West Midlands
    Sekretär
    Chelmarsh
    Daimler Green
    CV6 3LT Coventry
    King Automotive Systems Limited
    West Midlands
    British150690800001
    PAUL, Peter Michael
    Keys Cottage
    School Lane Warmington
    OX17 1DE Banbury
    Oxon
    Sekretär
    Keys Cottage
    School Lane Warmington
    OX17 1DE Banbury
    Oxon
    British7677600001
    WOTTON, Derek Frank
    King Automotive Systems,
    Chelmarsh, Daimler Green
    CV6 3LT Coventry
    Sekretär
    King Automotive Systems,
    Chelmarsh, Daimler Green
    CV6 3LT Coventry
    170962680001
    BALL, Roger William
    Bramdean 93 Coleshill Road
    Marston Green
    B37 7HT Birmingham
    West Midlands
    Geschäftsführer
    Bramdean 93 Coleshill Road
    Marston Green
    B37 7HT Birmingham
    West Midlands
    British64846000001
    BARRINGER, Terence Ian
    74 High Street
    Clophill
    MK45 4BE Bedford
    Bedfordshire
    Geschäftsführer
    74 High Street
    Clophill
    MK45 4BE Bedford
    Bedfordshire
    British7677580001
    BENTON, Derek John
    Bridge House Bradnocks Marsh Lane
    Hampton In Arden
    B92 0LL Solihull
    West Midlands
    Geschäftsführer
    Bridge House Bradnocks Marsh Lane
    Hampton In Arden
    B92 0LL Solihull
    West Midlands
    EnglandEnglish38163810002
    CHURCHMAN, Richard Alan
    The Garden Flat
    43 Abbey Road St Johns Wood
    NW8 0AA London
    Geschäftsführer
    The Garden Flat
    43 Abbey Road St Johns Wood
    NW8 0AA London
    EnglandBritish37813980001
    DAVIDSON, Alan Neil Ramsay, Captain
    Waterside
    Curlew Drive West Charleton
    TQ7 2AA Kingsbridge
    Devon
    Geschäftsführer
    Waterside
    Curlew Drive West Charleton
    TQ7 2AA Kingsbridge
    Devon
    United KingdomBritish63313000002
    DHAM, Anubhav
    King Automotive Systems,
    Chelmarsh, Daimler Green
    CV6 3LT Coventry
    Geschäftsführer
    King Automotive Systems,
    Chelmarsh, Daimler Green
    CV6 3LT Coventry
    IndiaIndian199368380001
    DHAM, Arvind
    King Automotive Systems,
    Chelmarsh, Daimler Green
    CV6 3LT Coventry
    Geschäftsführer
    King Automotive Systems,
    Chelmarsh, Daimler Green
    CV6 3LT Coventry
    IndiaIndian93665890001
    DRURY, Richard Anthony
    14 Queen Street
    SG5 4NX Stotfold
    Bedfordshire
    Geschäftsführer
    14 Queen Street
    SG5 4NX Stotfold
    Bedfordshire
    British15235520001
    FLINTHAM, John Ernest
    King Automotive Systems,
    Chelmarsh, Daimler Green
    CV6 3LT Coventry
    Geschäftsführer
    King Automotive Systems,
    Chelmarsh, Daimler Green
    CV6 3LT Coventry
    United KingdomBritish36461330002
    GREEN, Gareth Edward
    15 Richardson Crescent
    EN7 6WZ West Cheshunt
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    15 Richardson Crescent
    EN7 6WZ West Cheshunt
    Hertfordshire
    British98117470001
    HAUGHTON, Mark James
    11 Jacques Lane
    MK45 4BS Clophill
    Bedfordshire
    Geschäftsführer
    11 Jacques Lane
    MK45 4BS Clophill
    Bedfordshire
    United KingdomBritish98117320001
    JOHNSON, John Michael
    16 Unwin Close
    SG6 3RS Letchworth Garden City
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    16 Unwin Close
    SG6 3RS Letchworth Garden City
    Hertfordshire
    EnglandBritish7677540001
    PARKER, Kenneth
    Chelmarsh
    CV6 3LT Coventry
    King Automotive Systems Limited
    West Midlands
    Geschäftsführer
    Chelmarsh
    CV6 3LT Coventry
    King Automotive Systems Limited
    West Midlands
    EnglandBritish83139010002
    PARKER, Kenneth
    The Holt 5 Kingfisher Way
    Sheepy Parva
    CV9 3SW Atherstone
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    The Holt 5 Kingfisher Way
    Sheepy Parva
    CV9 3SW Atherstone
    Leicestershire
    EnglandBritish83139010002
    PATEL, Ashok Ravjibhai
    Chelmarsh
    Daimler Green
    CV6 3LT Coventry
    King Automotive Systems Ltd
    West Midlands
    Geschäftsführer
    Chelmarsh
    Daimler Green
    CV6 3LT Coventry
    King Automotive Systems Ltd
    West Midlands
    EnglandBritish36359860001
    PAUL, Peter Michael, Director
    Old Hill Farm
    London End
    CV47 7SL Priors Hardwick Southam
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    Old Hill Farm
    London End
    CV47 7SL Priors Hardwick Southam
    Warwickshire
    British7677600002
    SABHARWAL, Kunal
    Chelmarsh
    Daimler Green
    CV6 3LT Coventry
    King Automotive Systems Limited
    West Midlands
    Geschäftsführer
    Chelmarsh
    Daimler Green
    CV6 3LT Coventry
    King Automotive Systems Limited
    West Midlands
    IndiaIndian150097480001
    SMITH, Philip Anthony
    7 Graeme Road
    Sutton
    PE5 7XE Peterborough
    Cambridgeshire
    Geschäftsführer
    7 Graeme Road
    Sutton
    PE5 7XE Peterborough
    Cambridgeshire
    British117160910001
    TIKU, Sanjay
    Chelmarsh
    Daimler
    CV6 3LT Coventry
    Geschäftsführer
    Chelmarsh
    Daimler
    CV6 3LT Coventry
    IndiaIndian150831920001
    TRACEY, Michael
    5 The Old Orchard
    Ebrington
    GL55 6PA Chipping Campden
    Gloucestershire
    Geschäftsführer
    5 The Old Orchard
    Ebrington
    GL55 6PA Chipping Campden
    Gloucestershire
    British57624850001
    TULEY, Paul Scott
    2 Salters
    St Michaels Mead
    CM23 4NX Bishops Stortford
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    2 Salters
    St Michaels Mead
    CM23 4NX Bishops Stortford
    Hertfordshire
    British98120470001
    WELCH, Roderick Brett
    10 Newent Road
    B31 2ED Northfield
    West Midlands
    Geschäftsführer
    10 Newent Road
    B31 2ED Northfield
    West Midlands
    EnglandBritish90527220001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei KING AUTOMOTIVE SYSTEMS LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Freebournes Road
    CM8 3DX Witham
    16
    Essex
    England
    30. Juni 2016
    Freebournes Road
    CM8 3DX Witham
    16
    Essex
    England
    Nein
    RechtsformCompany Limited By Shares
    RegistrierungslandEngland
    RechtsgrundlageCompanies Act 2006
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer09166399
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hat das Recht, wesentlichen Einfluss oder Kontrolle über das Unternehmen auszuüben oder übt diese tatsächlich aus.
    • Die Person hat das Recht, wesentlichen Einfluss oder Kontrolle über die Aktivitäten einer Firma auszuüben oder übt diese tatsächlich aus, die nach dem Recht, das sie regelt, keine juristische Person ist; und die Mitglieder dieser Firma (in ihrer Eigenschaft als solche) haben das Recht, wesentlichen Einfluss oder Kontrolle über das Unternehmen auszuüben oder üben diese tatsächlich aus.

    Hat KING AUTOMOTIVE SYSTEMS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 02. März 2017
    Geliefert am 22. März 2017
    Ausstehend
    Belastungsgrundlage als Bare Trust: Ja
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • U.S. Bank Trustees Limited
    Transaktionen
    • 22. März 2017Registrierung einer Belastung (MR01)
    A registered charge
    Erstellt am 05. Aug. 2015
    Geliefert am 19. Aug. 2015
    Ausstehend
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Us Bank Trustees Limited
    Transaktionen
    • 19. Aug. 2015Registrierung einer Belastung (MR01)
    A registered charge
    Erstellt am 09. Apr. 2015
    Geliefert am 22. Apr. 2015
    Ausstehend
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • U.S.Bank Trustees Limited
    Transaktionen
    • 22. Apr. 2015Registrierung einer Belastung (MR01)
    Security agreement
    Erstellt am 30. Okt. 2012
    Geliefert am 12. Nov. 2012
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any chargor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Icici Bank UK PLC, Niederlassung Frankfurt Am Main
    Transaktionen
    • 12. Nov. 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 21. Jan. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Deed of amendment
    Erstellt am 06. Aug. 2012
    Geliefert am 10. Aug. 2012
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Idbi Bank Limited
    Transaktionen
    • 10. Aug. 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 21. Jan. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 26. Juli 2011
    Geliefert am 11. Aug. 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Idbi Bank Limited, Difc Branch, Dubai
    Transaktionen
    • 11. Aug. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 21. Jan. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Deed of charge over credit balances
    Erstellt am 31. März 2009
    Geliefert am 18. Apr. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) & the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon. It also creates an assignment by the chargor for the purposes of & to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) & interest thereon. Account number 03093263. sort code 20 00 00. account name bb re king automotive systems limited.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 18. Apr. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Nov. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 31. März 2009
    Geliefert am 06. Apr. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the charging company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Ford Motor Company Limited
    Transaktionen
    • 06. Apr. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Apr. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 18. März 2009
    Geliefert am 04. Apr. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Amtek Investments (UK) Limited
    Transaktionen
    • 04. Apr. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Sept. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Mortgage
    Erstellt am 16. Nov. 2005
    Geliefert am 26. Nov. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The items being plant no 1238 p j hare twin shock absorber assembly machine atlas copco tensor S7 control s/n 98X0049X200 assy, plant no 1237 p j hare twin shock absorber assembly machine atlas copco tensor S7 control s/n 98X0050X200 assy and plant no 6035 guyson orbit 800 parts washer s/n 50105 bentley assy for details of further goods charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC C/O Barclays Mercantile Business Finance Limited
    Transaktionen
    • 26. Nov. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Juni 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 04. Nov. 2005
    Geliefert am 17. Nov. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 17. Nov. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Juni 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 24. Okt. 2003
    Geliefert am 07. Nov. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited
    Transaktionen
    • 07. Nov. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Nov. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 24. Okt. 2003
    Geliefert am 29. Okt. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited
    Transaktionen
    • 29. Okt. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Nov. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 12. Juni 2002
    Geliefert am 18. Juni 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 18. Juni 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Nov. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 12. Juni 2002
    Geliefert am 18. Juni 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Lombard North Central PLC
    Transaktionen
    • 18. Juni 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Nov. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 12. Juni 2002
    Geliefert am 18. Juni 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 18. Juni 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Nov. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 01. Mai 1997
    Geliefert am 14. Mai 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the facilities agreement and the debenture as defined therein
    Kurze Angaben
    Land to the southeast of capmartin road, radford, west midlands title number wm 588798.. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 14. Mai 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Juli 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 01. Mai 1997
    Geliefert am 14. Mai 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the debenture as defined therein
    Kurze Angaben
    Land to the south east of capmartin road, redford, west midlands title number WM588798.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lombard North Central PLC
    Transaktionen
    • 14. Mai 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Juli 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Chattel mortgage
    Erstellt am 01. Mai 1997
    Geliefert am 14. Mai 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the chattel mortgage as defined therein
    Kurze Angaben
    The chattels set out on the schedule attached to the form M395 together with any part or parts thereof and all additions alternatives accessories replacements and renewals of component parts thereto and all technical records and log books thereof together with any item or items, the insurance policies and the contracts being the right and title and interest in and to the benefit of all present and future agreements relating to the chattels.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lombard North Central PLC
    Transaktionen
    • 14. Mai 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Juli 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Chattel mortgage
    Erstellt am 01. Mai 1997
    Geliefert am 14. Mai 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the facilities agreement and the chattel mortgage as defined therein
    Kurze Angaben
    The chattels set out on the schedule attached to the form M395 together with any part or parts thereof and all additions alternatives accessories replacements and renewals of component parts thereto and all technical records and log books thereof together with any item or items, the insurance policies and the contracts being the right and title and interest in and to the benefit of all present and future agreements relating to the chattels.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 14. Mai 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Juli 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 01. Mai 1997
    Geliefert am 07. Mai 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee in respect of the loan (as defined) pursuant to a deed of guaranty and indemnity of even date
    Kurze Angaben
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • 3I PLC, for Itself and as Trustee for the Investors (As Defined)
    Transaktionen
    • 07. Mai 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Juli 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 10. Feb. 1982
    Geliefert am 23. Feb. 1982
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed & floating charges undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts & uncalled capital. With all buildings fixtures (incl. Trade fixtures) fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. Feb. 1982Registrierung einer Belastung
    Guarantee debenture
    Erstellt am 10. Feb. 1982
    Geliefert am 19. Feb. 1982
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed & floating charges undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts & uncalled capital. With all buildings fixtures (incl. Trade fixtures) fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Feb. 1982Registrierung einer Belastung

    Hat KING AUTOMOTIVE SYSTEMS LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    20. Juli 2017Beginn der Verwaltung
    26. Juli 2018Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    David Matthew Hammond
    Pricewaterhousecoopers Llp Cornwall Court
    19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Praktiker
    Pricewaterhousecoopers Llp Cornwall Court
    19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Matthew Boyd Callaghan
    Pricewaterhousecoopers Llp 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praktiker
    Pricewaterhousecoopers Llp 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    David Robert Baxendale
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praktiker
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    2
    DatumTyp
    26. Juli 2018Beginn der Liquidation
    27. Dez. 2019Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    David Robert Baxendale
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praktiker
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Matthew Boyd Callaghan
    Pricewaterhousecoopers Llp 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praktiker
    Pricewaterhousecoopers Llp 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    David Matthew Hammond
    Pricewaterhousecoopers Llp Cornwall Court
    19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Praktiker
    Pricewaterhousecoopers Llp Cornwall Court
    19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0