BRITANNIA HOMES (WESTERN) LIMITED
Überblick
Unternehmensname | BRITANNIA HOMES (WESTERN) LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 00969632 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von BRITANNIA HOMES (WESTERN) LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich BRITANNIA HOMES (WESTERN) LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Yew Trees, Main Street North Aberford LS25 3AA West Yorkshire |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von BRITANNIA HOMES (WESTERN) LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
CLIFTON HOMES LIMITED | 31. Dez. 1981 | 31. Dez. 1981 |
CLIFTON HOME BUILDERS LIMITED | 06. Jan. 1970 | 06. Jan. 1970 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BRITANNIA HOMES (WESTERN) LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Sept. 2011 |
Welche sind die letzten Einreichungen für BRITANNIA HOMES (WESTERN) LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verzichtserklärung auf herrenlose Güter | 1 Seiten | BONA | ||||||||||||||||||
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 3 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 31. Mai 2013
| 5 Seiten | SH01 | ||||||||||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Jan. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Jan. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2011 | 5 Seiten | AA | ||||||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Jan. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2010 | 5 Seiten | AA | ||||||||||||||||||
Ernennung von John William Young Strachan Samuel als Direktor | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2009 | 5 Seiten | AA | ||||||||||||||||||
Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse verlegt | 1 Seiten | AD03 | ||||||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Jan. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde geändert | 1 Seiten | AD02 | ||||||||||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2008 | 5 Seiten | AA | ||||||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 353 | ||||||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von BRITANNIA HOMES (WESTERN) LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RENEW NOMINEES LIMITED | Sekretär | Yew Trees Main Street North LS25 3AA Aberford West Yorkshire | 41291250014 | |||||||
SAMUEL, John William Young Strachan | Geschäftsführer | Main Street North Aberford LS25 3AA Leeds Yew Trees | England | British | Chartered Accountant | 3909060002 | ||||
RENEW CORPORATE DIRECTOR LIMITED | Geschäftsführer | Yew Trees Main Street North LS25 3AA Aberford West Yorkshire | 91993060004 | |||||||
BARKER, James Alan | Sekretär | 20 Crabtree Park GL7 4LT Fairford Gloucestershire | British | 31113100001 | ||||||
FORSBROOK, Brian | Sekretär | The Gables Bredons Norton GL20 7EZ Tewkesbury Gloucestershire | British | Director | 5693190001 | |||||
BARKER, James Alan | Geschäftsführer | 20 Crabtree Park GL7 4LT Fairford Gloucestershire | British | Company Director | 31113100001 | |||||
CLIFT, Graham John | Geschäftsführer | 10 Church Road Alderton GL20 8NR Tewkesbury Gloucestershire | British | Architect | 5693180001 | |||||
FORSBROOK, Brian | Geschäftsführer | The Gables Bredons Norton GL20 7EZ Tewkesbury Gloucestershire | British | Director | 5693190001 | |||||
GOLDSMITH, Nicola | Geschäftsführer | Cromford 33 Eldon Road GL52 6TX Cheltenham Gloucestershire | British | Director | 41170310001 | |||||
HESTER, Geoffrey Kenneth | Geschäftsführer | 94 Redgrove Park GL51 6QZ Cheltenham Gloucestershire | United Kingdom | British | Director | 67346070001 | ||||
HESTER, Mary Kathleen | Geschäftsführer | 10 Charlton Park Gate Charlton Kings GL53 7DJ Cheltenham Gloucestershire | British | Director | 6068680001 | |||||
HORROCKS, Margaret Ann | Geschäftsführer | 91 Redgrove Park GL51 6QZ Cheltenham Gloucestershire | United Kingdom | British | Sales Manager | 38058430002 | ||||
JONES, Keith Michael | Geschäftsführer | Lightmoor House Pilford Court Leckhampton GL53 9BB Cheltenham Gloucestershire | United Kingdom | British | Director | 90844420001 | ||||
LAKEY, Daniel John | Geschäftsführer | Draycott Road Blockley GL56 9DY Moreton-In-Marsh Orchard Cottage Gloucestershire | England | British | Finance Director | 134060930001 | ||||
MCARTHUR, Alexander Nigel | Geschäftsführer | 39 Cornhill EC3V 3NU London | British | Chartered Accountant | 1571200002 | |||||
NELMES CROCKER, Michael | Geschäftsführer | Chartleys Box GL6 9HR Minchinhampton Stroud Gloucestershire | British | Company Director | 1729130003 | |||||
SELLARS, Paul | Geschäftsführer | White House Withyham TN7 4BT Hartfield East Sussex | England | British | Finance Director | 50761250001 | ||||
STEPHENSON, Daniel Francis | Geschäftsführer | 39 Cornhill EC3V 3NU London | Irish | Chartered Surveyor | 71140790004 | |||||
MONTPELLIER GROUP NOMINEES LIMITED | Geschäftsführer | 39 Cornhill EC3V 3NU London | 41291250009 |
Hat BRITANNIA HOMES (WESTERN) LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Guarantee and debenture | Erstellt am 15. Aug. 1997 Geliefert am 02. Sept. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 13. Mai 1996 Geliefert am 21. Mai 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land at randolph avenue, brimsham park, yate, gloucestershire t/n gr 178738. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 03. Apr. 1996 Geliefert am 05. Apr. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the agreement dated 7 december 1995 and all other monies and liabilities which the company covenanats in clause 3 of the legal charge to pay | |
Kurze Angaben 1G and 1H brimsham park yate. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 28. März 1996 Geliefert am 13. Apr. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £1,020,000.00 due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben 3.19 acres or thereabouts of f/h land at blackbird leys, sandford on thames, oxford, oxfordshire t/no. ON187712. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 28. März 1996 Geliefert am 10. Apr. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 5 acres or thereabouts at blackbird leys sandford on thames oxford oxfordshire t/no:- ON187401 (part). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 11. März 1996 Geliefert am 15. März 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 3.8625 acres of land at green farm quedgeley gloucestershire part t/no's GR125143 and GR125052. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 12. Feb. 1996 Geliefert am 16. Feb. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land to the rear of 53-67 church road combe down bath avon t/n-AV36608. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 04. Jan. 1996 Geliefert am 11. Jan. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land at millrace close lisvane cardiff mid glamorgan t/no part WA36903. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Charge | Erstellt am 28. Dez. 1995 Geliefert am 05. Jan. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £250,000 due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben F/H land at millrace close lisvane cardiff in the county of south glamorgan t/n wa 36903. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Floating charge | Erstellt am 28. Nov. 1995 Geliefert am 19. Dez. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Floating charge over the undertaking property and assets including uncalled capital and goodwill. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 28. Nov. 1995 Geliefert am 19. Dez. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H land lying to the north of bath road chippenham north wiltshire t/no WT126880 with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Charge and assignment | Erstellt am 19. Okt. 1995 Geliefert am 31. Okt. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben An agreement dated 14/7/95 between the company and t c savage & sond limited relating to land at woodlands estate peghouse farm slad road stroud glos. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 12. Juni 1995 Geliefert am 16. Juni 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Approx. One acre of land at church road, kingswood, bristol, avon t/nos. AV245042, AV187194, GR25294, AV54599, AV201338, GR40352 and AV163294. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 01. Juni 1995 Geliefert am 20. Juni 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land adjacent to the homestead wormelow, near hereford, hereford and worcester t/no. HW151673. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 01. Juni 1995 Geliefert am 08. Juni 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land adjoining 203 and 205 new bristol road worle weston super mare avon t/n-AV177229. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 31. Mai 1995 Geliefert am 08. Juni 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Plots 37, 38 and 39 hopton road, cam, gloucestershire t/n-GR130063 (part). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 31. Mai 1995 Geliefert am 08. Juni 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land at hereford road bromyard hereford & worcester t/n-HW110470. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 31. Mai 1995 Geliefert am 02. Juni 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £175,000 due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben Land on the south-east side of hereford rd,bromyard. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Charge and assignment | Erstellt am 22. Mai 1995 Geliefert am 31. Mai 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben (I) by way of charge all the agreement details of which are set out in the schedule hereto and the benefit of the same and all the premises comprised therein and the company's estate and interest in every conveyance,transfer or lease which may be granted to the company pursuant to the agreement.(ii) by way of assignment all moneys due or owing or from time to time becoming due or owing to the company under or by virtue of the agreement. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Charge and assignment | Erstellt am 22. Mai 1995 Geliefert am 31. Mai 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben (I) by way of charge all the agreement details of which are set out in the schedule hereto and the benefit of the same and all the premises comprised therein and the company's estate and interest in every conveyance,transfer or lease which may be granted to the company pursuant to the agreement.(ii) by way of assignment all moneys due or owing or from time to time becoming due or owing to the company under or by virtue of the agreement. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 06. Apr. 1995 Geliefert am 24. Apr. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land fronting A417 and church road, maisemore, gloucestershire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 06. Apr. 1995 Geliefert am 08. Apr. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £236,500 due from the company to the charge under the terms of the charge | |
Kurze Angaben Land at maisemore, gloucestershire on the north side of the road leading from gloucester to ledbury containing 0.900 of an acre or thereabouts and forming the site of the former village hall, maisemore. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 03. Apr. 1995 Geliefert am 07. Apr. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 0.82 acres of land at the rickyard school lane, whitminster, gloucestershire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage | Erstellt am 29. März 1995 Geliefert am 05. Apr. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £324,000 and all other monies due from the company to the chargee under the terms of the deed | |
Kurze Angaben Oxford lodge, banbury road, bicester, oxfordshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 29. März 1995 Geliefert am 04. Apr. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land at banbury road, bicester, oxfordshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0