QUEENS MOAT PROPERTIES LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | QUEENS MOAT PROPERTIES LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 00969962 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von QUEENS MOAT PROPERTIES LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich QUEENS MOAT PROPERTIES LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Suite 64 Waterhouse Business Park 2 Cromar Way CM1 2QE Chelmsford Essex England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von QUEENS MOAT PROPERTIES LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| TAYLOR WILLIAMS DEVELOPMENTS LIMITED | 21. Okt. 1987 | 21. Okt. 1987 |
| SECKLOW INVESTMENTS LIMITED | 31. Dez. 1976 | 31. Dez. 1976 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von QUEENS MOAT PROPERTIES LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2014 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für QUEENS MOAT PROPERTIES LIMITED?
| Jahresabschluss |
|
|---|
Welche sind die letzten Einreichungen für QUEENS MOAT PROPERTIES LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 68 Waterhouse Business Park 2 Cromar Way Chelmsford Essex CM1 2QE zum Suite 64 Waterhouse Business Park 2 Cromar Way Chelmsford Essex CM1 2QE am 07. Dez. 2015 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 24. Mai 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Sally Ann Coughlan am 02. Okt. 2014 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Queens Court 9-17 Eastern Road Romford Essex. RM1 3NG zum 68 Waterhouse Business Park 2 Cromar Way Chelmsford Essex CM1 2QE am 29. Sept. 2014 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 24. Mai 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von Martin Quinn als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Matthew Rosenberg als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Erwin Rieck als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 9 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 24. Mai 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von W2001 Britannia Llc als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von W2001 Two Cv als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 24. Mai 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Erwin Joseph Rieck am 12. Sept. 2011 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2010 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 24. Mai 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Ernennung von W2001 Britannia Llc als Direktor | 2 Seiten | AP02 | ||||||||||
Ernennung von W2001 Two Cv als Direktor | 2 Seiten | AP02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Veronique Menard als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von QUEENS MOAT PROPERTIES LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUGHLAN, Sally Ann | Sekretär | Waterhouse Business Park 2 Cromar Way CM1 2QE Chelmsford Suite 64 Essex England | British | 107832420001 | ||||||||||||
| QUINN, Martin Joseph | Geschäftsführer | 34 Francis Grove, Wimbledon SW19 4DT London Westmont Management Limited England | England | Irish | 186571310001 | |||||||||||
| BURGESS, Keith John | Sekretär | 3 Queen Annes Gate White House Walk GU9 9AN Farnham Surrey | British | 7009790002 | ||||||||||||
| CHRISTIAN, Tracy Joanne | Sekretär | 19 Lovell Walk RM13 7ND Rainham Essex | British | 102667300001 | ||||||||||||
| JONES, Vanessa | Sekretär | Stables House Castle Hill RH1 4LB Bletchingley Surrey | British | 72146200001 | ||||||||||||
| NOBLE, Martin Geoffrey Harold | Sekretär | 5 Sillswood MK46 5PL Olney Buckinghamshire | British | 11913310002 | ||||||||||||
| PURVIS, Martin Terence Alan | Sekretär | Fenetters Melfort Road TN6 1QT Crowborough East Sussex | British | 7901050001 | ||||||||||||
| STADEN, Paul Sidney | Sekretär | Swallows Barn New College Court MK18 5JP Chackmore Buckingham | British | 35453800001 | ||||||||||||
| WATERS, Jonathan Roy | Sekretär | Maldon Road CO3 3BQ Colchester 237 Essex | British | 129848360001 | ||||||||||||
| ALLSOP, Heather Louise | Geschäftsführer | 62 Prebend Street N1 8PS London | British | 101912850001 | ||||||||||||
| BEASLEY, Colin John | Geschäftsführer | The Ridings Plumpton Road, Woodend NN12 8RZ Towcester Northamptonshire | United Kingdom | British | 65499270001 | |||||||||||
| CAIRNS, Michael Anthony | Geschäftsführer | Birchlands Old Avenue KT13 0PY Weybridge Surrey | United Kingdom | British | 36488470001 | |||||||||||
| COLES, Alan Clifford | Geschäftsführer | The Knoll Grendon NN7 1JG Northampton Beeches, 5 Northamptonshire | England | British | 101144900002 | |||||||||||
| COLLYER, Brian Charles | Geschäftsführer | 49 Route De Croissy 78110 Le Vesinet France | Canadian | 101144260001 | ||||||||||||
| COPPEL, Andrew Maxwell | Geschäftsführer | Orchard House 8 Claremont Park Road KT10 9LT Esher Surrey | England | British | 14330100002 | |||||||||||
| CUTTS, John Charles | Geschäftsführer | Tudor Gables Old Warwick Road Lapworth B94 6AY Solihull West Midlands | United Kingdom | British | 56651680001 | |||||||||||
| GOIN, Russell Todd | Geschäftsführer | 4 Rue Jadin 75017 FOREIGN Paris France | American | 108675490001 | ||||||||||||
| KABALAN, Fadi | Geschäftsführer | Keyes House Dolphin Square SW1V 3NA London Suite 311 | England | British | 133846470001 | |||||||||||
| KRAIS, Ashley Simon | Geschäftsführer | 74 Marsh Lane NW7 4NT London | United Kingdom | British | 105921220001 | |||||||||||
| LE POIDEVIN, Andrew Daryl | Geschäftsführer | Kinneil 34 Bulstrode Way SL9 7QU Gerrards Cross Buckinghamshire | England | British | 4958800007 | |||||||||||
| MENARD, Veronique Pascale Dominique | Geschäftsführer | Goldman Sachs International Peterborough Court, 133 Fleet Street EC4A 2BB London Goldman Sachs International England | United Kingdom | French | 141156250001 | |||||||||||
| METCALFE, Michael Stuart | Geschäftsführer | Harwil 37 Howards Thicket SL9 7NT Gerrards Cross Buckinghamshire | England | British | 40294180002 | |||||||||||
| MOORE, Richard John | Geschäftsführer | 2 Maple Wood Bedhampton PO9 3JB Havant Hampshire | England | British | 101144680001 | |||||||||||
| MULAHASANI, Heather Louise | Geschäftsführer | Goldman Sachs International Peterborough Court, 133 Fleet Street EC4A 2BB London Goldman Sachs International | England | British | 136994090001 | |||||||||||
| O'SHEA, Michael Patrick | Geschäftsführer | Behihane Leckhamstead Road Wicken MK19 6BY Milton Keynes Buckinghamshire | British | 35170010001 | ||||||||||||
| OGDEN, Kathryn | Geschäftsführer | 14 Arundel Court 43-47 Arundel Gardens W11 2LP London | American | 114248790002 | ||||||||||||
| RIECK, Erwin Joseph | Geschäftsführer | Queens Court 9-17 Eastern Road RM1 3NG Romford Queens Court Essex England | German | 108675520002 | ||||||||||||
| ROSENBERG, Matthew Alexander | Geschäftsführer | Queens Court 9-17 Eastern Road RM1 3NG Romford Queens Court Essex England | England | British | 134723670001 | |||||||||||
| SCOBLE, Timothy James | Geschäftsführer | 57 Old Road Wheatley OX33 1NX Oxford Oxfordshire | United Kingdom | British | 83743120001 | |||||||||||
| STADEN, Paul Sidney | Geschäftsführer | Swallows Barn New College Court MK18 5JP Chackmore Buckingham | British | 35453800001 | ||||||||||||
| WILLIAMS, Graham Glyn | Geschäftsführer | Fairfield High Street Harpole NN7 4BS Northampton Northamptonshire | British | 12368700001 | ||||||||||||
| WILLIAMS, John Taylor | Geschäftsführer | Wappenham Manor Wappenham NN12 8SH Towcester Northamptonshire | British | 35538260001 | ||||||||||||
| W2001 BRITANNIA LLC | Geschäftsführer | The Corporation Trust Company 1209 Orange Street Wilmington The Corporation Trust Company County Of Newcastle Usa |
| 152068420001 | ||||||||||||
| W2001 TWO CV | Geschäftsführer | Strawinskylaan 1207 1077 Xx Amsterdam Strawinskylaan 1207 Netherlands |
| 152068160001 |
Hat QUEENS MOAT PROPERTIES LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A composite guarantee and debenture | Erstellt am 23. Feb. 2005 Geliefert am 04. März 2005 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to the secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 24. Nov. 2004 Geliefert am 14. Dez. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to the secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of legal mortgage all estates or interests in the f/h, l/h and other immovable property. By way of fixed charge all estates or interests in any f/h, l/h and other immovable property, all stocks shares debentures bonds notes and loan capital, the goodwill, all copyrights and patents. By way of floating charge the undertaking and all its property assets and rights. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 18. Juni 2004 Geliefert am 25. Juni 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental deed to the composite guarantee and debenture | Erstellt am 08. Juni 2004 Geliefert am 11. Juni 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor including the company to the security trustee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of legal mortgage the legally mortgaged property and sale thereof, by way of fixed charge all stocks, shares, the goodwill and uncalled capital, all copyrights, patents, by way of floating charge the undertaking, all property, assets and rights. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 25. März 2004 Geliefert am 26. März 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor including the company to the security trustee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of legal mortgage the legally mortgaged property and sale thereof, by way of fixed charge all stocks, shares, the goodwill and uncalled capital, all copyrights, patents, by way of floating charge the undertaking, all property, assets and rights. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 08. Juli 1980 Geliefert am 16. Juli 1980 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H:- 7, market square, stony stratford, milton keynes, bucks. As in a conveyance dated 9.3.79. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 16. Jan. 1980 Geliefert am 23. Jan. 1980 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H land on south east side of st. James mill road, northamptonshire & factory premises erected thereon. Title no:- nn 31115. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 16. Jan. 1980 Geliefert am 23. Jan. 1980 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H:- 8, market square, stoney stratford, milton keynes, bucks, described in a conveyance dated 9.3.79. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 25. Mai 1979 Geliefert am 14. Juni 1979 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land lying to the S.W. of sundon park road, luton beds. Title no:- bd 40444. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0