UNOMEDICAL LIMITED
Überblick
Unternehmensname | UNOMEDICAL LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aktiv |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 00976940 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von UNOMEDICAL LIMITED?
- Großhandel mit Arzneimitteln (46460) / Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen
Wo befindet sich UNOMEDICAL LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Gdc First Avenue Deeside Industrial Park CH5 2NU Deeside Flintshire United Kingdom |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von UNOMEDICAL LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
MAERSK MEDICAL LIMITED | 04. Jan. 2000 | 04. Jan. 2000 |
MAERSK MEDICAL DEVELOPMENTS LIMITED | 09. Jan. 1996 | 09. Jan. 1996 |
PHARMA-PLAST DEVELOPMENTS LIMITED | 12. Okt. 1992 | 12. Okt. 1992 |
STERISEAL BEAVER LIMITED | 19. Okt. 1987 | 19. Okt. 1987 |
N.1. MEDICAL LIMITED | 05. Aug. 1982 | 05. Aug. 1982 |
QUALITY SUTURES LIMITED | 13. Apr. 1970 | 13. Apr. 1970 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von UNOMEDICAL LIMITED?
Überfällig | Nein |
---|---|
Nächster Jahresabschluss | |
Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 31. Dez. 2024 |
Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 30. Sept. 2025 |
Letzter Jahresabschluss | |
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2023 |
Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für UNOMEDICAL LIMITED?
Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 06. Juni 2025 |
---|---|
Fälligkeit der nächsten Bescheinigung | 20. Juni 2025 |
Letzte Bestätigungsbescheinigung | |
Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 06. Juni 2024 |
Überfällig | Nein |
Welche sind die letzten Einreichungen für UNOMEDICAL LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
---|---|---|---|---|
Beendigung der Bestellung von Kamalika Ria Banerjee als Sekretär am 09. Sept. 2024 | 1 Seiten | TM02 | ||
Ernennung von Lorraine Clover als Sekretär am 09. Sept. 2024 | 2 Seiten | AP03 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2023 | 23 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 06. Juni 2024 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 7th Floor 20 Eastbourne Terrace London W2 6LG United Kingdom zum Gdc First Avenue Deeside Industrial Park Deeside Flintshire CH5 2NU am 12. Juni 2024 | 1 Seiten | AD01 | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Gdc Building First Avenue Deeside Industrial Park Deeside Flintshire CH5 2NU zum 7th Floor 20 Eastbourne Terrace London W2 6LG am 06. Juni 2024 | 1 Seiten | AD01 | ||
Beendigung der Bestellung von Grace Mccalla als Sekretär am 07. Mai 2024 | 1 Seiten | TM02 | ||
Ernennung von Mrs Kamalika Ria Banerjee als Sekretär am 07. Mai 2024 | 2 Seiten | AP03 | ||
Ernennung von Stephen James Howe als Direktor am 09. Mai 2024 | 2 Seiten | AP01 | ||
Beendigung der Bestellung von Robyn Victoria Alexandra Butler-Mason als Geschäftsführer am 09. Mai 2024 | 1 Seiten | TM01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2022 | 26 Seiten | AA | ||
Register(s) wurden an die Geschäftsanschrift Gdc Building First Avenue Deeside Industrial Park Deeside Flintshire CH5 2NU verlegt | 1 Seiten | AD04 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 06. Juni 2023 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Ernennung von Miss Grace Mccalla als Sekretär am 28. Nov. 2022 | 2 Seiten | AP03 | ||
Beendigung der Bestellung von Susan Marsden als Sekretär am 11. Nov. 2022 | 1 Seiten | TM02 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2021 | 26 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 06. Juni 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Beendigung der Bestellung von Susan Marsden als Geschäftsführer am 28. März 2022 | 1 Seiten | TM01 | ||
Ernennung von Robyn Victoria Alexandra Butler-Mason als Direktor am 28. März 2022 | 2 Seiten | AP01 | ||
Ernennung von Mrs. Fiona Victoria Ryder als Direktor am 21. März 2022 | 2 Seiten | AP01 | ||
Beendigung der Bestellung von Fathima Suzhanna Hameed-Burke als Geschäftsführer am 21. März 2022 | 1 Seiten | TM01 | ||
Beendigung der Bestellung von James Edward Spencer Kerton als Geschäftsführer am 14. Jan. 2022 | 1 Seiten | TM01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2020 | 27 Seiten | AA | ||
Ernennung von James Edward Spencer Kerton als Direktor am 29. Juni 2021 | 2 Seiten | AP01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 06. Juni 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Wer sind die Geschäftsführer von UNOMEDICAL LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLOVER, Lorraine | Sekretär | First Avenue Deeside Industrial Park CH5 2NU Deeside Gdc Flintshire United Kingdom | 327081760001 | |||||||||||
HOWE, Stephen James | Geschäftsführer | First Avenue Deeside Industrial Park CH5 2NU Deeside Gdc Flintshire United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 308443580001 | ||||||||
RYDER, Fiona Victoria, Mrs. | Geschäftsführer | First Avenue Deeside Industrial Park CH5 2NU Deeside Gdc Flintshire United Kingdom | England | British | Director | 293231040001 | ||||||||
ANDERSEN, Kim | Sekretär | Kettebakken 10 Skodsborg 2942 Denmark | Danish | Director | 63540650001 | |||||||||
BANERJEE, Kamalika Ria | Sekretär | 20 Eastbourne Terrace W2 6LG London 7th Floor United Kingdom | 323669450001 | |||||||||||
BATES, Clare Jane | Sekretär | 23 Forbury Road RG1 3JH Reading 3 Forbury Place England | 259381080001 | |||||||||||
JACKSON, Christopher Richard | Sekretär | 49 Mason Road B97 5DT Redditch Worcestershire | British | 100424500001 | ||||||||||
MARSDEN, Susan | Sekretär | First Avenue Deeside Industrial Park CH5 2NU Deeside Gdc Building Flintshire | 282550850001 | |||||||||||
MCCALLA, Grace | Sekretär | First Avenue Deeside Industrial Park CH5 2NU Deeside Gdc Building Flintshire | 302981340001 | |||||||||||
STAITE, Neil Anthony | Sekretär | Oak Tree Cottage New Road Castlemorton WR13 6BT Malvern Worcs | British | 71562900005 | ||||||||||
PRISM COSEC LIMITED | Sekretär | St Georges Business Park 207 Brooklands Road KT13 0TS Weybridge Elder House Surrey United Kingdom |
| 116519070002 | ||||||||||
SLC REGISTRARS LIMITED | Sekretär | Hersham Road KT12 1RZ Walton-On-Thames 42-50 Surrey United Kingdom |
| 34893920004 | ||||||||||
ANDERSEN, Kim | Geschäftsführer | Kettebakken 10 Skodsborg 2942 Denmark | Danish | Chartered Accountant | 63540650001 | |||||||||
BARRATT, Richard John | Geschäftsführer | First Avenue Deeside Industrial Park CH5 2NU Deeside Gdc Flintshire United Kingdom | United Kingdom | British | Finance Director | 172427280001 | ||||||||
BATES, Clare Jane | Geschäftsführer | Forbury Place 23 Forbury Road RG1 3JH Reading 3 United Kingdom | United Kingdom | British | Solicitor | 178363560001 | ||||||||
BRANDT, Henrik | Geschäftsführer | Bukkeballevej 34 Rungsted Kyst 2960 Denmark | Denmark | Danish | Director | 89136930001 | ||||||||
BROWN, Jason Conrad | Geschäftsführer | First Avenue Deeside Industrial Park CH5 2NU Deeside Gdc Building Flintshire | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 168053810001 | ||||||||
BUTLER-MASON, Robyn Victoria Alexandra | Geschäftsführer | First Avenue Deeside Industrial Park CH5 2NU Deeside Gdc Building Flintshire | England | British | Director | 294459560001 | ||||||||
CANNON, John | Geschäftsführer | Deeside Industrial Park Deeside CH5 2NU Flintshire Gdc First Avenue United Kingdom | United States | American | Finance Officer | 188153520001 | ||||||||
COTTRILL, Stephen Hedley | Geschäftsführer | First Avenue Deeside Industrial Park CH5 2NU Deeside Gdc Clwyd United Kingdom | United Kingdom | British | Solicitor | 160001530002 | ||||||||
CRAMER, Remy Rikardt | Geschäftsführer | Naerum Gadekaer 15 2850 Naerum Denmark | Danish | Company Director | 13659090001 | |||||||||
EDWARDS, Christopher Brian | Geschäftsführer | Milton Road UB10 8PU Ickenham Harrington House Middlesex | United Kingdom | British | Finance Director | 132965480002 | ||||||||
GEHRES, Frank | Geschäftsführer | Deeside Industrial Park Deeside CH5 2NU Flintshire Gdc First Avenue United Kingdom | Germany | German | Vp & German Manager Dach/Uki, Managing Director | 204302950002 | ||||||||
HAMEED-BURKE, Fathima Suzhanna | Geschäftsführer | First Avenue Deeside Industrial Park CH5 2NU Deeside Gdc Building Flintshire | England | British | Senior Finance Director | 283012460001 | ||||||||
HEGINBOTHAM, Robert | Geschäftsführer | First Avenue Deeside Industrial Park CH5 2NU Deeside Gdc Flintshire | United Kingdom | British | Plant Director | 117814740001 | ||||||||
JACKSON, Christopher Richard | Geschäftsführer | 49 Mason Road B97 5DT Redditch Worcestershire | British | Chartered Secretary | 100424500001 | |||||||||
JACOBS, Flemming Robert | Geschäftsführer | 4 Clarendon Place W2 2NP London | Danish | Company Director | 76190870002 | |||||||||
KERTON, James Edward Spencer | Geschäftsführer | 23 Forbury Road RG1 3JH Reading 3 Forbury Place England | England | British | Solicitor | 285118220001 | ||||||||
LEWIS, Sarah Jane | Geschäftsführer | First Avenue Deeside Industrial Park CH5 2NU Deeside Gdc Clwyd United Kingdom | United Kingdom | British | Finance Director | 134578980015 | ||||||||
LYDON, Michael James, Dr | Geschäftsführer | First Avenue Deeside Industrial Park CH5 2NU Deeside Gdc Flintshire | United Kingdom | British | Chief Scientific Technology Officer | 163750320001 | ||||||||
MANNING, Malcolm Stanley | Geschäftsführer | 27 Stone Delf S10 3QX Sheffield South Yorkshire | United Kingdom | British | Company Director | 70744660001 | ||||||||
MARSDEN, Susan | Geschäftsführer | 23 Forbury Road RG1 3JH Reading 3 Forbury Place England | United Kingdom | British | Deputy Company Secretary Fcis | 258807410001 | ||||||||
RICHARDSON, Alan Robert | Geschäftsführer | Deeside Industrial Park Deeside CH5 2NU Flintshire Gdc Building First Avenue England And Wales United Kingdom | United Kingdom | British | Vice President, Operational Performance | 200871680002 | ||||||||
SEDWELL, Christopher John | Geschäftsführer | First Avenue Deeside Industrial Park CH5 2NU Deeside Gdc Flintshire United Kingdom | England | British | Chartered Accountant | 290688980001 | ||||||||
SORENSEN, Henrik Sven | Geschäftsführer | 88 Lea Green Lane Wythall B47 6HN Birmingham West Midlands | Danish | General Manager | 72624560001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei UNOMEDICAL LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unomedical Holdings Limited | 06. Apr. 2016 | Deeside Industrial Park Deeside CH5 2NU Flintshire Gdc Building First Avenue England And Wales United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat UNOMEDICAL LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Erstellt am 31. Okt. 2016 Geliefert am 11. Nov. 2016 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung The intellectual property specified in the instrument including patent no. D616994 (biomedical electrode).. For more details, please refer to the instrument. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 31. Okt. 2016 Geliefert am 11. Nov. 2016 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung The intellectual property specified in the instrument including trademark no. 1935642 registered in the united kingdom. For more details, please refer to the instrument. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 07. Sept. 2015 Geliefert am 09. Sept. 2015 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung Unilect trade mark no 79023051 please see image for details of further land (including buildings), ship, aircraft or intellectual property charged. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Intellectual property security agreement | Erstellt am 26. Sept. 2011 Geliefert am 14. Okt. 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All of its right title and interest in all intellectual property all books and recores pertaining to the intellectual property. Unomedical limited D555,788 29/237,304 device for fixating a tube relative to a skin surface part of a patient or person. Unomedical limited D558,464 29/282,522 biomedical electrode for attachment to skin. Unomedical limited D586,464 29/282,522 epidural catheter fixation device (for further details of intellectual property charged please refer to the form MG01) see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Fixed and floating security agreement | Erstellt am 22. Dez. 2010 Geliefert am 07. Jan. 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Assignment of bank account | Erstellt am 04. März 2009 Geliefert am 06. März 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company or any obligor to ant secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All present and future right, title and interest in each assigned account- a/no- 40004203. iban number- GB22CHAS60924240004203 see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Assignment of bank account | Erstellt am 27. Feb. 2009 Geliefert am 06. März 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company or any obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All present and future right title and interest in each assigned account being; account no. 40004201 iban no. GB76CHAS60924240004201 and account no. 40004202 iban no. GB49CHAS60924240004202. See image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Supplemental debenture | Erstellt am 28. Okt. 2008 Geliefert am 11. Nov. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company or an obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben F/H unit 3 brunel way stroudwater business park stonehouse glos t/no GR170198/GR160449,f/h unit 4 brunel way stroudwater business park stonehouse glos t/no GR164981 first fixed charge all its present and future insurances and all related proceeds,claims of any kind,returns of premium and other benefits see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Fixed & floating security document | Erstellt am 02. Sept. 2008 Geliefert am 09. Sept. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from a chargor or an obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of debenture | Erstellt am 06. März 2003 Geliefert am 21. März 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee as security agent and trustee for itself and the other beneficiaries (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0