KELNIGAL GROUP LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | KELNIGAL GROUP LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 00979170 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von KELNIGAL GROUP LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich KELNIGAL GROUP LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 200 Great Dover Street SE1 4YB London England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von KELNIGAL GROUP LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| HIGH-POINT RENDEL GROUP LIMITED | 26. Feb. 2007 | 26. Feb. 2007 |
| HIGH-POINT RENDEL GROUP PLC | 14. Jan. 1998 | 14. Jan. 1998 |
| HIGH-POINT PLC | 06. Okt. 1988 | 06. Okt. 1988 |
| HIGH-POINT SERVICES GROUP PLC | 31. Dez. 1977 | 31. Dez. 1977 |
| HIGH-POINT CONTRACT SERVICES LIMITED | 08. Mai 1970 | 08. Mai 1970 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von KELNIGAL GROUP LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2015 |
Welche sind die letzten Einreichungen für KELNIGAL GROUP LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 09. Jan. 2017 mit Aktualisierungen | 7 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 31. März 2016 bis 30. Sept. 2016 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 61 Southwark Street London SE1 1SA zum 200 Great Dover Street London SE1 4YB am 06. Juli 2016 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 09. Jan. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 12. Jan. 2016
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2015 | 16 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bescheinigung über die Änderung der Firma Company name changed high-point rendel group LIMITED\certificate issued on 04/08/15 | 2 Seiten | CERTNM | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Hinweis auf Namensänderung | 2 Seiten | CONNOT | ||||||||||||||
Erfüllung der Belastung 009791700014 vollständig | 6 Seiten | MR04 | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 09. Jan. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2014 | 17 Seiten | AA | ||||||||||||||
Rücktritt des Auditors | 1 Seiten | AUD | ||||||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verkürzt von 19. Apr. 2014 bis 31. März 2014 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 19. Apr. 2013 | 16 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 05. Dez. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verkürzt von 31. Juli 2013 bis 19. Apr. 2013 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||||||
Erfüllung der Belastung 13 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||||||
Eintragung der Belastung 009791700014 | 191 Seiten | MR01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Juli 2012 | 16 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 05. Dez. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von KELNIGAL GROUP LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARSONS, Charlotte Louise | Sekretär | Great Dover Street SE1 4YB London 200 England | Other | 135626530001 | ||||||
| BELL, Nigel Stuart | Geschäftsführer | Great Dover Street SE1 4YB London 200 England | United Kingdom | British | 91913690001 | |||||
| HINGLEY, Kelvin William Thomas | Geschäftsführer | Great Dover Street SE1 4YB London 200 England | United Kingdom | British | 50467220002 | |||||
| PARSONS, Charlotte Louise | Geschäftsführer | Great Dover Street SE1 4YB London 200 England | United Kingdom | British | 140414820004 | |||||
| BEST, John David | Sekretär | Milbanke 43 Lady Byron Lane Knowle B93 9AX Solihull West Midlands | British | 2810080001 | ||||||
| DAVISON, Suzanne | Sekretär | 106a Coppermill Lane Walthamstow E17 7HE London | British | 80856470001 | ||||||
| DESMOND, Pat | Sekretär | 7 Regents Drive BR2 6BU Keston Kent | British | 52839700001 | ||||||
| DIXON, Leslie Albert | Sekretär | 167 St Bernards Road B92 7DH Solihull West Midlands | British | 3640870001 | ||||||
| FINDLAY, Ian Scott | Sekretär | 4 The Cobbles Off Priory Walk B72 1XE Sutton Coldfield West Midlands | British | 54138670001 | ||||||
| FINDLAY, Ian Scott | Sekretär | 4 The Cobbles Off Priory Walk B72 1XE Sutton Coldfield West Midlands | British | 54138670001 | ||||||
| GREENWOOD, Stephen Harold | Sekretär | 45 New Concordia Wharf Mill Street SE1 2BB London | British | 71052650001 | ||||||
| GREENWOOD, Stephen Harold | Sekretär | 45 New Concordia Wharf Mill Street SE1 2BB London | British | 71052650001 | ||||||
| TRENDELL, William Anthony | Sekretär | Victorian Rendezvous 18 Rectory Close Merrow GU4 7AR Guildford Surrey | British | 12317760001 | ||||||
| BENNETT, Melvin Eugene | Geschäftsführer | 2016 Bulrush Lane Cardiff By The Sea FOREIGN San Diego Ca 92007 Usa | American | 43502520002 | ||||||
| DESMOND, Pat | Geschäftsführer | 7 Regents Drive BR2 6BU Keston Kent | British | 52839700001 | ||||||
| DIXON, Leslie Albert | Geschäftsführer | 167 St Bernards Road B92 7DH Solihull West Midlands | British | 3640870001 | ||||||
| FINDLAY, Ian Scott | Geschäftsführer | 4 The Cobbles Off Priory Walk B72 1XE Sutton Coldfield West Midlands | British | 54138670001 | ||||||
| GREENWOOD, Stephen Harold | Geschäftsführer | 45 New Concordia Wharf Mill Street SE1 2BB London | British | 71052650001 | ||||||
| HOOKWAY, David Wilfred | Geschäftsführer | 68 Hartley Old Road CR8 4HJ Purley Surrey | British | 374710001 | ||||||
| JOHNSON, Peter | Geschäftsführer | 54 Mymms Drive Brookmans Park AL9 7AF Hatfield Hertfordshire | British | 11342310001 | ||||||
| PALMER, Horace Anthony | Geschäftsführer | Fairfield London Road Sunninghill SL5 0PH Ascot Berkshire | United Kingdom | British | 45646020002 | |||||
| PERREY, Derek Randall | Geschäftsführer | Oaklands Rockbear Hill Marsh Green EX5 2EZ Exeter | British | 12614160001 | ||||||
| REEVES, Ian William | Geschäftsführer | Hewletts Mill Galhampton BA22 7BG Yeovil Somerset | British | 71881990001 | ||||||
| REEVES, Ian William | Geschäftsführer | Hewletts Mill Galhampton BA22 7BG Yeovil Somerset | British | 71881990001 | ||||||
| SHEPPARD, Allen John George, The Right Honourable Lord | Geschäftsführer | Didgmere Hall Low Hill Road Roydon CM19 5JN Harlow Essex | Great Britain | British | 66789210001 | |||||
| SMITH, Martin Christopher Geoffrey | Geschäftsführer | 9 Finlarigg Drive Edgbaston B15 3RH Birmingham West Midlands | England | British | 71281420001 | |||||
| STUBBS, Robert John | Geschäftsführer | 40 Tolmers Road Cuffley EN6 4JF Potters Bar Hertfordshire | United Kingdom | British | 40694340001 | |||||
| TREE, David George | Geschäftsführer | East Wickham 59 College Lane Hurstpierpoint BN6 9AD Hassocks West Sussex | British | 64855130001 | ||||||
| TRENDELL, William Anthony | Geschäftsführer | Victorian Rendezvous 18 Rectory Close Merrow GU4 7AR Guildford Surrey | England | British | 12317760001 | |||||
| WHARTON, Robert Victor | Geschäftsführer | Seven Clare Drive Edgbaston B15 3LP Birmingham West Midlands | United Kingdom | British | 3640880001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei KELNIGAL GROUP LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört |
|---|---|---|---|
| Mr Kelvin William Thomas Hingley | 06. Apr. 2016 | Great Dover Street SE1 4YB London 200 England | Nein |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: United Kingdom | |||
Arten der Kontrolle
| |||
| Mr Nigel Stuart Bell | 06. Apr. 2016 | Great Dover Street SE1 4YB London 200 England | Nein |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: United Kingdom | |||
Arten der Kontrolle
| |||
Hat KELNIGAL GROUP LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 22. Apr. 2013 Geliefert am 10. Mai 2013 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung Trade mark: hp-high point. Class: 16. registration number: 1074975. notification of addition to or amendment of charge. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 27. Mai 2010 Geliefert am 04. Juni 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 19. Juli 2005 Geliefert am 27. Juli 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee and debenture by the company and high-point rendel limited, high-point europe limited, vantagepoint management consultants (public sector) limited | Erstellt am 04. Juli 2001 Geliefert am 24. Juli 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge | Erstellt am 16. Feb. 1999 Geliefert am 17. Feb. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Book debts and all the goodwill of the business. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of assignment | Erstellt am 10. Juni 1997 Geliefert am 19. Juni 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever and under the terms of the facility agreement being the master facilities agreement dated 9 june 1997 (as therein defined) | |
Kurze Angaben The agreement being the placing and offer agreement dated 10/6/97 relating to a placing and open offer of ordinary shares of 1P each in high-point PLC and the benefit of the same and assigns all right title and interest in and to all moneys owing under the agreement. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee and debenture | Erstellt am 09. Okt. 1995 Geliefert am 12. Okt. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 14. Juni 1989 Geliefert am 20. Juni 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 16. Dez. 1986 Geliefert am 05. Jan. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben No 11 amen lodge ave. Maria lane l/b or the city of london t/no - lgl 427936. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 16. Dez. 1986 Geliefert am 05. Jan. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The penthouse, amen lodge ave, maria lane l/borne city of london t/no-ngl 137194. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 30. Jan. 1985 Geliefert am 06. Feb. 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Property situate and known as the penthouse amen lodge, warwick lane london EC4 title no ngl 137194 and flat 11 amen lodge warwick lane london EC4 title no ngl 427936 together with all buildings, trade and other fixtures, fixed plant and machinery. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 01. Juli 1982 Geliefert am 15. Juli 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 01. Okt. 1980 Geliefert am 06. Okt. 1980 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/Hold 6TH & part 7TH floor of king edward house, new st. Birmingham B2 4QW. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 11. Aug. 1980 Geliefert am 21. Aug. 1980 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 2A highfield road, dartford kent, title no k 464228. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0