AUTOBAR INVESTMENTS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | AUTOBAR INVESTMENTS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 00980004 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von AUTOBAR INVESTMENTS LIMITED?
- Sonstige Verpflegungsdienste (56290) / Gastgewerbe
Wo befindet sich AUTOBAR INVESTMENTS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Apollo House Odyssey Business Park West End Road HA4 6QD Ruislip Middlesex England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von AUTOBAR INVESTMENTS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| AUTOBAR FRESHBREW LIMITED | 19. Mai 1970 | 19. Mai 1970 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von AUTOBAR INVESTMENTS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2016 |
Welche sind die letzten Einreichungen für AUTOBAR INVESTMENTS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||||||
Aktienkonsolidierung am 19. Okt. 2017 | 4 Seiten | SH02 | ||||||||||||||
legacy | 3 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 20. Okt. 2017
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 3 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Erfüllung der Belastung 7 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||||||
Ernennung von David Christophe Marc Flochel als Direktor am 25. Sept. 2017 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Ernennung von Wesley Mulligan als Direktor am 25. Sept. 2017 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Ghassan Nicolas Kara als Geschäftsführer am 25. Sept. 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 08. März 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde vom C/O Speechly Bircham Llp 7 Albemarle Street London W1S 4HQ England zum C/O Speechly Bircham Llp 7 Albemarle Street London W1S 4HQ geändert | 1 Seiten | AD02 | ||||||||||||||
Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse C/O Speechly Bircham Llp 7 Albemarle Street London W1S 4HQ verlegt | 1 Seiten | AD03 | ||||||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde vom C/O Speechly Bircham Llp 6 New Street Square London EC4A 3LX United Kingdom zum C/O Speechly Bircham Llp 7 Albemarle Street London W1S 4HQ geändert | 1 Seiten | AD02 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2016 | 16 Seiten | AA | ||||||||||||||
Ernennung von Dr Ghassan Nicolas Kara als Direktor am 01. Juli 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Kris Paul Ludo Geysels als Geschäftsführer am 01. Juli 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 08. März 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 29. März 2015 | 17 Seiten | AA | ||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom , East Wing 14th Floor, 389 Chiswick High Road, Chiswick London, W4 4AJ zum Apollo House Odyssey Business Park West End Road Ruislip Middlesex HA4 6QD am 29. Juli 2015 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 08. März 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 26. Feb. 2015
| 4 Seiten | SH01 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | RESOLUTIONS | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von AUTOBAR INVESTMENTS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABRAHAMS, Daniel Henry | Geschäftsführer | Odyssey Business Park West End Road HA4 6QD Ruislip Apollo House Middlesex England | England | British | 183822370001 | |||||
| FLOCHEL, David Christophe Marc | Geschäftsführer | Hinterbergstrasse 6330 Cham 20 Switzerland | Switzerland | French | 238363320001 | |||||
| MULLIGAN, Wesley | Geschäftsführer | Lime Tree Way Chineham RG24 8GG Basingstoke Spinnaker House England | England | Irish | 238363000001 | |||||
| GREENWOOD, Michael Frank | Sekretär | Gloucester Road Kew TW9 3BT Richmond 51 Surrey | British | 90910000002 | ||||||
| MCKAY, William Trevor | Sekretär | 1 West Court HA0 3QQ North Wembley Middlesex | British | 588890001 | ||||||
| BRISTOW, Andrew Wyatt | Geschäftsführer | Garden Road BR1 3LX Bromley 22 Kent | England | British | 8748280008 | |||||
| DAVEY, Michael John | Geschäftsführer | 225 Sheen Lane East Sheen SW14 8LE London | United Kingdom | British | 976330001 | |||||
| GEYSELS, Kris Paul Ludo | Geschäftsführer | Odyssey Business Park West End Road HA4 6QD Ruislip Apollo House Middlesex England | Belgium | Belgian | 193655140001 | |||||
| GREENWOOD, Michael Frank | Geschäftsführer | Gloucester Road Kew TW9 3BT Richmond 51 Surrey | United Kingdom | British | 90910000002 | |||||
| KARA, Ghassan Nicolas, Dr | Geschäftsführer | Odyssey Business Park West End Road HA4 6QD Ruislip Apollo House Middlesex England | Uk | French/Lebanese | 210351450001 | |||||
| MACKIE, Brian | Geschäftsführer | 14th Floor 389 Chiswick High Road W4 4AJ Chiswick London East Wing | Scotland | British | 173446330001 | |||||
| O'LEARY, Mark Joseph Christopher | Geschäftsführer | 14 Meadow View SL7 3PA Marlow Bottom Buckinghamshire | Irish | 43800040002 | ||||||
| SMITH, Carl | Geschäftsführer | 96-122 Uxbridge Road West Ealing W13 8RD London 124 Lovelace House | British | 132430250001 | ||||||
| WALFORD, Anthony William Cecil | Geschäftsführer | Toque House Salters Meadow Beacon Hill HP10 8NH Penn Buckinghamshire | British | 2198510001 | ||||||
| WHITELING, Mark Argent | Geschäftsführer | 14th Floor 389 Chiswick High Road W4 4AJ Chiswick London East Wing | England | British | 101297630001 | |||||
| WILLIS, Helen Margaret | Geschäftsführer | 14th Floor 389 Chiswick High Road W4 4AJ Chiswick London East Wing | United Kingdom | British | 277089380001 | |||||
| ZOLDAN, Ronald Anthony | Geschäftsführer | 14 Pipers Green Lane HA8 8DG Edgware Middlesex | United Kingdom | British | 8256490001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei AUTOBAR INVESTMENTS LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autobar Industries Limited | 06. Apr. 2016 | Odyssey Business Park, West End Road HA4 6QD Ruislip Apollo House Middlesex England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat AUTOBAR INVESTMENTS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Fixed and flotaing security document | Erstellt am 19. Okt. 2010 Geliefert am 22. Okt. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of accession | Erstellt am 12. Dez. 2005 Geliefert am 20. Dez. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee (whether for its own account or as security agent for the secured parties) or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of accession to a debenture dated 2 july 2004 | Erstellt am 02. Aug. 2004 Geliefert am 10. Aug. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All right title and interest in and to a) the real property b) the tangible moveable property c) the accounts d) the intellectual property e) any goodwill. Assigns a) the proceeds of any insurance policy and all related rights b) all rights and claims in relation to any assigned account. By way of floating charge the assets and undertaking. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Inter company letter of sett off | Erstellt am 01. Aug. 1983 Geliefert am 18. Aug. 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credito of any present or future account of the company. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Letter of set off | Erstellt am 11. Sept. 1978 Geliefert am 20. Sept. 1978 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the co with the bank. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 10. Juni 1976 Geliefert am 11. Juni 1976 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land and buildings on the south east side of sheffield road, timoley, south yorkshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge without instrument | Erstellt am 03. Juni 1976 Geliefert am 10. Juni 1976 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land and buildins on the south east side of sheffield road, timoley, south yorkshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0