PORT HAMPTON LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | PORT HAMPTON LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 00981408 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von PORT HAMPTON LIMITED?
- Sonstige Vermietung und Verpachtung eigener oder gepachteter Immobilien (68209) / Grundstücks- und Wohnungswesen
Wo befindet sich PORT HAMPTON LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 50 New Bond Street W1S 1BJ London United Kingdom |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von PORT HAMPTON LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Sept. 2014 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für PORT HAMPTON LIMITED?
| Jahresabschluss |
|
|---|
Welche sind die letzten Einreichungen für PORT HAMPTON LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Terrace Hill (Secretaries) Limited am 28. Okt. 2015 | 1 Seiten | CH04 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 22. Sept. 2015
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von Mr Philip Alexander Jeremy Leech als Direktor am 28. Mai 2015 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Robert Edward Lane als Geschäftsführer am 28. Aug. 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Robert Edward Lane am 08. Juni 2015 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Jonathan Martin Austen am 08. Juni 2015 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 1 Portland Place London W1B 1PN zum 50 New Bond Street London W1S 1BJ am 08. Juni 2015 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2014 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 28. März 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2013 | 13 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 28. März 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Thomas Walsh als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Jonathan Martin Austen als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2012 | 13 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 28. März 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Robert Edward Lane am 05. Juli 2012 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2011 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 28. März 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Terrace Hill (Secretaries) Limited am 19. Aug. 2011 | 2 Seiten | CH04 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von PORT HAMPTON LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URBAN&CIVIC (SECRETARIES) LIMITED | Sekretär | 115 George Street EH2 4JN Edinburgh 4th Floor United Kingdom |
| 41006000014 | ||||||||||
| AUSTEN, Jonathan Martin | Geschäftsführer | W1S 1BJ London 50 New Bond Street United Kingdom | United Kingdom | British | 51921200001 | |||||||||
| LEECH, Philip Alexander Jeremy | Geschäftsführer | W1S 1BJ London 50 New Bond Street United Kingdom | England | British | 77080490002 | |||||||||
| FARROW, Elizabeth | Sekretär | 30 Cardinal Avenue KT2 5SB Kingston Upon Thames Surrey | British | 25613800001 | ||||||||||
| GAN, Karen Kheg Lin | Sekretär | Flat 73 Grange Gardens The Bourne N14 6QN Southgate London | Malaysian | 38520290001 | ||||||||||
| SINCLAIR, Cherie Lynda | Sekretär | 31 Cross Road Wimbledon SW19 1PL London | British | 39655330002 | ||||||||||
| WALSH, Thomas Gerard | Sekretär | 26 Flanders Road Chiswick W4 1NG London | Irish | 48520230001 | ||||||||||
| ADAIR, Robert Fredrik Martin | Geschäftsführer | 31 Pembroke Square W8 6PB London | British | 37096760001 | ||||||||||
| LANE, Robert Edward | Geschäftsführer | W1S 1BJ London 50 New Bond Street United Kingdom | United Kingdom | British | 71610620005 | |||||||||
| LLEWELLYN, Hazel | Geschäftsführer | 23 Pelham Road SW19 1SU London | England | British | 231573640001 | |||||||||
| TOPLAS, David Hugh Sheridan | Geschäftsführer | Mill Haven Chestnut Avenue GU2 4HF Guildford Surrey | England | British | 77200680001 | |||||||||
| TURNBULL, Nigel James Cavers | Geschäftsführer | 17 Salisbury Avenue AL5 2QF Harpenden Hertfordshire | England | British | 1604580001 | |||||||||
| WALSH, Thomas Gerard | Geschäftsführer | Portland Place W1B 1PN London 1 | England | Irish | 48520230001 |
Hat PORT HAMPTON LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 23. Apr. 2010 Geliefert am 30. Apr. 2010 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben For details of property charged please refer to form MG01 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 23. Apr. 2010 Geliefert am 30. Apr. 2010 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben For details of property charged please refer to form MG01 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating charge | Erstellt am 20. Feb. 1996 Geliefert am 28. Feb. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Kurze Angaben L/H property k/a platts eyot hampton the footbridge leading thereto and the car park on the lower south side of lower sunbury road richmond upon thames under the lease (as defined). See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Cash collateral agreement | Erstellt am 21. Feb. 1990 Geliefert am 08. März 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility agreement dated 21ST february 1990 | |
Kurze Angaben All the company's right title and interest in and to all sums standing to credit the deposit account in the name of the company with bank of scotland number 01610782 (see 395 for further details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee and debenture | Erstellt am 21. Feb. 1990 Geliefert am 08. März 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility agreement dated 21ST february 1990 | |
Kurze Angaben First fixed charge over all estates and other interests in any f/h l/h and immovable property belonging to the company all the l/h premises at platt's eyot hampton the footbridge leading thereto and land on the southside of lower sundrey road richmond upon thames (please see 395 for further details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0