REEVES WIRELINE INVESTMENTS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | REEVES WIRELINE INVESTMENTS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 00986376 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von REEVES WIRELINE INVESTMENTS LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich REEVES WIRELINE INVESTMENTS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Gotham Road East Leake LE12 6JX Loughborough Leicestershire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von REEVES WIRELINE INVESTMENTS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| WIRELINE INVESTMENTS LIMITED | 01. Apr. 1994 | 01. Apr. 1994 |
| BPB INSTRUMENTS INTERNATIONAL LIMITED | 24. März 1986 | 24. März 1986 |
| ISLE OF ELY PAPER SACKS LIMITED | 07. Aug. 1970 | 07. Aug. 1970 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von REEVES WIRELINE INVESTMENTS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2013 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für REEVES WIRELINE INVESTMENTS LIMITED?
| Jahresabschluss |
|
|---|
Welche sind die letzten Einreichungen für REEVES WIRELINE INVESTMENTS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 4 Seiten | 4.71 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 2 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von Mr Neil Alexander Macleod als Direktor am 28. Aug. 2014 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Ian Jones als Geschäftsführer am 28. Aug. 2014 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 29. Juni 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Erfüllung der Belastung 3 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Ms Julie Mary Thomson als Direktor am 27. Aug. 2013 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mrs Gemma Rose-Garvie als Sekretär am 27. Aug. 2013 | 1 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Brian Moncur als Sekretär am 27. Aug. 2013 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Brian Moncur als Geschäftsführer am 05. Aug. 2013 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 29. Juni 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr Euan Robertson Prentice als Direktor am 04. Sept. 2012 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von William Gray Fulton als Geschäftsführer am 04. Sept. 2012 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 29. Juni 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 29. Juni 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Ian Jones am 22. Juni 2011 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr William Gray Fulton am 22. Juni 2011 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Mr Brian Moncur am 22. Juni 2011 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Gotham Road East Leake Loughborough Leicestershire LE12 6JX am 16. Mai 2011 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von REEVES WIRELINE INVESTMENTS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROSE-GARVIE, Gemma | Sekretär | East Leake LE12 6JX Loughborough Gotham Road Leicestershire United Kingdom | 180875850001 | |||||||
| MACLEOD, Neil Alexander | Geschäftsführer | East Leake LE12 6JX Loughborough Gotham Road Leicestershire | Scotland | British | 177581770001 | |||||
| PRENTICE, Euan Robertson | Geschäftsführer | Souter Head Road Altens Industrial Estate AB12 3LF Aberdeen Weatherford Centre Scotland | Scotland | British | 168927430001 | |||||
| THOMSON, Julie Mary | Geschäftsführer | East Leake LE12 6JX Loughborough Gotham Road Leicestershire United Kingdom | Scotland | British | 171856740001 | |||||
| ATKIN, James Reginald | Sekretär | Laurel Cottage Tithby Road Cropwell Butler NG12 3AA Nottingham Nottinghamshire | British | 55311660001 | ||||||
| ATKIN, James Reginald | Sekretär | Laurel Cottage Tithby Road Cropwell Butler NG12 3AA Nottingham Nottinghamshire | British | 55311660001 | ||||||
| FULTON, William Gray | Sekretär | 2 Lawson Drive Dyce AB21 0DR Aberdeen Weatherford House United Kingdom | British | 138793410001 | ||||||
| HYDE, Robin Anthony | Sekretär | 56 Belper Road DE1 3EN Derby Derbyshire | British | 14363830002 | ||||||
| MONCUR, Brian | Sekretär | East Leake LE12 6JX Loughborough Gotham Road Leicestershire United Kingdom | 146420320001 | |||||||
| WROOT, Richard Wilson | Sekretär | 25 Burlington Road Sherwood NG5 2GR Nottingham | British | 73604700002 | ||||||
| BECKETT, Michael Ernest | Geschäftsführer | Northcroft Dulwich Common SE21 7EW London | British | 118661100001 | ||||||
| BOYES, John Stewart | Geschäftsführer | Cosford Hall Farm Cosford CV21 1HT Rugby Warwickshire | Uk | British | 10479120001 | |||||
| FULTON, William Gray | Geschäftsführer | East Leake LE12 6JX Loughborough Gotham Road Leicestershire United Kingdom | United Kingdom | British | 139048390001 | |||||
| HYDE, Robin Anthony | Geschäftsführer | 56 Belper Road DE1 3EN Derby Derbyshire | British | 14363830002 | ||||||
| JONES, Ian | Geschäftsführer | East Leake LE12 6JX Loughborough Gotham Road Leicestershire United Kingdom | England | British | 57632040002 | |||||
| MARTIN, Burt Michael | Geschäftsführer | 4817 Welford 77401 Bellaire Texas | United States | 74615750001 | ||||||
| MCNULTY, Michael Joseph | Geschäftsführer | 1121 Wentworth View S.W. Calgary Alberta T3h 5k3 Canada | Canadian | 100108550001 | ||||||
| MONCUR, Brian | Geschäftsführer | Souter Head Road Altens Industrial Estate AB12 3LF Aberdeen Weatherford Centre United Kingdom | United Kingdom | British | 118915490001 | |||||
| REEVES, Donald Richard | Geschäftsführer | Lindum House Grantham Road Whatton NG13 9EU Nottingham Nottinghamshire | British | 14037750001 | ||||||
| SPENCER, Michael Charles | Geschäftsführer | Cleeve House Melton Road Hickling Pastures LE14 3QG Melton Mowbray Leicestershire | England | British | 14363850002 | |||||
| SYDNEY-SMITH, Peter Edward | Geschäftsführer | Laundry House Laundry Lane Heckfield RG27 0LF Basingstoke Hampshire | British | 13962530002 | ||||||
| WHATMOUGH, Michael John | Geschäftsführer | 41 Kings Road SL4 2AD Windsor Berkshire | British | 13032520001 |
Hat REEVES WIRELINE INVESTMENTS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 24. Dez. 1998 Geliefert am 06. Jan. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Share pledge | Erstellt am 11. Juli 1995 Geliefert am 28. Juli 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever including (without limitation) pursuant to the facilities agreement | |
Kurze Angaben The company as security for the obligations assigns mortgages charges hypoothecates and pladges to the bank the shares. The charge provides that the pledged shares shall include any substitution therefor, additions thereto or proceeds thereof, arising out of any consolidation, subdivision, reclassification, stock dividend or similar increase or decrease in or alteration of the capital of the issuer of thepledged shares (the "issuer") or any other event.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee and debenture | Erstellt am 11. Juli 1995 Geliefert am 21. Juli 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company or any other group company to the chargee on any account whatsoever including but not limited to under the facilities agreement dated 11TH july 1995 | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat REEVES WIRELINE INVESTMENTS LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0