W WILLOW LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Bestätigungsbescheinigung
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameW WILLOW LIMITED
    UnternehmensstatusLiquidation
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 00988028
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von W WILLOW LIMITED?

    • (1533) /
    • (1583) /

    Wo befindet sich W WILLOW LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Orchard House
    Irthlingborough
    NN9 5DB Wellingborough
    Northamptonshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von W WILLOW LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    WHITWORTHS LIMITED25. März 198525. März 1985
    W & M PUMPHREY LIMITED27. Aug. 197027. Aug. 1970

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von W WILLOW LIMITED?

    ÜberfälligJa
    Nächster Jahresabschluss
    Ende des nächsten Geschäftsjahres am27. Apr. 2000
    Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am27. Mai 2001
    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Apr. 1999

    Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für W WILLOW LIMITED?

    ÜberfälligJa
    Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis12. Juli 2016
    Fälligkeit der nächsten Bescheinigung26. Juli 2016
    ÜberfälligJa

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für W WILLOW LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss
    ÜberfälligJa

    Welche sind die letzten Einreichungen für W WILLOW LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Wiederherstellung durch Gerichtsbeschluss - zuvor in Gläubigerinsolvenz

    3 SeitenREST-CVL

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ2

    Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde ausgesetzt

    1 SeitenDISS16(SOAS)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Wiederherstellung durch Gerichtsbeschluss

    4 SeitenAC92

    legacy

    1 SeitenLIQ

    Beendigung der Liquidation

    1 SeitenL64.07

    Gerichtsbeschluss zur Liquidation

    2 SeitenCOCOMP

    Bescheinigung über die Änderung der Firma

    Company name changed whitworths LIMITED\certificate issued on 18/04/01
    2 SeitenCERTNM

    legacy

    2 Seiten244

    legacy

    8 Seiten363s

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    1 Seiten288b

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Apr. 1999

    16 SeitenAA

    legacy

    4 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288c

    legacy

    5 Seiten395

    legacy

    1 Seiten244

    legacy

    3 Seiten288a

    legacy

    3 Seiten288a

    legacy

    8 Seiten363s
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    annual-return30. Juli 1999

    legacy

    363(288)

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Apr. 1998

    16 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    Wer sind die Geschäftsführer von W WILLOW LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    VICARY, Gary Kevin
    Desborough Manorial Road
    Parkgate
    CH64 6QN Neston
    Wirral
    Sekretär
    Desborough Manorial Road
    Parkgate
    CH64 6QN Neston
    Wirral
    British18943850005
    COOK, Bernard
    Ferndale Cottage Ascott Road
    Whichford
    CV36 5PE Shipston On Stour
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    Ferndale Cottage Ascott Road
    Whichford
    CV36 5PE Shipston On Stour
    Warwickshire
    EnglandBritish12836850003
    DIGGINES, Jonathan Brett
    Rossways
    32 Broad Lane
    WA15 0DH Hale
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Rossways
    32 Broad Lane
    WA15 0DH Hale
    Cheshire
    British80119110001
    PRATT, David
    The Yews 60 High Street
    Burwell
    CB5 0HD Cambridge
    Geschäftsführer
    The Yews 60 High Street
    Burwell
    CB5 0HD Cambridge
    British61204820001
    THOMAS, Barbara, Lady
    St James's Street
    SW1A 1HD London
    33
    Geschäftsführer
    St James's Street
    SW1A 1HD London
    33
    American88709030001
    VICARY, Gary Kevin
    Desborough Manorial Road
    Parkgate
    CH64 6QN Neston
    Wirral
    Geschäftsführer
    Desborough Manorial Road
    Parkgate
    CH64 6QN Neston
    Wirral
    British18943850005
    ROBERTS, Peter
    5 Nene Rise
    Cogenhoe
    NN7 1NT Northampton
    Northamptonshire
    Sekretär
    5 Nene Rise
    Cogenhoe
    NN7 1NT Northampton
    Northamptonshire
    British9010990001
    ROBERTSON, Duncan Murray Lindsay
    Cherry Orchard
    Hilltop Lane
    OX9 4BH Chinnor
    Oxfordshire
    Sekretär
    Cherry Orchard
    Hilltop Lane
    OX9 4BH Chinnor
    Oxfordshire
    British34806130002
    THOMAS, Christopher Owen
    Barnett House Bierton
    HP22 5DL Aylesbury
    Buckinghamshire
    Sekretär
    Barnett House Bierton
    HP22 5DL Aylesbury
    Buckinghamshire
    British9213140001
    THOMAS, Richard
    Cefn Bryn
    Gwernaffield Road
    CH7 1RQ Mold
    Flintshire
    Sekretär
    Cefn Bryn
    Gwernaffield Road
    CH7 1RQ Mold
    Flintshire
    British55309350002
    AIRD, Michael John
    11 Iron Mill Cottages
    Minchinhampton
    GL6 9AL Stroud
    Geschäftsführer
    11 Iron Mill Cottages
    Minchinhampton
    GL6 9AL Stroud
    United KingdomBritish94978940001
    ALLAWAY, Michael John
    Grove Cottage
    Blounts Court Road
    RG9 5EU Peppard
    Henley On Thames
    Geschäftsführer
    Grove Cottage
    Blounts Court Road
    RG9 5EU Peppard
    Henley On Thames
    United KingdomBritish37618690001
    ATKINSON, Ivor Clive
    Well House
    Bramfield
    SG14 2QF Hertford
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Well House
    Bramfield
    SG14 2QF Hertford
    Hertfordshire
    British9010970001
    BRADBURY, Vernon John
    The Hayloft 3 Chapel View
    Little Brington
    NN7 4HX Northampton
    Geschäftsführer
    The Hayloft 3 Chapel View
    Little Brington
    NN7 4HX Northampton
    British58339670001
    CURTIS, Keith Robert
    Persimmon House 26 Wentworth Drive
    Oundle
    PE8 4QF Peterborough
    Geschäftsführer
    Persimmon House 26 Wentworth Drive
    Oundle
    PE8 4QF Peterborough
    British6141480002
    MCCUTCHEON, John
    11 Spinney Field
    Ellington
    PE28 0AT Huntingdon
    Cambridgeshire
    Geschäftsführer
    11 Spinney Field
    Ellington
    PE28 0AT Huntingdon
    Cambridgeshire
    EnglandBritish4991790003
    MERCHANT, Peter Anthony
    Pen Y Maes Back Lane
    Astbury Somerford
    CW12 4RB Congleton
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Pen Y Maes Back Lane
    Astbury Somerford
    CW12 4RB Congleton
    Cheshire
    EnglandBritish47424990001
    PRICE, Stephen
    The Willows
    Water Stratford
    MK18 5DU Buckingham
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    The Willows
    Water Stratford
    MK18 5DU Buckingham
    Buckinghamshire
    EnglandBritish73146560001
    REYNOLDS, David
    Burdyke
    Wood Lane Weekley
    NN16 9UX Kettering
    Northants
    Geschäftsführer
    Burdyke
    Wood Lane Weekley
    NN16 9UX Kettering
    Northants
    EnglandBritish7422360001
    RIDGWELL, Patrick George
    84 Hall Lane
    RM14 1AQ Upminster
    Essex
    Geschäftsführer
    84 Hall Lane
    RM14 1AQ Upminster
    Essex
    EnglandBritish55921800001
    ROBERTS, Peter
    5 Nene Rise
    Cogenhoe
    NN7 1NT Northampton
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    5 Nene Rise
    Cogenhoe
    NN7 1NT Northampton
    Northamptonshire
    British9010990001
    ROBERTSON, Duncan Murray Lindsay
    Cherry Orchard
    Hilltop Lane
    OX9 4BH Chinnor
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    Cherry Orchard
    Hilltop Lane
    OX9 4BH Chinnor
    Oxfordshire
    United KingdomBritish34806130002
    SANDERS, Nigel Mervyn
    11 Holne Chase
    N2 0PQ London
    Geschäftsführer
    11 Holne Chase
    N2 0PQ London
    British12411620001
    SOOD, Rajan
    37 Park Avenue North
    NN3 2HT Northampton
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    37 Park Avenue North
    NN3 2HT Northampton
    Northamptonshire
    British103861970001
    THOMAS, Christopher Owen
    Barnett House Bierton
    HP22 5DL Aylesbury
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Barnett House Bierton
    HP22 5DL Aylesbury
    Buckinghamshire
    British9213140001
    THOMAS, Richard
    Cefn Bryn
    Gwernaffield Road
    CH7 1RQ Mold
    Flintshire
    Geschäftsführer
    Cefn Bryn
    Gwernaffield Road
    CH7 1RQ Mold
    Flintshire
    British55309350002
    WADDELL, Judith Lillian
    The Hay Loft 3 Chapel View
    Little Brington
    NN7 4HX Northampton
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    The Hay Loft 3 Chapel View
    Little Brington
    NN7 4HX Northampton
    Northamptonshire
    British70404500001

    Hat W WILLOW LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal charge
    Erstellt am 29. März 2000
    Geliefert am 14. Apr. 2000
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All obligations and liabilities due or to become due from the company or the group companies (as defined in the agreements) to the chargee on any account whatsoever under this charge
    Kurze Angaben
    F/Hold property known as land/blds on north west side of wellingborough rd,irthlingborough; t/no nn 138948;all other estates or interests in any property. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 14. Apr. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 06. Mai 1997
    Geliefert am 15. Mai 1997
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any group company (as defined) to the chargee pursuant to the guarantee (as defined) or otherwise; and on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land lying to the south of a road leading to windmill road, irthingborough; f/h land lying to the north west of wellingborough road, irthlingborough;f/h land on the south east side of victoria street, irthlingborough t/nos: NN105630 NN74056 and NN138951. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC; As Security Trustee for the Security Beneficiaries (As Defined)
    Transaktionen
    • 15. Mai 1997Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 15. Mai 1985
    Geliefert am 23. Mai 1985
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over all f/hold & l/hold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charge over undertaking and all property and assets present and future including goodwill, bookdebts. & benefit of any licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. Mai 1985Registrierung einer Belastung

    Hat W WILLOW LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    31. Mai 2002Abschluss der Liquidation
    13. Aug. 2001Beginn der Liquidation
    15. Mai 2001Antragsdatum
    Zwangsliquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    The Official Receiver Or Northampton
    Scottish Life House
    29 St Katherines Street
    NN1 5GA Northampton
    Praktiker
    Scottish Life House
    29 St Katherines Street
    NN1 5GA Northampton

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0