WINGAS STORAGE ENTERPRISE LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | WINGAS STORAGE ENTERPRISE LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 00989348 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von WINGAS STORAGE ENTERPRISE LIMITED?
- Förderung von Erdgas (06200) / Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden
Wo befindet sich WINGAS STORAGE ENTERPRISE LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Fairview House Victoria Place CA1 1HP Carlisle Cumbria |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von WINGAS STORAGE ENTERPRISE LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| ROC OIL (CEL) LTD | 21. Juli 1999 | 21. Juli 1999 |
| CAMBRIAN EXPLORATION LIMITED | 15. Sept. 1970 | 15. Sept. 1970 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von WINGAS STORAGE ENTERPRISE LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2015 |
Welche sind die letzten Einreichungen für WINGAS STORAGE ENTERPRISE LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verzichtserklärung auf herrenlose Güter | 1 Seiten | BONA | ||||||||||
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 7 Seiten | LIQ13 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Building 3 Chiswick Business Park 566 Chiswick High Road London W4 5YA zum Fairview House Victoria Place Carlisle Cumbria CA1 1HP am 25. Jan. 2017 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 26. Okt. 2016 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 26. Okt. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 26. Okt. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 11 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr Peter Gordon Adams als Sekretär | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Fraser Ashman als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 26. Okt. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 26. Okt. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Helmut Conrad Cordes als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Joachim Hobrecker als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Stephen Dewald als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 26. Okt. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2010 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr Joachim Hobrecker als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von WINGAS STORAGE ENTERPRISE LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAMS, Peter Gordon | Sekretär | Victoria Place CA1 1HP Carlisle Fairview House Cumbria | 189076600001 | |||||||
| CORDES, Helmut Conrad | Geschäftsführer | Victoria Place CA1 1HP Carlisle Fairview House Cumbria | United Kingdom | German | 171814320001 | |||||
| ASHMAN, Fraser Lionel | Sekretär | Building 3 Chiswick Business Park W4 5YA 566 Chiswick High Road London | British | 73535420002 | ||||||
| BUTLER, Neil | Sekretär | Crop House Main Street, Upton NG23 5TE Newark Nottinghamshire | British | 65804260001 | ||||||
| CAINES, Christine Edith | Sekretär | 15 Millfield Avenue Saxilby LN1 2QN Lincoln Lincolnshire | British | 85981610001 | ||||||
| COMBES, Michael Patrick | Sekretär | 36 Fairway GU1 2XN Guildford Surrey | British | 102888420001 | ||||||
| CUMMING, Robert Cameron | Sekretär | 6 Carding Hill AB41 8BG Ellon Aberdeenshire | British | 35356450001 | ||||||
| SANDERS, Jan | Sekretär | Danes Cottage Navestock Side CM14 5SE Brentwood Essex | British | 98651250001 | ||||||
| STEVENSON, Rosalind Jane | Sekretär | 58 Pump Hollow Lane Forest Town NG19 0AS Mansfield Nottinghamshire | British | 65556130001 | ||||||
| ATKINSON, John Paul | Geschäftsführer | The Orangery Burton LN1 2RD Lincoln Lincolnshire | British | 64084360001 | ||||||
| BAINES, Edgar | Geschäftsführer | 18 Winnowsty Lane LN2 5RZ Lincoln | British | 68877560002 | ||||||
| BRAATEN, Peter Alfred | Geschäftsführer | 4 Fair Fields Green Lane KT11 2NN Cobham Surrey | Canadian | 30784310002 | ||||||
| BUTLER, Neil | Geschäftsführer | Crop House Main Street, Upton NG23 5TE Newark Nottinghamshire | United Kingdom | British | 65804260001 | |||||
| COLBURNE, Stewart Ancil | Geschäftsführer | 24 Vardell Place Nw T3A 0BD Calgary Canada | British | 48097870001 | ||||||
| DEBONI, Walter | Geschäftsführer | 127 Oakside Close T2V 4T9 Calgary Alberta Canada | Canada | Canadian | 43590580001 | |||||
| DEWALD, Stephen, Dr | Geschäftsführer | Building 3 Chiswick Business Park W4 5YA 566 Chiswick High Road London | Germany | German | 135676420001 | |||||
| DORAN, John, Dr | Geschäftsführer | 30 Cranbrook Road Bellevue Hill New South Wales 2023 Australia | British | 65503190003 | ||||||
| GIBSON SMITH, Christopher Shaw, Dr | Geschäftsführer | Lansdowne White Lane GU4 8PR Guildford Surrey | United Kingdom | British | 76355430001 | |||||
| HOBRECKER, Joachim | Geschäftsführer | Building 3 Chiswick Business Park W4 5YA 566 Chiswick High Road London | United Kingdom | German | 156428510001 | |||||
| KLINGENBERGER, Peter, Dr | Geschäftsführer | 37 A Zum Berggarten Kassel 34130 Germany | German | 102888350002 | ||||||
| LEHMANN, Thomas | Geschäftsführer | 8a Park Road Twickenham TW1 2PX Middx Tw1 2px | German | 102888260002 | ||||||
| LUNDIN, Ian | Geschäftsführer | Jadaf Shipyard PO BOX 9211 Dubai United Arab Emigrants | Swedish | 58813850001 | ||||||
| MCCUE, Nigel Robert | Geschäftsführer | PO BOX 9211 Dubai FOREIGN United Arab Emirates | British | 35135170001 | ||||||
| MORRIS, Robin Dale | Geschäftsführer | Netherton Of Glenboig Farm Fintry G63 0YH Stirlingshire | Uk | British | 34878230001 | |||||
| STEVENSON, Rosalind Jane | Geschäftsführer | 58 Pump Hollow Lane Forest Town NG19 0AS Mansfield Nottinghamshire | British | 65556130001 | ||||||
| TAUCHNITZ, Frank, Dr | Geschäftsführer | Building 3 Chiswick Business Park W4 5YA 566 Chiswick High Road London | England | German | 135521180002 | |||||
| VAN DEN BRINK, Giksbertus Wilhelmus | Geschäftsführer | 4 Tring Avenue Ealing W5 3QA London | Dutch | 119737090001 | ||||||
| WOOD, David Anthony, Dr | Geschäftsführer | 25 Badgers Oak Bassingham LN5 9JP Lincoln | England | British | 35340490002 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei WINGAS STORAGE ENTERPRISE LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Russian Federation | 06. Apr. 2016 | Federal Agency For State Property Mangement Nikolskaya Lane, 9 Moscow C/O Russia | Nein | ||||
| |||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||
Hat WINGAS STORAGE ENTERPRISE LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Supplemental debenture supplemental to an original guarantee and debenture referred to in the restated credit agreement dated 14 july 1993 as amended and restated by a deed of amendment of guarantee and debenture dated 4 july 1997 | Erstellt am 31. Jan. 2000 Geliefert am 18. Feb. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each obligor to the agent, the arranger, the banks and the swap bank (or any of them) under each of the finance documents (as defined) to which such obligor is a party together with all costs charges and expenses incurred by the agent, the arranger or any bank in connection with the protection, preservation or enforcement of its respective rights under the finance documents | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee and debenture dated 14TH july 1993 as amended and restated by a deed of amendment of guarantee and debenture between mmrl (UK) limited, cambrian exploration limited, candecca resources limited and barclays bank PLC as agent and trustee (the agent) for itself and each bank (as defined) | Erstellt am 04. Juli 1997 Geliefert am 25. Juli 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each obligor to the agent, the arranger, the banks and the swap bank (or any of them) under each of the finance documents (as defined) to which such obligor is a party together with all costs charges and expenses incurred by the agent, the arranger or any bank in connection with the protection, preservation or enforcement of its respective rights under the finance documents | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee and debenture | Erstellt am 14. Juli 1993 Geliefert am 30. Juli 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the finance documents (as defined) | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Secured guarantee | Erstellt am 15. Juni 1982 Geliefert am 19. Juli 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from candecca resources PLC under the terms of the facility letter dated 28.5.82 | |
Kurze Angaben All bookdebts & other debts now & from time to time owing to the company. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Operating agreement | Erstellt am 07. Dez. 1977 Geliefert am 28. Dez. 1977 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due under the terms of the charge | |
Kurze Angaben All rights & interests of the company under the licences referred to in the operating agreement with all equipment & materials acquired under the operating agreement (see doc M35). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Operating agreement | Erstellt am 07. Dez. 1977 Geliefert am 28. Dez. 1977 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due under the terms of the charge | |
Kurze Angaben All rights & interests of the company under the licences referred to in the operating agreement with all equipment & materials acquired under the operating agreement. (See doc M34). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat WINGAS STORAGE ENTERPRISE LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0