CROMWELL LAND LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameCROMWELL LAND LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 00989850
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von CROMWELL LAND LIMITED?

    • Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen

    Wo befindet sich CROMWELL LAND LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    12 Charles Ii Street
    SW1Y 4QU London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von CROMWELL LAND LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    CROMWELL LAND SECURITIES LIMITED06. Dez. 199006. Dez. 1990
    CROMWELL LAND SECURITY LIMITED19. Nov. 199019. Nov. 1990
    CITYLAND PROPERTIES AND INVESTMENTS LIMITED15. Feb. 198915. Feb. 1989
    CITYLAND HOTELS LIMITED22. Sept. 197022. Sept. 1970

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CROMWELL LAND LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2014

    Welche sind die letzten Einreichungen für CROMWELL LAND LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Kapitalaufstellung am 11. Okt. 2016

    • Kapital: GBP 1
    3 SeitenSH19

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    legacy

    1 SeitenSH20

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    Jahresrückblick erstellt bis 23. Feb. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital24. Feb. 2016

    Kapitalaufstellung am 24. Feb. 2016

    • Kapital: GBP 10,000
    SH01

    Erfüllung der Belastung 54 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 53 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 52 vollständig

    4 SeitenMR04

    Beendigung der Bestellung von Iain Douglas Bond als Geschäftsführer am 30. Nov. 2015

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2014

    20 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 12. Jan. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital12. Jan. 2015

    Kapitalaufstellung am 12. Jan. 2015

    • Kapital: GBP 10,000
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2013

    20 SeitenAA

    Verschiedenes

    Section 519
    1 SeitenMISC

    Verschiedenes

    Aud res sec 519
    1 SeitenMISC

    Verschiedenes

    Sect 519
    2 SeitenMISC

    Rücktritt des Auditors

    2 SeitenAUD

    Jahresrückblick erstellt bis 10. Jan. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital10. Jan. 2014

    Kapitalaufstellung am 10. Jan. 2014

    • Kapital: GBP 10,000
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2012

    21 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 08. Jan. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2011

    20 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 12. Jan. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01

    Beendigung der Bestellung von Sharon Kerridge als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Wer sind die Geschäftsführer von CROMWELL LAND LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    WYLLIE, Alison
    Charles Ii Street
    SW1Y 4QU London
    12
    United Kingdom
    Sekretär
    Charles Ii Street
    SW1Y 4QU London
    12
    United Kingdom
    British107811220001
    HUXTABLE, Christopher John
    Charles Ii Street
    SW1Y 4QU London
    12
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Charles Ii Street
    SW1Y 4QU London
    12
    United Kingdom
    EnglandBritishInvestment Banker156351910001
    THORP, Timothy Geoffrey
    Charles Ii Street
    SW1Y 4QU London
    12
    Geschäftsführer
    Charles Ii Street
    SW1Y 4QU London
    12
    EnglandBritishChartered Accountant66923730003
    BANDEL, Martin Howard
    Gable End
    29 Christchurch Crescent
    WD7 8AQ Radlett
    Hertfordshire
    Sekretär
    Gable End
    29 Christchurch Crescent
    WD7 8AQ Radlett
    Hertfordshire
    BritishCompany Secretary37249220002
    COLE, Jennifer
    Flat 2 The Earl Of Devon
    213 Devons Road Bow Common
    E3 3QX London
    Sekretär
    Flat 2 The Earl Of Devon
    213 Devons Road Bow Common
    E3 3QX London
    British74489480002
    FORSTER, Helen
    Flat 4
    5 Corkran Road
    KT6 6PL Surbiton
    Surrey
    Sekretär
    Flat 4
    5 Corkran Road
    KT6 6PL Surbiton
    Surrey
    British106129360001
    JENKINSON, Louisa Jane
    12 Amberley Close
    Send
    GU23 7BX Woking
    Surrey
    Sekretär
    12 Amberley Close
    Send
    GU23 7BX Woking
    Surrey
    British106060330002
    LYON, Karen
    Belvedere Court
    372-374 Upper Richmond Road
    SW15 6HY London
    33
    United Kingdom
    Sekretär
    Belvedere Court
    372-374 Upper Richmond Road
    SW15 6HY London
    33
    United Kingdom
    Other140536930001
    MILLER, Philip
    87 Sutton Court
    Fauconberg Road
    W4 3JF London
    Sekretär
    87 Sutton Court
    Fauconberg Road
    W4 3JF London
    British121053850001
    POOLE, Rebecca Louise
    69b Replingham Road
    Southfields
    SW18 5LU Wimbledon
    Sekretär
    69b Replingham Road
    Southfields
    SW18 5LU Wimbledon
    British92013940001
    STUART-SMITH, Gordon
    Summerview Chequers Park
    Wye
    TN25 5BA Ashford
    Kent
    Sekretär
    Summerview Chequers Park
    Wye
    TN25 5BA Ashford
    Kent
    British5463920001
    PATERNOSTER SECRETARIES LIMITED
    55 Basinghall Street
    EC2V 5HD London
    Sekretär
    55 Basinghall Street
    EC2V 5HD London
    76827740001
    ALLPORT, Howard Coplestone
    20 Fernshaw Road
    SW10 0TE London
    Geschäftsführer
    20 Fernshaw Road
    SW10 0TE London
    BritishCo Director3356770001
    BANDEL, Martin Howard
    Flat 6
    1/2 Alma Square St Johns Wood
    NW8 9QD London
    Geschäftsführer
    Flat 6
    1/2 Alma Square St Johns Wood
    NW8 9QD London
    BritishChartered Accountant37249220003
    BOND, Iain Douglas
    Charles Ii Street
    SW1Y 4QU London
    12
    Geschäftsführer
    Charles Ii Street
    SW1Y 4QU London
    12
    United KingdomBritishProperty Director68687180001
    DESAI, Arunkumar Bhilalbhai
    Jubilee Place
    SW3 3TQ London
    2
    England
    Geschäftsführer
    Jubilee Place
    SW3 3TQ London
    2
    England
    United KingdomBritishGroup Accountant84225840001
    DESAI, Arunkumar Bhilalbhai
    12 Cherry Close
    SM5 2BW Carshalton
    Surrey
    Geschäftsführer
    12 Cherry Close
    SM5 2BW Carshalton
    Surrey
    United KingdomBritishGroup Accountant84225840001
    EDWARDS, Dylan Crocker
    22 Greenway Gardens
    UB6 9TT Greenford
    Middlesex
    Geschäftsführer
    22 Greenway Gardens
    UB6 9TT Greenford
    Middlesex
    BritishSurveyor5965630001
    GLEDHILL, Sarah Louise
    Charles Ii Street
    SW1Y 4QU London
    12
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Charles Ii Street
    SW1Y 4QU London
    12
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant131963100002
    GLOVER, Edward Douglas
    Charles Ii Street
    SW1Y 4QU London
    12
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Charles Ii Street
    SW1Y 4QU London
    12
    United Kingdom
    United KingdomBritishMerchant Banker121380002
    HAYES, Laurence Edwin
    Jubilee Place
    SW3 3TQ London
    2
    England
    Geschäftsführer
    Jubilee Place
    SW3 3TQ London
    2
    England
    United KingdomBritishAccountant192784770001
    HOLBROOK, Carolyn
    5 Croftside
    CO8 5LL Bures St Mary
    Suffolk
    Geschäftsführer
    5 Croftside
    CO8 5LL Bures St Mary
    Suffolk
    United KingdomBritishProperty Management165098780001
    KERRIDGE, Sharon Diana Mandy
    Charles Ii Street
    SW1Y 4QU London
    12
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Charles Ii Street
    SW1Y 4QU London
    12
    United Kingdom
    United KingdomBritishBanker128267610003
    MOFFAT, Andrew David John
    Jubilee Place
    SW3 3TQ London
    2
    England
    Geschäftsführer
    Jubilee Place
    SW3 3TQ London
    2
    England
    EnglandBritishMerchant Banker34399870003
    RAWLINS, Richard Denis
    183 Ramsden Road
    SW12 8RG London
    Geschäftsführer
    183 Ramsden Road
    SW12 8RG London
    United KingdomBritishSurveyor56889050001
    STUART-SMITH, Gordon
    Summerview Chequers Park
    Wye
    TN25 5BA Ashford
    Kent
    Geschäftsführer
    Summerview Chequers Park
    Wye
    TN25 5BA Ashford
    Kent
    BritishAccountant5463920001
    SZPIRO, Toby Nicholas Maximilian
    Flat 3
    18 Camden Hill Gardens
    W8 7AY London
    Geschäftsführer
    Flat 3
    18 Camden Hill Gardens
    W8 7AY London
    United KingdomBritishCompany Director76573230001
    THORP, Timothy Geoffrey
    3 St George's Road
    TN13 3ND Sevenoaks
    Kent
    Geschäftsführer
    3 St George's Road
    TN13 3ND Sevenoaks
    Kent
    EnglandBritishChartered Accountant66923730003

    Hat CROMWELL LAND LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Charge over bank accounts
    Erstellt am 21. Juni 2011
    Geliefert am 30. Juni 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed charge the charged balance and charged accounts see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society (Security Trustee)
    Transaktionen
    • 30. Juni 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 06. Feb. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 10. Juni 2011
    Geliefert am 22. Juni 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Raglan court empire way wembley t/n P137078, fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society (Security Trustee)
    Transaktionen
    • 22. Juni 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 26. Jan. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 10. Juni 2011
    Geliefert am 22. Juni 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Flat 8 raglan court empire way wembley t/n NGL782443, flat 19 raglan court empire way wembley t/n NGL782442, flat 20 raglan court empire way wembley t/n NGL782441, for details of further properties charged, please refer to form MG01, together with all buildings, fixtures (including trade fixtures), fixed plant & machinery thereon, the goodwill of any business carried on at the property, the benefit of all licences & registration required in the running of such a business (see image for full details).
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society (Security Trustee)
    Transaktionen
    • 22. Juni 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 15. Jan. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 16. Juli 1996
    Geliefert am 31. Juli 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 31. Juli 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Juni 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 06. März 1996
    Geliefert am 12. März 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of legal mortgage f/h land situated at 3, 5 and 7 whitegate road and 2, 4 and 6 warrior square, southend on sea t/no. EX171106 and the goodwill of any business carried on at the property. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 12. März 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Mai 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 30. Aug. 1994
    Geliefert am 31. Aug. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    49 atlanta street, fulham, together with the benefit of all rights licences and covenants affecting the property, fixed charge over all plant and other machinery,fixtures and fittings ,furniture and equipment ,implements and utensils etc... the present and future goodwill of any business carried on at or about the property.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC,
    Transaktionen
    • 31. Aug. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Mai 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge.
    Erstellt am 30. Aug. 1994
    Geliefert am 31. Aug. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    6 to 18 tudor court , russell hill. Purley,croydon. London together with all covenants and rightrs affecting or concerning the property , the plant and machinery and fixtures and fittings furniture, equipment implements and utensils, of the company now and in the future at the property ,the present and future goodwill of any business carried on at or about the property. Please see doc for further details,.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC,
    Transaktionen
    • 31. Aug. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Mai 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge.
    Erstellt am 30. Aug. 1994
    Geliefert am 31. Aug. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    1 to 66 kensington mansions, trebovir road, kensington and chelsea, together with the benefit of all covenants and rights affecting or concerning the property , all plant and other machinery fixtures and fittings ,furniture equipment ,implements and utensils. The present and future goodwill of any business carried on at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC,
    Transaktionen
    • 31. Aug. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Juni 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 30. Aug. 1994
    Geliefert am 31. Aug. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    2 to 10A purley parade ,(excluding no .3 ) high street, purley. Fixed charge over all covenants and rights affecting or concerning the property, the plant ,machinery , and fixtures and fittings ,furniture, equipment ,implements utensils,of the company now and in the future at the property. The present and future goodwill of the business carried on at the property .
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC.
    Transaktionen
    • 31. Aug. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Mai 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite debenture
    Erstellt am 27. Sept. 1990
    Geliefert am 05. Okt. 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of a guarantee of evendate.
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 05. Okt. 1990Registrierung einer Belastung
    • 12. Juni 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 25. Nov. 1988
    Geliefert am 30. Nov. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    141, finborough road, london SW10. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Charterhouse Bank Limited
    Transaktionen
    • 30. Nov. 1988Registrierung einer Belastung
    • 04. Mai 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 05. Aug. 1988
    Geliefert am 16. Aug. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    91, bere hill crescent, andover, hampshire. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Charterhouse Bank Limited
    Transaktionen
    • 16. Aug. 1988Registrierung einer Belastung
    • 04. Mai 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 15. Juli 1988
    Geliefert am 22. Juli 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    First and fixed legal charge over property k/as 67 penge road london SE 25.. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Charterhouse Bank Limited
    Transaktionen
    • 22. Juli 1988Registrierung einer Belastung
    • 04. Mai 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 25. Apr. 1988
    Geliefert am 03. Mai 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed charge 103A westbourne grove london. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Charterhouse Bank Limited
    Transaktionen
    • 03. Mai 1988Registrierung einer Belastung
    • 04. Mai 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 05. Feb. 1988
    Geliefert am 23. Feb. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H courtfield rd london SW7 t/no ngl 599654 fixed and. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Swordheath Properties Limited
    Transaktionen
    • 23. Feb. 1988Registrierung einer Belastung
    • 11. Juni 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 26. Jan. 1988
    Geliefert am 02. Feb. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed charge over:- 3 north street, horsham west sussex and,. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Charterhouse Bank Limited
    Transaktionen
    • 02. Feb. 1988Registrierung einer Belastung
    • 04. Mai 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 27. Aug. 1987
    Geliefert am 04. Sept. 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property k/a 30, downland place, adastral road, canford heath, poole, dorset title no: dt 105678 fixed and. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Charterhouse Bank Limited
    Transaktionen
    • 04. Sept. 1987Registrierung einer Belastung
    • 04. Mai 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge registered pursuant to a statutory declaration dated 11/9/87
    Erstellt am 18. Aug. 1987
    Geliefert am 03. Sept. 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H-69 denmark hill, camberwell, london SE5 T.no:- sgl 279325. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Charterhouse Bank Limited
    Transaktionen
    • 03. Sept. 1987Registrierung einer Belastung
    • 04. Mai 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 07. Mai 1987
    Geliefert am 09. Mai 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    42, finborough rd; london SW10. Floating charge.
    Berechtigte Personen
    • Charterhouse Bank Limited
    Transaktionen
    • 09. Mai 1987Registrierung einer Belastung
    • 04. Mai 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 06. Apr. 1987
    Geliefert am 08. Apr. 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    106 church rd, richmond surrey floating charge.
    Berechtigte Personen
    • Charterhouse Bank Limited
    Transaktionen
    • 08. Apr. 1987Registrierung einer Belastung
    • 04. Mai 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 02. Jan. 1987
    Geliefert am 07. Jan. 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 37, courtfield road, london SW7 title no ngl 455035 inc fixtures fittings plant, machinery, implements,utensils furniture & equipment.
    Berechtigte Personen
    • Charterhouse Bank Limited
    Transaktionen
    • 07. Jan. 1987Registrierung einer Belastung
    • 04. Mai 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 04. Aug. 1986
    Geliefert am 06. Aug. 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Flat e, angel house, pentonville road, london N1. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Charterhouse Bank Limited
    Transaktionen
    • 06. Aug. 1986Registrierung einer Belastung
    • 04. Mai 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 25. Juni 1986
    Geliefert am 28. Juni 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property 338 south norwood hill, london SE25 and floating charge.
    Berechtigte Personen
    • Charterhouse Japhet PLC
    Transaktionen
    • 28. Juni 1986Registrierung einer Belastung
    • 04. Mai 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 06. Jan. 1986
    Geliefert am 10. Jan. 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Flat 4, 15 whitworth road, london SE25.
    Berechtigte Personen
    • Charterhouse Japhet PLC
    Transaktionen
    • 10. Jan. 1986Registrierung einer Belastung
    • 04. Mai 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 06. Jan. 1986
    Geliefert am 10. Jan. 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    41 ronelean road, folworth r b of kingston upon thames.
    Berechtigte Personen
    • Charterhouse Japhet PLC
    Transaktionen
    • 10. Jan. 1986Registrierung einer Belastung
    • 04. Mai 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0