CROMWELL LAND LIMITED
Überblick
Unternehmensname | CROMWELL LAND LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 00989850 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von CROMWELL LAND LIMITED?
- Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen
Wo befindet sich CROMWELL LAND LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 12 Charles Ii Street SW1Y 4QU London |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von CROMWELL LAND LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
CROMWELL LAND SECURITIES LIMITED | 06. Dez. 1990 | 06. Dez. 1990 |
CROMWELL LAND SECURITY LIMITED | 19. Nov. 1990 | 19. Nov. 1990 |
CITYLAND PROPERTIES AND INVESTMENTS LIMITED | 15. Feb. 1989 | 15. Feb. 1989 |
CITYLAND HOTELS LIMITED | 22. Sept. 1970 | 22. Sept. 1970 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CROMWELL LAND LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2014 |
Welche sind die letzten Einreichungen für CROMWELL LAND LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 11. Okt. 2016
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 23. Feb. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Erfüllung der Belastung 54 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 53 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 52 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Iain Douglas Bond als Geschäftsführer am 30. Nov. 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 20 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 12. Jan. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 20 Seiten | AA | ||||||||||
Verschiedenes Section 519 | 1 Seiten | MISC | ||||||||||
Verschiedenes Aud res sec 519 | 1 Seiten | MISC | ||||||||||
Verschiedenes Sect 519 | 2 Seiten | MISC | ||||||||||
Rücktritt des Auditors | 2 Seiten | AUD | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 10. Jan. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 21 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 08. Jan. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 20 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 12. Jan. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Sharon Kerridge als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von CROMWELL LAND LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WYLLIE, Alison | Sekretär | Charles Ii Street SW1Y 4QU London 12 United Kingdom | British | 107811220001 | ||||||
HUXTABLE, Christopher John | Geschäftsführer | Charles Ii Street SW1Y 4QU London 12 United Kingdom | England | British | Investment Banker | 156351910001 | ||||
THORP, Timothy Geoffrey | Geschäftsführer | Charles Ii Street SW1Y 4QU London 12 | England | British | Chartered Accountant | 66923730003 | ||||
BANDEL, Martin Howard | Sekretär | Gable End 29 Christchurch Crescent WD7 8AQ Radlett Hertfordshire | British | Company Secretary | 37249220002 | |||||
COLE, Jennifer | Sekretär | Flat 2 The Earl Of Devon 213 Devons Road Bow Common E3 3QX London | British | 74489480002 | ||||||
FORSTER, Helen | Sekretär | Flat 4 5 Corkran Road KT6 6PL Surbiton Surrey | British | 106129360001 | ||||||
JENKINSON, Louisa Jane | Sekretär | 12 Amberley Close Send GU23 7BX Woking Surrey | British | 106060330002 | ||||||
LYON, Karen | Sekretär | Belvedere Court 372-374 Upper Richmond Road SW15 6HY London 33 United Kingdom | Other | 140536930001 | ||||||
MILLER, Philip | Sekretär | 87 Sutton Court Fauconberg Road W4 3JF London | British | 121053850001 | ||||||
POOLE, Rebecca Louise | Sekretär | 69b Replingham Road Southfields SW18 5LU Wimbledon | British | 92013940001 | ||||||
STUART-SMITH, Gordon | Sekretär | Summerview Chequers Park Wye TN25 5BA Ashford Kent | British | 5463920001 | ||||||
PATERNOSTER SECRETARIES LIMITED | Sekretär | 55 Basinghall Street EC2V 5HD London | 76827740001 | |||||||
ALLPORT, Howard Coplestone | Geschäftsführer | 20 Fernshaw Road SW10 0TE London | British | Co Director | 3356770001 | |||||
BANDEL, Martin Howard | Geschäftsführer | Flat 6 1/2 Alma Square St Johns Wood NW8 9QD London | British | Chartered Accountant | 37249220003 | |||||
BOND, Iain Douglas | Geschäftsführer | Charles Ii Street SW1Y 4QU London 12 | United Kingdom | British | Property Director | 68687180001 | ||||
DESAI, Arunkumar Bhilalbhai | Geschäftsführer | Jubilee Place SW3 3TQ London 2 England | United Kingdom | British | Group Accountant | 84225840001 | ||||
DESAI, Arunkumar Bhilalbhai | Geschäftsführer | 12 Cherry Close SM5 2BW Carshalton Surrey | United Kingdom | British | Group Accountant | 84225840001 | ||||
EDWARDS, Dylan Crocker | Geschäftsführer | 22 Greenway Gardens UB6 9TT Greenford Middlesex | British | Surveyor | 5965630001 | |||||
GLEDHILL, Sarah Louise | Geschäftsführer | Charles Ii Street SW1Y 4QU London 12 United Kingdom | United Kingdom | British | Accountant | 131963100002 | ||||
GLOVER, Edward Douglas | Geschäftsführer | Charles Ii Street SW1Y 4QU London 12 United Kingdom | United Kingdom | British | Merchant Banker | 121380002 | ||||
HAYES, Laurence Edwin | Geschäftsführer | Jubilee Place SW3 3TQ London 2 England | United Kingdom | British | Accountant | 192784770001 | ||||
HOLBROOK, Carolyn | Geschäftsführer | 5 Croftside CO8 5LL Bures St Mary Suffolk | United Kingdom | British | Property Management | 165098780001 | ||||
KERRIDGE, Sharon Diana Mandy | Geschäftsführer | Charles Ii Street SW1Y 4QU London 12 United Kingdom | United Kingdom | British | Banker | 128267610003 | ||||
MOFFAT, Andrew David John | Geschäftsführer | Jubilee Place SW3 3TQ London 2 England | England | British | Merchant Banker | 34399870003 | ||||
RAWLINS, Richard Denis | Geschäftsführer | 183 Ramsden Road SW12 8RG London | United Kingdom | British | Surveyor | 56889050001 | ||||
STUART-SMITH, Gordon | Geschäftsführer | Summerview Chequers Park Wye TN25 5BA Ashford Kent | British | Accountant | 5463920001 | |||||
SZPIRO, Toby Nicholas Maximilian | Geschäftsführer | Flat 3 18 Camden Hill Gardens W8 7AY London | United Kingdom | British | Company Director | 76573230001 | ||||
THORP, Timothy Geoffrey | Geschäftsführer | 3 St George's Road TN13 3ND Sevenoaks Kent | England | British | Chartered Accountant | 66923730003 |
Hat CROMWELL LAND LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Charge over bank accounts | Erstellt am 21. Juni 2011 Geliefert am 30. Juni 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed charge the charged balance and charged accounts see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 10. Juni 2011 Geliefert am 22. Juni 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Raglan court empire way wembley t/n P137078, fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 10. Juni 2011 Geliefert am 22. Juni 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Flat 8 raglan court empire way wembley t/n NGL782443, flat 19 raglan court empire way wembley t/n NGL782442, flat 20 raglan court empire way wembley t/n NGL782441, for details of further properties charged, please refer to form MG01, together with all buildings, fixtures (including trade fixtures), fixed plant & machinery thereon, the goodwill of any business carried on at the property, the benefit of all licences & registration required in the running of such a business (see image for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 16. Juli 1996 Geliefert am 31. Juli 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 06. März 1996 Geliefert am 12. März 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben By way of legal mortgage f/h land situated at 3, 5 and 7 whitegate road and 2, 4 and 6 warrior square, southend on sea t/no. EX171106 and the goodwill of any business carried on at the property. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 30. Aug. 1994 Geliefert am 31. Aug. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 49 atlanta street, fulham, together with the benefit of all rights licences and covenants affecting the property, fixed charge over all plant and other machinery,fixtures and fittings ,furniture and equipment ,implements and utensils etc... the present and future goodwill of any business carried on at or about the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge. | Erstellt am 30. Aug. 1994 Geliefert am 31. Aug. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 6 to 18 tudor court , russell hill. Purley,croydon. London together with all covenants and rightrs affecting or concerning the property , the plant and machinery and fixtures and fittings furniture, equipment implements and utensils, of the company now and in the future at the property ,the present and future goodwill of any business carried on at or about the property. Please see doc for further details,. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge. | Erstellt am 30. Aug. 1994 Geliefert am 31. Aug. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 1 to 66 kensington mansions, trebovir road, kensington and chelsea, together with the benefit of all covenants and rights affecting or concerning the property , all plant and other machinery fixtures and fittings ,furniture equipment ,implements and utensils. The present and future goodwill of any business carried on at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 30. Aug. 1994 Geliefert am 31. Aug. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 2 to 10A purley parade ,(excluding no .3 ) high street, purley. Fixed charge over all covenants and rights affecting or concerning the property, the plant ,machinery , and fixtures and fittings ,furniture, equipment ,implements utensils,of the company now and in the future at the property. The present and future goodwill of the business carried on at the property . | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Composite debenture | Erstellt am 27. Sept. 1990 Geliefert am 05. Okt. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of a guarantee of evendate. | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 25. Nov. 1988 Geliefert am 30. Nov. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 141, finborough road, london SW10. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 05. Aug. 1988 Geliefert am 16. Aug. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 91, bere hill crescent, andover, hampshire. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 15. Juli 1988 Geliefert am 22. Juli 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben First and fixed legal charge over property k/as 67 penge road london SE 25.. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 25. Apr. 1988 Geliefert am 03. Mai 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed charge 103A westbourne grove london. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 05. Feb. 1988 Geliefert am 23. Feb. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H courtfield rd london SW7 t/no ngl 599654 fixed and. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 26. Jan. 1988 Geliefert am 02. Feb. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed charge over:- 3 north street, horsham west sussex and,. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 27. Aug. 1987 Geliefert am 04. Sept. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H property k/a 30, downland place, adastral road, canford heath, poole, dorset title no: dt 105678 fixed and. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge registered pursuant to a statutory declaration dated 11/9/87 | Erstellt am 18. Aug. 1987 Geliefert am 03. Sept. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H-69 denmark hill, camberwell, london SE5 T.no:- sgl 279325. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 07. Mai 1987 Geliefert am 09. Mai 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 42, finborough rd; london SW10. Floating charge. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 06. Apr. 1987 Geliefert am 08. Apr. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 106 church rd, richmond surrey floating charge. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 02. Jan. 1987 Geliefert am 07. Jan. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a 37, courtfield road, london SW7 title no ngl 455035 inc fixtures fittings plant, machinery, implements,utensils furniture & equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 04. Aug. 1986 Geliefert am 06. Aug. 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Flat e, angel house, pentonville road, london N1. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 25. Juni 1986 Geliefert am 28. Juni 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H property 338 south norwood hill, london SE25 and floating charge. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 06. Jan. 1986 Geliefert am 10. Jan. 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Flat 4, 15 whitworth road, london SE25. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 06. Jan. 1986 Geliefert am 10. Jan. 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 41 ronelean road, folworth r b of kingston upon thames. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0