THE COLONY CLUB LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | THE COLONY CLUB LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 00990697 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von THE COLONY CLUB LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich THE COLONY CLUB LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | One Snowhill Snow Hill Queensway B4 6GH Birmingham |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von THE COLONY CLUB LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| INTERNATIONAL SPORTING CLUB (LONDON) LIMITED | 01. Okt. 1970 | 01. Okt. 1970 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von THE COLONY CLUB LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2016 |
Welche sind die letzten Einreichungen für THE COLONY CLUB LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 6 Seiten | LIQ13 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Genting Club Star City Watson Road Birmingham B7 5SA zum One Snowhill Snow Hill Queensway Birmingham B4 6GH am 09. Okt. 2018 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 5 Seiten | LIQ01 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 23. Sept. 2018 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 23. Sept. 2017 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 1 Seiten | AA | ||||||||||
Notification of Capital Casinos Group Limited as a person with significant control on 07. Aug. 2017 | 2 Seiten | PSC02 | ||||||||||
Withdrawal of a person with significant control statement on 07. Aug. 2017 | 2 Seiten | PSC09 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 23. Sept. 2016 mit Aktualisierungen | 6 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 1 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr James Axelby als Direktor am 13. Juli 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Peter Malcolm Brooks am 24. Mai 2016 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Ernennung von Paul Stewart Willcock als Direktor am 23. März 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Richard Robert Salmond als Geschäftsführer am 23. Dez. 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Erklärung der Unternehmensgegenstände | 2 Seiten | CC04 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 27 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 21. Sept. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 1 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Elizabeth Jill Tarn am 23. Okt. 2014 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 21. Sept. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 1 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 21. Sept. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von THE COLONY CLUB LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARN, Elizabeth Jill | Sekretär | Snow Hill Queensway B4 6GH Birmingham One Snowhill | British | 131467900001 | ||||||
| AXELBY, James | Geschäftsführer | Star City, Watson Road B7 5SA Birmingham Genting Club England | United Kingdom | British | 210535950001 | |||||
| BROOKS, Peter Malcolm | Geschäftsführer | Snow Hill Queensway B4 6GH Birmingham One Snowhill | Monaco | British | 84067460002 | |||||
| WILLCOCK, Paul Stewart | Geschäftsführer | Snow Hill Queensway B4 6GH Birmingham One Snowhill | England | British | 206400610001 | |||||
| BARKER, Nicholas Charles Lawrence | Sekretär | Inshala Hilfield Lane Aldenham WD2 8AJ Watford Hertfordshire | British | 10939990001 | ||||||
| CHANDLER, Andrew Philip | Sekretär | 30 Parkhurst Road DA5 1AR Bexley Kent | British | 53832740002 | ||||||
| DIBBLE, Keith George | Sekretär | 8 Newcastle Avenue IG6 3EE Ilford Essex | British | 82410610001 | ||||||
| GOULBOURNE, Sarah-Jane | Sekretär | 36 Wynnstay Lane Marford LL12 8LG Wrexham Clwyd | British | 64347190002 | ||||||
| MOORE, Gillian | Sekretär | 13 Basil Way South Shields NE34 8UA Tyne And Waer | British | 113027650001 | ||||||
| PEREIRA, Desmond Cajetan | Sekretär | Manor Villas 161g Station Road Finchley Central N3 2SP London | British | 108086000001 | ||||||
| BARKER, Nicholas Charles Lawrence | Geschäftsführer | Inshala Hilfield Lane Aldenham WD2 8AJ Watford Hertfordshire | British | 10939990001 | ||||||
| BRACKENBURY, Frederick Edwin John Gedge | Geschäftsführer | 8 Moore Street SW3 2QN London | United Kingdom | British | 53682420001 | |||||
| CHANDLER, Andrew Philip | Geschäftsführer | 30 Parkhurst Road DA5 1AR Bexley Kent | United Kingdom | British | 53832740002 | |||||
| CHILD, Colin Charles | Geschäftsführer | Waterside House Headbourne Worthy SO23 7JR Winchester Hants | England | British | 125146440001 | |||||
| DUNKLEY, John David | Geschäftsführer | 29 Burnett Park CM19 4SD Harlow Essex | British | 24899280001 | ||||||
| GRAY, David William | Geschäftsführer | 15 Huson Close NW3 3JW London | England | British | 78691870001 | |||||
| HEARN, Alan John | Geschäftsführer | Tylecroft 29 Woodchester Park Knotty Green HP9 2TU Beaconsfield Buckinghamshire | British | 13648200003 | ||||||
| HOSKINS, Michael | Geschäftsführer | 83 Nelmes Crescent RM11 2PR Hornchurch Essex | England | British | 55577460001 | |||||
| LOWRY, Thomas Allen | Geschäftsführer | Homewood Smithy Lane Mouldsworth CH3 8AR Chester | England | British | 34909450002 | |||||
| MCNALLY, Peter | Geschäftsführer | Silver Lining Brock Way GU25 4SD Virginia Water Surrey | England | British | 24036040001 | |||||
| NESBITT, Garry | Geschäftsführer | 5 Frognal Way Hampstead NW3 6XE London | British | 10940020001 | ||||||
| PERRIN, Nicholas John | Geschäftsführer | Henley Road B95 5NN Ullenhall Treboro House Warwickshire | England | British | 174660810001 | |||||
| QUINLAN, Timothy Edward | Geschäftsführer | 121 Thorpe Bay Gardens Thorpe Bay SS1 3NW Southend On Sea Essex | England | British | 49553030001 | |||||
| RAHA, Maryse | Geschäftsführer | 10 Copse Wood Way HA6 2UE Northwood Middlesex | French | 24036050001 | ||||||
| RIDDY, Alan Michael | Geschäftsführer | The Willows Well Lane, Mollington CH1 6LD Chester Cheshire | England | British | 62615300004 | |||||
| RIDDY, Alan Michael | Geschäftsführer | The Willows Well Lane, Mollington CH1 6LD Chester Cheshire | England | British | 62615300004 | |||||
| SALMOND, Richard Robert | Geschäftsführer | Star City Watson Road B7 5SA Birmingham Circus Casino West Midlands England | England | British | 164973490001 | |||||
| STEINBERG, Leonard, Lord | Geschäftsführer | 20 Carrwood Halebarns WA15 0EE Altrincham Cheshire | British | 35686260002 | ||||||
| WIPER, Robert | Geschäftsführer | The Hollow Moggie Lane SK10 4NY Adlington Cheshire | United Kingdom | British | 73690420002 | |||||
| WIPER, Robert | Geschäftsführer | Pelham Cottage Brookledge Lane SK10 4JU Adlington Cheshire | British | 73690420001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei THE COLONY CLUB LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital Casinos Group Limited | 07. Aug. 2017 | Watson Road B7 5SA Birmingham Genting Club Star City England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Wie lauten die letzten Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss für THE COLONY CLUB LIMITED?
| Benachrichtigt am | Aufgehört am | Erklärung |
|---|---|---|
| 23. Sept. 2016 | 07. Aug. 2017 | Das Unternehmen hat die erforderlichen Schritte zur Ermittlung, ob eine Person eine registrierungspflichtige Person oder eine registrierungspflichtige relevante juristische Person in Bezug auf das Unternehmen ist, noch nicht abgeschlossen. |
Hat THE COLONY CLUB LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Supplemental guarantee and debenture | Erstellt am 24. Dez. 1997 Geliefert am 08. Jan. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future obligations and liabilities of capital corporation (holdings) limited and/or crockfords club limited and/or the company to midland bank PLC under the midland overdraft facility (as defined) and of cromwell sporting enterprises limited to national westminster bank PLC under the natwest overdraft facility (as defined) and of each obligor (as defined) due or to become due from the company to the chargee under the security documents (as defined) and of each obligor due or to become due to the chargee and/or the banks (as defined) or any of them under any other financing documents (as defined) | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental debenture | Erstellt am 18. Dez. 1995 Geliefert am 04. Jan. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present or future obligations and liabilities of the company to the chargees pursuant to the terms of the 364-day facility the security and financing documents (as defined) and/or this supplemental debenture | |
Kurze Angaben All the property (if any ) specified in the first schedule to the original guarantee and debenture together with all buildings and fixtures. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee and debenture | Erstellt am 01. Aug. 1995 Geliefert am 15. Aug. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from crockfords (holdings) limited to the chargee and/or the revolving credit banks (or any of them) under the facility agreement dated 11 october 1994 (as defined) and all monies due or to become due from crockfords (holdings) limited and/or crockfords club limited to the overdraft bank under the overdraft facility agreement dated 11 october 1994 (as defined) and all monies due or to become due from each obligor (as defined) to the chargee and/or the banks (or any of them) under the security document(s) or any other financing document(s) (as defined) to which it is a party | |
Kurze Angaben An underlease dated 1994 and relating to casino premises at 18-19 old park land and 24 hertford street london W1 t/n NGL726210, fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 01. März 1994 Geliefert am 11. März 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 30. März 1992 Geliefert am 14. Apr. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under clause 2.1 of the composite guarantee and debenture. | |
Kurze Angaben (See form 395 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee and debenture | Erstellt am 27. März 1992 Geliefert am 13. Apr. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee. | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee and debenture | Erstellt am 11. Nov. 1991 Geliefert am 28. Nov. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all of the other companies named therein to the chargee under the facility agreement dated 11TH november 1991 | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital building fixtures fixed plant and machinery see form 395 for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 01. Juli 1991 Geliefert am 18. Juli 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from thebrent walker group PLC and certain of its subsidiaries to the chargee under the terms of the facility agreement dated 1ST july 1991 | |
Kurze Angaben See doc M150 for full details. A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee & debenture | Erstellt am 28. März 1991 Geliefert am 17. Apr. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the brent walker group PLC and/or any other company named therein under the terms of this deed to the chargee. | |
Kurze Angaben (See doc M140 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee & debenture | Erstellt am 28. März 1991 Geliefert am 16. Apr. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from brent walker limited under the terms of the facility agreement dated 19/2/91 and this deed to the chargee. | |
Kurze Angaben (See doc M171 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee & debenture | Erstellt am 28. März 1991 Geliefert am 16. Apr. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the brent walker group PLC under the terms of the stand by facility agreement dated 15/11/90 and this deed to the chargee. | |
Kurze Angaben (See doc M148 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee & debenture | Erstellt am 28. März 1991 Geliefert am 16. Apr. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the brent walker group PLC and/or any other company named therein under the terms of the facility agreement dated 28/3/91 and this deed th the chargee. | |
Kurze Angaben (See doc M125 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat THE COLONY CLUB LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0