NALIM LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | NALIM LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 00996170 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von NALIM LIMITED?
- Glücksspiel- und Wettbetriebe (92000) / Kunst, Unterhaltung und Erholung
Wo befindet sich NALIM LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 1 More London Place SE1 2AF London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von NALIM LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 01. Jan. 2019 |
Welche sind die letzten Einreichungen für NALIM LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 11 Seiten | LIQ13 | ||||||||||
Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse 1 Bedford Avenue London WC1B 3AU verlegt | 2 Seiten | AD03 | ||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde auf 1 Bedford Avenue London WC1B 3AU geändert | 2 Seiten | AD02 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 1 Bedford Avenue London WC1B 3AU United Kingdom zum 1 More London Place London SE1 2AF am 22. Dez. 2020 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 5 Seiten | LIQ01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Simon James Callander als Direktor am 25. März 2020 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Simon James Callander als Sekretär am 25. März 2020 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Balbir Kelly-Bisla als Geschäftsführer am 25. März 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Balbir Kelly-Bisla als Sekretär am 25. März 2020 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 14. Jan. 2020 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 01. Jan. 2019 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr Michael James Ford als Direktor am 24. Mai 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Claire Margaret Pape als Geschäftsführer am 24. Mai 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Greenside House 50 Station Road Wood Green London N22 7TP zum 1 Bedford Avenue London WC1B 3AU am 01. März 2019 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 14. Jan. 2019 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Ernennung von Balbir Kelly-Bisla als Direktor am 19. Dez. 2018 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Balbir Kelly-Bisla als Sekretär am 19. Dez. 2018 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Luke Amos Thomas als Geschäftsführer am 19. Dez. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Luke Amos Thomas als Sekretär am 19. Dez. 2018 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 26. Dez. 2017 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Luke Amos Thomas als Sekretär am 17. Sept. 2018 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Thomas Stamper Fuller als Sekretär am 17. Sept. 2018 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von NALIM LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALLANDER, Simon James | Sekretär | More London Place SE1 2AF London 1 | 268457950001 | |||||||
| CALLANDER, Simon James | Geschäftsführer | More London Place SE1 2AF London 1 | United Kingdom | British | 268458460001 | |||||
| FORD, Michael James | Geschäftsführer | More London Place SE1 2AF London 1 | United Kingdom | British | 244782600001 | |||||
| ANDERSON, Sarah | Sekretär | Greenside House 50 Station Road, Wood Green N22 7TP London | British | 100326820003 | ||||||
| BLYTHE-TINKER, Nigel Edwin | Sekretär | Top Farm High Street PE19 6RX Toseland Cambs | British | 63851130001 | ||||||
| FULLER, Thomas Stamper | Sekretär | 50 Station Road N22 7TP Wood Green Greenside House London United Kingdom | British | 99624870001 | ||||||
| HOGAN, Kevin Matthew Joseph Christopher | Sekretär | Willow House 121 Upper Hoyland Road S74 9NL Hoyland South Yorkshire | British | 4502520001 | ||||||
| KELLY-BISLA, Balbir | Sekretär | Bedford Avenue WC1B 3AU London 1 United Kingdom | 253658590001 | |||||||
| MACQUEEN, Andrea Louise | Sekretär | 10 Eglington Road Chingford E4 7AN London | British | 98483080001 | ||||||
| MOTT, Matthew John Spencer | Sekretär | 25 Princess Court 105 Hornsey Lane Highgate N6 5XD London | British | 19710010002 | ||||||
| READ, Dennis | Sekretär | Greenside House 50 Station Road Wood Green N22 7TP London | British | 125938390001 | ||||||
| THOMAS, Luke Amos | Sekretär | 50 Station Road N22 7TP Wood Green Greenside House London United Kingdom | 250776010001 | |||||||
| BROWN, John Michael | Geschäftsführer | Milford Court Milford Road South Milford LS25 5AD Leeds | British | 889800001 | ||||||
| COOPER, Neil | Geschäftsführer | 50 Station Road N22 7TP Wood Green Greenside House London United Kingdom | United Kingdom | British | 151902940001 | |||||
| COWBURN, Leonard Ponsonby | Geschäftsführer | Tranby Lane Swanland HU14 3NB East Yorkshire Foxhollows | British | 140373600001 | ||||||
| DUNCAN, Fraser Scott | Geschäftsführer | 25 Kippington Road TN13 2LJ Sevenoaks Kent | England | British | 57508670001 | |||||
| HART, Raymond John | Geschäftsführer | Hazel Court The Drive SM2 7DH Belmont Surrey | British | 63042500001 | ||||||
| HAYGARTH, William Leslie | Geschäftsführer | 9 Hillside Burghfield Common RG7 3BQ Reading Berkshire | British | 11592110002 | ||||||
| KELLY-BISLA, Balbir | Geschäftsführer | Bedford Avenue WC1B 3AU London 1 United Kingdom | United Kingdom | British | 253475470001 | |||||
| LAMBERT, Robert | Geschäftsführer | Red Roof Tithe Barn Lane, Bardsey LS17 9DX Wetherby | United Kingdom | British | 153968320001 | |||||
| LANE, Simon Paul | Geschäftsführer | Greenside House 50 Station Road, Wood Green N22 7TP London | British | 117893540001 | ||||||
| MCGUIGAN, Liam John | Geschäftsführer | 9 Park Drive Thorntonhall G74 5AS Glasgow | Scotland | British | 62685050001 | |||||
| OLIVE, Stephen Gerard | Geschäftsführer | 4 High Park Road Kew TW9 4BH Richmond Surrey | British | 38206770002 | ||||||
| PAPE, Claire Margaret | Geschäftsführer | Bedford Avenue WC1B 3AU London 1 United Kingdom | United Kingdom | British | 215706010001 | |||||
| SINGER, Thomas Daniel | Geschäftsführer | 27 Observatory Road SW14 7QB East Sheen London | British | 63386730002 | ||||||
| SPEARING, Ian John | Geschäftsführer | Greenside House 50 Station Road, Wood Green N22 7TP London | British | 34180750003 | ||||||
| STEELE, Anthony David | Geschäftsführer | Greenside House 50 Station Road N22 7TP Wood Green | United Kingdom | British | 193930220001 | |||||
| THOMAS, Luke Amos | Geschäftsführer | 50 Station Road N22 7TP Wood Green Greenside House London United Kingdom | United Kingdom | British | 181597010001 | |||||
| WASANI, Shailen | Geschäftsführer | Greenside House 50 Station Road, Wood Green N22 7TP London | British | 102956140003 |
Wie lauten die letzten Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss für NALIM LIMITED?
| Benachrichtigt am | Aufgehört am | Erklärung |
|---|---|---|
| 14. Jan. 2017 | Das Unternehmen weiß oder hat Grund zu der Annahme, dass es keine registrierungspflichtige Person oder registrierungspflichtige relevante juristische Person in Bezug auf das Unternehmen gibt. |
Hat NALIM LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 01. März 1994 Geliefert am 10. März 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All the company's undertaking property assets and revenues present and future by way of floating charge. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 01. März 1994 Geliefert am 10. März 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All the company's undertaking property assets and revenues present and future by way of floating charge. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 01. März 1994 Geliefert am 10. März 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All the company's undertaking property assets and revenues present and future by way of floating charge. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 01. März 1994 Geliefert am 10. März 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 01. März 1994 Geliefert am 10. März 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 01. März 1994 Geliefert am 10. März 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All the company's undertaking property assets and revenues present and future by way of floating charge. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat NALIM LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0