BULLOUGH HEATING LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameBULLOUGH HEATING LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 00996720
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von BULLOUGH HEATING LIMITED?

    • (3663) /

    Wo befindet sich BULLOUGH HEATING LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Baker Tilley
    5 Old Bailey
    EC4M 7AF London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von BULLOUGH HEATING LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    BOULTER BOILERS LIMITED10. Dez. 197010. Dez. 1970

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BULLOUGH HEATING LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Apr. 2004

    Welche sind die letzten Einreichungen für BULLOUGH HEATING LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 30. Nov. 2009

    6 Seiten4.68

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    7 Seiten4.72

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 13. Nov. 2009

    10 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 13. Mai 2009

    6 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 13. Nov. 2008

    6 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 13. Nov. 2008

    6 Seiten4.68

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Außerordentlicher Beschluss zur Vergleichsverfahren

    LRESEX

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Vermögensübersicht

    5 Seiten4.20

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    5 Seiten363a

    legacy

    5 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288c

    legacy

    1 Seiten288c

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    1 Seiten244

    legacy

    6 Seiten363s

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Apr. 2004

    17 SeitenAA

    legacy

    6 Seiten363s

    Rücktritt des Auditors

    1 SeitenAUD

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    7 Seiten395

    Wer sind die Geschäftsführer von BULLOUGH HEATING LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    CYBRUS LIMITED
    Bayhall Mills
    Birkby Huddersfield
    HD1 5EP West Yorkshire
    Sekretär
    Bayhall Mills
    Birkby Huddersfield
    HD1 5EP West Yorkshire
    99212380003
    BROWALLIA CORPORATE DIRECTOR LIMITED
    Bayhall Mills
    Birkby
    HD1 5EP Huddersfield
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Bayhall Mills
    Birkby
    HD1 5EP Huddersfield
    West Yorkshire
    96468430003
    HAYES, Christopher Patrick Dennis
    2 Central Close
    Hethersett
    NR9 3ER Norwich
    Norfolk
    Sekretär
    2 Central Close
    Hethersett
    NR9 3ER Norwich
    Norfolk
    British29377090001
    MONTPELLIER GROUP NOMINEES LIMITED
    39 Cornhill
    EC3V 3NU London
    Sekretär
    39 Cornhill
    EC3V 3NU London
    41291250009
    BALMER, Henry Richard
    Devon House 66 Northumberland Road
    CV32 6HB Leamington Spa
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    Devon House 66 Northumberland Road
    CV32 6HB Leamington Spa
    Warwickshire
    British1637840001
    BENJAMIN, John
    Virginia Cottage
    102 Upper Harlestone
    NN7 4EL Northampton
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    Virginia Cottage
    102 Upper Harlestone
    NN7 4EL Northampton
    Northamptonshire
    British75927710002
    BOND, Gordon
    Omega
    Durford Wood
    GU31 5AN Petersfield
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Omega
    Durford Wood
    GU31 5AN Petersfield
    Hampshire
    British37448240001
    BONSEY, Colin Peter
    114 Village Way
    TW15 2JU Ashford
    Middlesex
    Geschäftsführer
    114 Village Way
    TW15 2JU Ashford
    Middlesex
    British3301850001
    GALES, Richard David Russell
    Unicorn House Meadow Valley
    Great Bricett
    IP7 7DX Ipswich
    Suffolk
    Geschäftsführer
    Unicorn House Meadow Valley
    Great Bricett
    IP7 7DX Ipswich
    Suffolk
    British65044000001
    HAYES, Christopher Patrick Dennis
    2 Central Close
    Hethersett
    NR9 3ER Norwich
    Norfolk
    Geschäftsführer
    2 Central Close
    Hethersett
    NR9 3ER Norwich
    Norfolk
    EnglandBritish29377090001
    HOUNSFIELD, Andrew Michael
    Gordon House
    Ecsing Road
    NR9 Lyng
    Norfolk
    Geschäftsführer
    Gordon House
    Ecsing Road
    NR9 Lyng
    Norfolk
    British29377110001
    HOUSE, Nigel Roy
    Apple Cottage Long Stratton Road
    Forncett St Peter
    NR16 1HT Norwich
    Norfolk
    Geschäftsführer
    Apple Cottage Long Stratton Road
    Forncett St Peter
    NR16 1HT Norwich
    Norfolk
    British98984520001
    KNOTT, Michael Graham
    Two Hoots Old Newton Road
    Gipping
    IP14 4PR Stowmarket
    Suffolk
    Geschäftsführer
    Two Hoots Old Newton Road
    Gipping
    IP14 4PR Stowmarket
    Suffolk
    British113480810001
    MANN, Paul Richard
    29 Berkeley Close
    Albany Gardens
    IP4 2TS Ipswich
    Suffolk
    Geschäftsführer
    29 Berkeley Close
    Albany Gardens
    IP4 2TS Ipswich
    Suffolk
    United KingdomBritish38087920002
    MARSHALL, Howard Cleveley
    Hillfields House
    Shatterford
    DY12 1SY Bewdley
    Worcestershire
    Geschäftsführer
    Hillfields House
    Shatterford
    DY12 1SY Bewdley
    Worcestershire
    EnglandBritish11620350003
    MCGHEE, Thomas Allan
    Stuart Court
    Queen Mary Close
    GU51 4QR Fleet
    Hants
    Geschäftsführer
    Stuart Court
    Queen Mary Close
    GU51 4QR Fleet
    Hants
    British81489550001
    PARK, Michael Christopher
    5 Factory Lane East
    CO9 2JH Halstead
    Essex
    Geschäftsführer
    5 Factory Lane East
    CO9 2JH Halstead
    Essex
    EnglandIrish57983810001
    STEVENS, Timothy Mark
    14 Stonalls
    Woolpit
    IP30 9TX Bury St Edmunds
    Suffolk
    Geschäftsführer
    14 Stonalls
    Woolpit
    IP30 9TX Bury St Edmunds
    Suffolk
    British32830170002
    SZADURSKI, Marek Leopold
    2 Old Hartshay Hill
    Ripley
    DE5 3HU Derby
    Derbyshire
    Geschäftsführer
    2 Old Hartshay Hill
    Ripley
    DE5 3HU Derby
    Derbyshire
    British42067720001
    THOMPSON, Keith
    3 Hailes Wood
    Elsenham
    CM22 6DQ Bishops Stortford
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    3 Hailes Wood
    Elsenham
    CM22 6DQ Bishops Stortford
    Hertfordshire
    British48041730001
    YATES, Christopher John
    20 Brewhouse Lane
    SG14 1TZ Hertford
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    20 Brewhouse Lane
    SG14 1TZ Hertford
    Hertfordshire
    EnglandBritish56704980002

    Hat BULLOUGH HEATING LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Charge of deposit
    Erstellt am 08. Dez. 2003
    Geliefert am 16. Dez. 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All deposits now and in the future credited to account designation NO64037142 with the bank and any deposit or account of any other currency description or designation which derives in whole or in part from such deposit or account.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. Dez. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 04. Dez. 2003
    Geliefert am 17. Dez. 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 17. Dez. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 11. März 2002
    Geliefert am 20. März 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 20. März 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Dez. 2002Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)

    Hat BULLOUGH HEATING LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    14. Mai 2007Beginn der Liquidation
    10. März 2010Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Geoffrey Lambert Carton-Kelly
    Baker Tilly 1st Floor 5 Old Bailey
    EC4M 7AF London
    Praktiker
    Baker Tilly 1st Floor 5 Old Bailey
    EC4M 7AF London
    Michael David Rollings
    Baker Tilly
    5 Old Bailey
    London
    Ec4m 7af
    Praktiker
    Baker Tilly
    5 Old Bailey
    London
    Ec4m 7af

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0