TIDEWATER MARINE NORTH SEA LIMITED

TIDEWATER MARINE NORTH SEA LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameTIDEWATER MARINE NORTH SEA LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01000605
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von TIDEWATER MARINE NORTH SEA LIMITED?

    • Erbringung von Dienstleistungen für die Erdöl- und Erdgasgewinnung (09100) / Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden

    Wo befindet sich TIDEWATER MARINE NORTH SEA LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    4 Hardman Square
    Springfields
    M3 3EB Manchester
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von TIDEWATER MARINE NORTH SEA LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    O.I.L. LIMITED29. Nov. 198329. Nov. 1983
    OCEAN INCHCAPE LIMITED22. Jan. 197122. Jan. 1971

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von TIDEWATER MARINE NORTH SEA LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2011

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für TIDEWATER MARINE NORTH SEA LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für TIDEWATER MARINE NORTH SEA LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    9 Seiten4.72

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 14. Nov. 2015

    11 Seiten4.68

    Insolvenzgerichtsbeschluss

    Court order INSOLVENCY:court order re. Replacement of liquidator
    12 SeitenLIQ MISC OC

    Hinweis auf die Einstellung der Tätigkeit als freiwilliger Liquidator

    1 Seiten4.40

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 15. Nov. 2013

    12 Seiten2.24B

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Mitteilung über den Übergang vom Verwaltungsfall zur freiwilligen Liquidation der Gläubiger

    1 Seiten2.34B

    Ergebnis der Gläubigerversammlung

    1 Seiten2.23B

    Vermögensübersicht mit Formular 2.14B

    6 Seiten2.16B

    Vorschlag des Verwalters

    25 Seiten2.17B

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * C/O Ince & Co International House 1 St Katherines Way London E1W 1UN* am 24. Juli 2013

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines Verwalters

    1 Seiten2.12B

    Jahresrückblick erstellt bis 01. Juni 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital08. Juli 2013

    Kapitalaufstellung am 08. Juli 2013

    • Kapital: GBP 5,000,000
    SH01

    Änderung der Details des Direktors für Richard Hart am 01. Mai 2013

    2 SeitenCH01

    Beendigung der Bestellung von Jeffrey Platt als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Quinn Fanning als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Jeffrey Michael Platt als Direktor

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Dean Taylor als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 01. Juni 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01

    Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde eingestellt

    1 SeitenDISS40

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2011

    24 SeitenAA

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Jahresrückblick erstellt bis 01. Juni 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    16 SeitenAR01

    Beendigung der Bestellung von Stephen Dick als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Wer sind die Geschäftsführer von TIDEWATER MARINE NORTH SEA LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    CAMBRE, Clay
    Versailles Boulevard
    FOREIGN New Orleans
    14
    La, 70125
    Usa
    Sekretär
    Versailles Boulevard
    FOREIGN New Orleans
    14
    La, 70125
    Usa
    UsAttorney121213890001
    TURCAN CONNELL COMPANY SECRETARIES LIMITED
    1 Earl Grey Street
    EH3 9EE Edinburgh
    Princes Exchange
    Sekretär
    1 Earl Grey Street
    EH3 9EE Edinburgh
    Princes Exchange
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    RegistrierungsnummerSC396460
    159071750001
    HART, Richard
    Burnside Road
    Peterculter
    AB14 0LP Aberdeen
    Lower Kinnerty Mill
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Burnside Road
    Peterculter
    AB14 0LP Aberdeen
    Lower Kinnerty Mill
    United Kingdom
    ScotlandAmerican (Usa)Financial Controller100865380001
    DONNELLY, James Harkness
    6 The Steading
    Upper Anguston
    AB14 0PY Aberdeen
    Sekretär
    6 The Steading
    Upper Anguston
    AB14 0PY Aberdeen
    BritishShip Manager77730750002
    GOLDBLATT, Michael Lee
    4709 Folse Drive
    Metairie
    Louisiana
    70006
    Usa
    Sekretär
    4709 Folse Drive
    Metairie
    Louisiana
    70006
    Usa
    American53094660001
    HARKNESS, James Alan
    63 Beaconsfield Place
    AB15 4AD Aberdeen
    Sekretär
    63 Beaconsfield Place
    AB15 4AD Aberdeen
    UsaFinance78283570001
    HART, Richard
    1 Crombie Circle
    AB14 0XU Peterculter
    Aberdeenshire
    Sekretär
    1 Crombie Circle
    AB14 0XU Peterculter
    Aberdeenshire
    American56160400001
    LABORDE, Cliffe Floyd
    429 Walnut Street
    New Orleans
    Louisiana
    70118
    Usa
    Sekretär
    429 Walnut Street
    New Orleans
    Louisiana
    70118
    Usa
    AmericanExecutive53094340001
    RICKETTS, John Anthony
    Wellyard
    Nyewood
    GU31 5JA Petersfield
    Hampshire
    Sekretär
    Wellyard
    Nyewood
    GU31 5JA Petersfield
    Hampshire
    BritishLegal Adviser826820001
    WALLS, Kenneth Charles
    4 Squirrel Rise
    SL7 3PN Marlow Bottom
    Buckinghamshire
    Sekretär
    4 Squirrel Rise
    SL7 3PN Marlow Bottom
    Buckinghamshire
    British24310840002
    BELL & SCOTT (SECRETARIAL SERVICES) LIMITED
    Hill Street
    EH2 3LD Edinburgh
    16
    Midlothian
    Scotland
    Sekretär
    Hill Street
    EH2 3LD Edinburgh
    16
    Midlothian
    Scotland
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    RegistrierungsnummerSC268061
    97847080001
    DAVIDSON CHALMERS (SECRETARIAL SERVICES) LIMITED
    12 Hope Street
    EH2 4DB Edinburgh
    Midlothian
    Sekretär
    12 Hope Street
    EH2 4DB Edinburgh
    Midlothian
    137092310001
    BARTON, Derek John
    Woodend
    The Cedars
    RH16 1RP Haywards Heath
    West Sussex
    Geschäftsführer
    Woodend
    The Cedars
    RH16 1RP Haywards Heath
    West Sussex
    BritishCertified Accountant767710001
    BUCHAN, William Jamie
    The Yews Knoll Road
    GU7 2EL Godalming
    Surrey
    Geschäftsführer
    The Yews Knoll Road
    GU7 2EL Godalming
    Surrey
    BritishMarketing Director44486250001
    CURRENCE, Richard Morrison
    541 Audubon
    New Orleans
    Louisiana 70118
    Usa
    Geschäftsführer
    541 Audubon
    New Orleans
    Louisiana 70118
    Usa
    AmericanExecutive10304500001
    DICK, Stephen Wallace
    Lake Charlotte Lane
    77406 Richmond
    1738
    Tx
    Usa
    Geschäftsführer
    Lake Charlotte Lane
    77406 Richmond
    1738
    Tx
    Usa
    UsaAmericanManager44896530002
    DONNELLY, James Harkness
    6 The Steading
    Upper Anguston
    AB14 0PY Aberdeen
    Geschäftsführer
    6 The Steading
    Upper Anguston
    AB14 0PY Aberdeen
    BritishShip Manager77730750002
    FANNING, Quinn Paul
    3251 Reba Drive
    Houston
    Texas
    Tx 77019
    United States
    Geschäftsführer
    3251 Reba Drive
    Houston
    Texas
    Tx 77019
    United States
    United StatesAmericanExecutive138896240001
    GIBBARD, Michael John
    Dormer Cottage 24 Weald Way
    CR3 6EG Caterham
    Surrey
    Geschäftsführer
    Dormer Cottage 24 Weald Way
    CR3 6EG Caterham
    Surrey
    BritishFinance Director7528830001
    HAMILTON, John Alexander
    10 Hook Hill Park
    GU22 0PX Woking
    Surrey
    Geschäftsführer
    10 Hook Hill Park
    GU22 0PX Woking
    Surrey
    EnglandBritishChief Operating Officer59522210001
    HARPER, David
    Bede House
    Billingbear Lane, Binfield
    RG42 5PS Bracknell
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Bede House
    Billingbear Lane, Binfield
    RG42 5PS Bracknell
    Berkshire
    EnglandBritishHuman Resources Director68326060001
    HART, Richard
    1 Crombie Circle
    AB14 0XU Peterculter
    Aberdeenshire
    Geschäftsführer
    1 Crombie Circle
    AB14 0XU Peterculter
    Aberdeenshire
    AmericanFinance Director56160400001
    JAYNES III, Porter Kennedy
    63 Beaconsfield Place
    AB15 4AD Aberdeen
    Geschäftsführer
    63 Beaconsfield Place
    AB15 4AD Aberdeen
    AmericanExecutive86359370001
    LENTHALL, Rodney Desmonde Morgan
    Mulberry Lodge
    Lodge Hill Road
    GU10 3RD Farnham
    Surrey
    Geschäftsführer
    Mulberry Lodge
    Lodge Hill Road
    GU10 3RD Farnham
    Surrey
    BritishManaging Director64332640001
    LOUSTEAU, Joseph Keith
    673 North Beau
    Chene Drive
    Mandeville La 70471
    United States Of America
    Geschäftsführer
    673 North Beau
    Chene Drive
    Mandeville La 70471
    United States Of America
    AmericanExecutive72710400001
    O'MALLEY, William Charles
    4 Lakeway Court
    New Orleans Louisiana 70131
    Usa
    Geschäftsführer
    4 Lakeway Court
    New Orleans Louisiana 70131
    Usa
    AmericanExecutive41492720001
    PHILIP, Graham Martin
    3 Harebell Hill
    KT11 2RS Cobham
    Surrey
    Geschäftsführer
    3 Harebell Hill
    KT11 2RS Cobham
    Surrey
    BritishChartered Accountant2585740002
    PLATT, Jeffrey Michael
    Poydras St.
    Suite 1900
    70130 New Orleans
    601
    Louisiana
    Usa
    Geschäftsführer
    Poydras St.
    Suite 1900
    70130 New Orleans
    601
    Louisiana
    Usa
    United StatesAmericanBusinessman171211630001
    ROURKE, James Lindsay
    Castle Airy
    High Street
    AB31 5TJ Banchory
    Aberdeenshire
    Geschäftsführer
    Castle Airy
    High Street
    AB31 5TJ Banchory
    Aberdeenshire
    BritishManager56160290002
    SMITH, Archibald Frederick
    Eden Lodge 67 Nightingale Road
    WD3 2BU Rickmansworth
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Eden Lodge 67 Nightingale Road
    WD3 2BU Rickmansworth
    Hertfordshire
    United KingdomBritishManager201270780001
    TAMBLYN, Ken Chaffin
    78021 Donnie Road
    Folsom
    LA 70437 Louisiana
    Usa
    Geschäftsführer
    78021 Donnie Road
    Folsom
    LA 70437 Louisiana
    Usa
    AmericanExecutive39349160001
    TAYLOR, Dean Edward
    6109 Penny Lane
    Kiln
    Ms 39556
    Usa
    Geschäftsführer
    6109 Penny Lane
    Kiln
    Ms 39556
    Usa
    UsaAmericanExecutive190219250001
    WARNER, Neil William
    7 Linkway
    GU15 2NH Camberley
    Surrey
    Geschäftsführer
    7 Linkway
    GU15 2NH Camberley
    Surrey
    BritishChartered Accountant41166370001
    WRIGHT, Kenneth
    50 Moss Delph Lane
    Aughton
    L39 5DZ Ormskirk
    Lancashire
    Geschäftsführer
    50 Moss Delph Lane
    Aughton
    L39 5DZ Ormskirk
    Lancashire
    BritishExecutive Director/Secretary4781220001

    Hat TIDEWATER MARINE NORTH SEA LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A second preferred panamanian mortgage over M.V."oil benue"
    Erstellt am 10. Sept. 1993
    Geliefert am 24. Sept. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £1,354,160 and the expenses (as defined) and all moneys due or to become due from the company to lloyds bank PLC on any account whatsoever under the terms of the financial agreement of even date and the security documents (as defined) or any of them
    Kurze Angaben
    The vessel "oil benue" and all interest therein. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 24. Sept. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    A general assignment supplemental to the second preferred panamanian mortgage of even date
    Erstellt am 10. Sept. 1993
    Geliefert am 24. Sept. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the financial agreement,the finance documents (as defined) or any of them
    Kurze Angaben
    The vessel "O.I.L. benue" with all rights,title and interest thereon; all contracts of insurances. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 24. Sept. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    A first preferred panamanian mortgage over M.V."oil benue"
    Erstellt am 10. Sept. 1993
    Geliefert am 24. Sept. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the shipowner's agreement of even date,the mortgage and the security documents (as defined) or any of them
    Kurze Angaben
    The ship known as M.V."oil benue" with all interest thereon; all engines,machinery,etc. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Secretary of State for Trade and Industry
    Transaktionen
    • 24. Sept. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    A contract assignment
    Erstellt am 10. Sept. 1993
    Geliefert am 10. Sept. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £1,354,160 and interest thereon,the expenses (as defined) and all other sums due from the company to lloyds bank PLC on any account whatsoever under the terms of the financial agreement and the security documents (as defined) or any of them
    Kurze Angaben
    The vessel as defined in the financial agreement dated 17/9/92 as being 2350 bhp,hull no.102 With all her engines,equipment and machinery over the vessel "oil benue". See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Sept. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    A shipowners agreement
    Erstellt am 10. Sept. 1993
    Geliefert am 10. Sept. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of clause 4 and 5 of this agreement
    Kurze Angaben
    Any moneys payable in accordance with clause 3.1 or 4.2 of the contract assignment (as defined) or of clause 2.3 of the general assignment (as defined) over the vessel 2350 bhp,hull no.102 (As defined) with all engines,equipment and machinery thereon over the vessel "oil benue". See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Secretary of State for Trade and Industry
    Transaktionen
    • 10. Sept. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    A first preferred panamanian mortgage over M.V."oil razee"
    Erstellt am 27. Aug. 1993
    Geliefert am 08. Sept. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the shipowners' agreement of even date,the mortgage and the other security documents (as defined) or any of them
    Kurze Angaben
    The ship "oil razee" with all engines,machinery,fuel,etc. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Secretary of State for Trade and Industry
    Transaktionen
    • 08. Sept. 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    • 08. Sept. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    First preferred panamanian mortgage
    Erstellt am 27. Aug. 1993
    Geliefert am 08. Sept. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the shipowner's agreement of even date and the mortgage and the other security documents (as defined) or any of them
    Kurze Angaben
    The ship being the vessel M.V. "oil randan". See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Secretary of State for Trade and Industry
    Transaktionen
    • 08. Sept. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    A second preferred panamanian mortgage over M.V."oil randan"
    Erstellt am 27. Aug. 1993
    Geliefert am 08. Sept. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £559,200 and the expenses (as defined) and all moneys due or to become due from the company to lloyds bank PLC on any account whatsoever under the financial agreement of even date and the security documents (as defined)
    Kurze Angaben
    The ship (being the vessel M.V. "oil randan"). See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 08. Sept. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    Second preferred panamanian mortgage
    Erstellt am 27. Aug. 1993
    Geliefert am 08. Sept. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £559,200 and the expenses (as defined) and all monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoeverunder the financial agreement of even date and the security documents (as defined)
    Kurze Angaben
    The vessel "O.I.L. razee". See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 08. Sept. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Apr. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A general assignment
    Erstellt am 27. Aug. 1993
    Geliefert am 08. Sept. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The outstanding indebtedness being the loan of £559,200 and interest thereon,the expenses (as defined) and all other sums due from the company to lloyds bank PLC on any account whatsoever under the terms of the financial agreement and the security documents (as defined) or any of them under the financial agreement of even date and the security documents (as defined)
    Kurze Angaben
    The vessel "O.I.L. razee" with all rights,title and interest thereon; all policies and contracts of insurance. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 08. Sept. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Apr. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A shipowners agreement
    Erstellt am 27. Aug. 1993
    Geliefert am 01. Sept. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to clause 4,and 5 of the shipowners agreement
    Kurze Angaben
    Any moneys payable to the company in accordance with clause 3.1 or 4.2 of the contract agreement (as defined) or of clause 2.3 of the general assignment (as defined) or of clause 8.1 of the mortgage (as defined) over the vessel known as 760 bhp,line handling,hull no.112 With all her engines,equipment and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Secretary of State for Trade and Industry
    Transaktionen
    • 01. Sept. 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    • 01. Sept. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    A contract assignment
    Erstellt am 27. Aug. 1993
    Geliefert am 01. Sept. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The outstanding indebtedness being the loan of £559,200 and interest thereon,the expenses (as defined) and all other sums due from the company to lloyds bank PLC on any account whatsoever under the terms of the financial agreement and the security documents (as defined) or any of them
    Kurze Angaben
    All interest,benefits,rights and titles in and under the contract (as defined) including the vessel being 760 bhp line handling tug to be known as hull no.112 With all her engines,equipment and machinery thereon; all moneys payable in respect of insurances effected by the builder under the contract and all other interests. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 01. Sept. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Apr. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A general assignment
    Erstellt am 27. Aug. 1993
    Geliefert am 01. Sept. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The outstanding indebtedness being the loan of £559,200 and interest thereon, the expenses (as defined) and all other sums due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the financial agreement and the security documents (as defined) or any of them
    Kurze Angaben
    (A) all the company's beneficial interest and all its benefits, rights and titles in and under the contract, including the vessel "O.I.l randan" with all her engines and equipment in and under the contract and all moneys payable by the builder to the company under the contract; (b) all monies payable in respect of the insurances and all other interest thereunder. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 01. Sept. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    A shipowners agreement
    Erstellt am 27. Aug. 1993
    Geliefert am 01. Sept. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to clause 4 and 5 of the shipowners agreement
    Kurze Angaben
    Any moneys payable to the company in accordance with clause 3.1 or 4.2 of the contract assignment (as defined) over the vessel - 760 bhp line handling tug,hull no.111 With all engines,equipment and machinery etc.. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Secretary of State for Trade and Industry
    Transaktionen
    • 01. Sept. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Apr. 1997Registrierung einer Belastung
    A contract assignment
    Erstellt am 27. Aug. 1993
    Geliefert am 01. Sept. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £559,200 and interest thereon,the expenses (as defined) and all other sums due from the company to lloyds bank PLC on any account whatsoever under the terms of the financial agreement and the security documents (as defined) or any of them
    Kurze Angaben
    All interest,rights,benefits and titles over the vessel "oil randan"; hull no.111 With all engines,equipment and machinery,etc. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 01. Sept. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    A second preferred panamanian mortgage over "oil benin"
    Erstellt am 05. Aug. 1993
    Geliefert am 17. Aug. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £1,354,160 and all other moneys due or to become due from the company to lloyds bank PLC under the terms of the financial agreement of even date and the security documents (all as defined) or any of them
    Kurze Angaben
    (A) all the company's beneficial interest and all benefits rights and titles in and under the contract, including the vessel and all her engines and equipment etc. and all moneys payable by the builder to the company under the contract and (b) all monies payable to the company in respect of the insurances effected by the builder under the contract and all the company's joint or other interests in connection with such insurances over the ship "oil benin". See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 17. Aug. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    A shipowners agreement
    Erstellt am 05. Aug. 1993
    Geliefert am 06. Aug. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to clause 4 and 5 of the agreement
    Kurze Angaben
    The ship being the vessel defined as 2350 bhp,hull no.101 With all engines,equipment and machinery,etc.any moneys payable in accordance with clause 3.1 or 4.2 of the contract assignment. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Secretary of State for Trade and Industry
    Transaktionen
    • 06. Aug. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    A contract assignment
    Erstellt am 05. Aug. 1993
    Geliefert am 06. Aug. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the financial agreement and the security documents (as defined)
    Kurze Angaben
    All benefits,rights,titles and interest in and under the contracts (as defined) over the vessel being 2350 bhp,hull no.101 With all engines,equipment and machinery; the vessel known as "benin". See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 06. Aug. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    A general assignmentt
    Erstellt am 05. Aug. 1993
    Geliefert am 06. Aug. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the financial agreement and the security documents (as defined)
    Kurze Angaben
    All its benefits, rights and titles (but not its obligations) in and under the contract (as defined) including the vessel "oil benin". See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 06. Aug. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    A second preferred panamanian mortgage over "oil B0NNY"
    Erstellt am 28. Mai 1993
    Geliefert am 11. Juni 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the shipowners' agreement of even date and the mortgage and the other security documents (as defined) or any of them
    Kurze Angaben
    The ship being: the vessel "O.I.l bonny" of the following dimensions and tonnages length overall (excluding fenders) 30.50 metres having international call sign hp-7225. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. Juni 1993Registrierung einer Belastung (395)
    A second preferred panamanian mortgage over "oil orashi"
    Erstellt am 28. Mai 1993
    Geliefert am 11. Juni 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the financial agreement and the security documents (asdefined) or any of them
    Kurze Angaben
    The ship "oil orashi" with all related interest therein. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. Juni 1993Registrierung einer Belastung (395)
    A second preferred panamanian mortgage over "oil bonny"
    Erstellt am 28. Mai 1993
    Geliefert am 11. Juni 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the financial agreement (as defined) and the security documents (as defined) or any of them
    Kurze Angaben
    The ship (being the vessel "O.I.L. bonny"). See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. Juni 1993Registrierung einer Belastung (395)
    A first preferred panamanian mortgage over "oil bonny"
    Erstellt am 28. Mai 1993
    Geliefert am 11. Juni 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the financial agreement (as defined) and the security documents (as defined) or any of them
    Kurze Angaben
    The ship being the vessel "O.I.L. bonny". See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Secretary of State for Trade and Industry
    Transaktionen
    • 11. Juni 1993Registrierung einer Belastung (395)
    First preferred panamanian mortgage
    Erstellt am 28. Mai 1993
    Geliefert am 11. Juni 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the shipowners' agreement (as defined), this mortgage and the other security documents (as defined) or any of them
    Kurze Angaben
    The ship (being the vessel M.V. "oil otamiri"). See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Secretary of State for Trade and Industry
    Transaktionen
    • 11. Juni 1993Registrierung einer Belastung (395)
    A first preferred panamanian mortgage
    Erstellt am 28. Mai 1993
    Geliefert am 11. Juni 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the shipowners' agreement (as defined), this mortgage and the other security documents (as defined) or any of them
    Kurze Angaben
    The ship (being the vessel M.V. "oil orashi"). See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Secretary of State for Trade and Industry
    Transaktionen
    • 11. Juni 1993Registrierung einer Belastung (395)

    Hat TIDEWATER MARINE NORTH SEA LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    15. Juli 2013Beginn der Verwaltung
    15. Nov. 2013Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Ian James Corfield
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Praktiker
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    David John Dunckley
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Praktiker
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    2
    DatumTyp
    15. Nov. 2013Beginn der Liquidation
    03. Juni 2016Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Ian James Corfield
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Praktiker
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    David John Dunckley
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Praktiker
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0