MOLINARE HOLDINGS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameMOLINARE HOLDINGS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01004983
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von MOLINARE HOLDINGS LIMITED?

    • (7415) /

    Wo befindet sich MOLINARE HOLDINGS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    38 De Montfort Street
    LE1 7GS Leicester
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von MOLINARE HOLDINGS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    STEFAN SARGENT PRODUCTIONS LIMITED17. März 197117. März 1971

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MOLINARE HOLDINGS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Juni 2011

    Welche sind die letzten Einreichungen für MOLINARE HOLDINGS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Mitteilung über den Übergang von der Verwaltung zur Auflösung am 26. Nov. 2013

    11 Seiten2.35B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 06. Juni 2013

    11 Seiten2.24B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 06. Dez. 2012

    11 Seiten2.24B

    Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge

    1 SeitenF2.18

    Vorschlag des Verwalters

    38 Seiten2.17B

    Mitteilung über den Beschluss zur Behandlung von belasteten Vermögenswerten

    5 Seiten2.28B

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 19 Harcourt House London W1A 2AW am 13. Juni 2012

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines Verwalters

    1 Seiten2.12B

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2011

    14 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Anish Sharma als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 04. Jan. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital18. Mai 2011

    Kapitalaufstellung am 18. Mai 2011

    • Kapital: GBP 532,070
    SH01

    Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 18. Mai 2010

    • Kapital: GBP 532,070
    3 SeitenSH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2010

    15 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Mark Foligno als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Steven Milne als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2009

    13 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 04. Jan. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    18 SeitenAR01

    Verschiedenes

    Section 519 ca 2006
    1 SeitenMISC

    Verschiedenes

    Section 519 of ca 2006
    1 SeitenMISC

    Beendigung der Bestellung von Deepak Sikka als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2008

    11 SeitenAA

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    Wer sind die Geschäftsführer von MOLINARE HOLDINGS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    TEWARI, Abhieshek
    C-67 Friends Colony East
    New Delhi
    110065
    India
    Geschäftsführer
    C-67 Friends Colony East
    New Delhi
    110065
    India
    IndiaIndianDirector135317410001
    TIWARI, Anand Kumar
    C-67 Friends Colony East
    New Delhi
    110065
    India
    Geschäftsführer
    C-67 Friends Colony East
    New Delhi
    110065
    India
    IndiaIndianDirector130605760001
    TIWARI, Probodh
    C-67 Friends Colony East
    FOREIGN New Delhi
    110065
    India
    Geschäftsführer
    C-67 Friends Colony East
    FOREIGN New Delhi
    110065
    India
    IndiaIndianDirector127876480001
    BALDWIN, Peter Alan Charles, Major General
    Acorns Oak End Way
    SL9 8DA Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Sekretär
    Acorns Oak End Way
    SL9 8DA Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    British50762530001
    HAMMOND, Michael Lawley
    64 Edna Road
    SW20 8BT London
    Sekretär
    64 Edna Road
    SW20 8BT London
    British48477380001
    LASSMAN, Keith
    The Oaks
    WS19 4LA Oxley
    7
    Herts
    Sekretär
    The Oaks
    WS19 4LA Oxley
    7
    Herts
    BritishSolicitor135317590001
    LAWSON-TANCRED, Andrew
    Aldborough Manor
    YO51 9EP Boroughbridge
    North Yorkshire
    Sekretär
    Aldborough Manor
    YO51 9EP Boroughbridge
    North Yorkshire
    British62085530001
    ROBERTS, Nigel John
    32 Werna House
    31 Monument Street
    EC3R 8BT London
    Sekretär
    32 Werna House
    31 Monument Street
    EC3R 8BT London
    British93265570001
    ROSAMOND, Mark
    35 Peckarmans Wood
    Crescent Wood Road
    SE26 6RY London
    Sekretär
    35 Peckarmans Wood
    Crescent Wood Road
    SE26 6RY London
    British35664160001
    SIKKA, Deepak Kumar
    Edith Grove
    SW10 0NH London
    Basement Flat 106
    Sekretär
    Edith Grove
    SW10 0NH London
    Basement Flat 106
    British139159140001
    SIKKA, Deepak Kumar
    Basement Flat
    106 Edith Grove
    SW10 0NH London
    Sekretär
    Basement Flat
    106 Edith Grove
    SW10 0NH London
    BritishAccountant103446470001
    ANDERSON, Martin Hume Caldicot
    Long House Farm
    Penrhos
    NP5 2DE Raglan
    Gwent
    Geschäftsführer
    Long House Farm
    Penrhos
    NP5 2DE Raglan
    Gwent
    United KingdomBritishManaging Director105198750001
    BATE, Terence
    105 Hamri Street
    Ghajnsielem
    Gozo
    Malta
    Geschäftsführer
    105 Hamri Street
    Ghajnsielem
    Gozo
    Malta
    MaltaCanadianDirector51047490001
    CALLEN, Stephen Gibson
    14 St Pauls Road
    TW9 2HH Richmond
    Surrey
    Geschäftsführer
    14 St Pauls Road
    TW9 2HH Richmond
    Surrey
    EnglandBritishFinance Director1530360001
    FIRMIN, Barry Howard
    Broad Oaks
    Lewes Road
    RH17 7SP Haywards Heath
    West Sussex
    Geschäftsführer
    Broad Oaks
    Lewes Road
    RH17 7SP Haywards Heath
    West Sussex
    BritishChartered Accountant17772130002
    FOLIGNO, Mark Wayne
    70 Bolton Road
    SL4 3JL Windsor
    Berkshire
    Geschäftsführer
    70 Bolton Road
    SL4 3JL Windsor
    Berkshire
    EnglandBritishManaging Director125294570001
    LAWSON-TANCRED, Andrew
    Aldborough Manor
    YO51 9EP Boroughbridge
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    Aldborough Manor
    YO51 9EP Boroughbridge
    North Yorkshire
    EnglandBritishCo Director/Lawyer62085530001
    MILNE, Steven John
    South Lodge
    112 London Road
    GU34 4EW Holybourne
    Hampshire
    Geschäftsführer
    South Lodge
    112 London Road
    GU34 4EW Holybourne
    Hampshire
    United KingdomBritishManaging Director92303450002
    ROSAMOND, Mark
    35 Peckarmans Wood
    Crescent Wood Road
    SE26 6RY London
    Geschäftsführer
    35 Peckarmans Wood
    Crescent Wood Road
    SE26 6RY London
    EnglandBritishChartered Accountant35664160001
    ROWLANDS, Christopher John
    Buchan House
    24 Northumberland Road Redland
    BS6 7BB Bristol
    Geschäftsführer
    Buchan House
    24 Northumberland Road Redland
    BS6 7BB Bristol
    United KingdomBritishDirector4524130002
    SARGENT, Nicola Jane
    97 Albert Bridge Road
    Battersea
    SW11 4PF London
    Geschäftsführer
    97 Albert Bridge Road
    Battersea
    SW11 4PF London
    BritishCompany Director90167470001
    SHARMA, Anish Kumar
    R-756 New Rajinder Nagar
    FOREIGN New Delhi
    110060
    India
    Geschäftsführer
    R-756 New Rajinder Nagar
    FOREIGN New Delhi
    110060
    India
    IndiaIndianDirector127876360001
    SIKKA, Deepak Kumar
    Basement Flat
    106 Edith Grove
    SW10 0NH London
    Geschäftsführer
    Basement Flat
    106 Edith Grove
    SW10 0NH London
    United KingdomBritishFinance Director103446470001
    SPINNER, Richard Frederick
    Herrnstrasse 46
    8000 Munchen 22
    FOREIGN Germany
    Geschäftsführer
    Herrnstrasse 46
    8000 Munchen 22
    FOREIGN Germany
    Us CitizenCompany Executive29912020003
    WOOLFSON, Darren Joseph
    8 Sunningfields Crescent
    Hendon
    NW4 4RD London
    Geschäftsführer
    8 Sunningfields Crescent
    Hendon
    NW4 4RD London
    BritishTechnical Director58266070001

    Hat MOLINARE HOLDINGS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 22. Jan. 2009
    Geliefert am 31. Jan. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property being land and buildings at craven house, 34-36 fouberts place and 25-32 marshall street, london. Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank of India
    Transaktionen
    • 31. Jan. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 03. Juli 2008
    Geliefert am 22. Juli 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Amount standing to the credit of a designated deposit account from time to time.
    Berechtigte Personen
    • Wh Smith Retail Holdings Limited
    Transaktionen
    • 22. Juli 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 19. Mai 2004
    Geliefert am 24. Mai 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 24. Mai 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Feb. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 04. Nov. 1996
    Geliefert am 19. Nov. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • Coutts & Company
    Transaktionen
    • 19. Nov. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Sept. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 02. Sept. 1985
    Geliefert am 23. Sept. 1985
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over all f/h and l/h properties and the proceeds of sale thereof. Fixed & floaitng charges on undertaking and all property and assets presnet and future including goodwill, book & other debts & legal mortgage over l/h caraven house, mashall street, london W1. Title no: ngl 407314 and the proceeds of sale thereof.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. Sept. 1985Registrierung einer Belastung
    Debenture
    Erstellt am 19. Dez. 1984
    Geliefert am 28. Dez. 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Kurze Angaben
    Please see doc M25. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Foreign & Colonial Management Limited
    Transaktionen
    • 28. Dez. 1984Registrierung einer Belastung
    Debenture
    Erstellt am 19. Dez. 1984
    Geliefert am 28. Dez. 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge.
    Kurze Angaben
    Please see doc M24.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Electra Investment Trust PLC
    Transaktionen
    • 28. Dez. 1984Registrierung einer Belastung
    Debenture
    Erstellt am 22. Feb. 1984
    Geliefert am 10. März 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    (See doc. M23).. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Williams & Glyn's Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. März 1984Registrierung einer Belastung
    Further guarantee & debenture
    Erstellt am 25. Jan. 1984
    Geliefert am 15. Feb. 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All that property undertaking and assets charges by the principal deed and further deed.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 15. Feb. 1984Registrierung einer Belastung
    Series of debentures
    Erstellt am 10. Feb. 1983
    Geliefert am 22. Feb. 1983
    Vollständig erfüllt
    Transaktionen
    • 22. Feb. 1983Registrierung einer Belastung
    Further guarantee and debenture
    Erstellt am 20. Jan. 1983
    Geliefert am 28. Jan. 1983
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 28. Jan. 1983Registrierung einer Belastung
    Debenture
    Erstellt am 10. Dez. 1982
    Geliefert am 18. Dez. 1982
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the molinaire limited to the chargee on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    Fixed & floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill book & other debts uncalled capital. Tog. With all fixtures (inc. Trade fixtures) fixed plant & machinery stock in trade, work in progress pre-payments etc. and cash of the company. (See doc. M19).
    Berechtigte Personen
    • Industrial and Commercial Finance Corporation Limited
    Transaktionen
    • 18. Dez. 1982Registrierung einer Belastung

    Hat MOLINARE HOLDINGS LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    07. Juni 2012Beginn der Verwaltung
    26. Nov. 2013Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Situl Devji Raithatha
    38 De Montfort Street
    LE1 7GS Leicester
    Leicestershire
    Praktiker
    38 De Montfort Street
    LE1 7GS Leicester
    Leicestershire

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0