HEATH INSURANCE BROKING LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | HEATH INSURANCE BROKING LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01005219 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von HEATH INSURANCE BROKING LIMITED?
- Nicht-Lebensversicherung (65120) / Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
Wo befindet sich HEATH INSURANCE BROKING LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | The Walbrook Building 25 Walbrook EC4N 8AW London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von HEATH INSURANCE BROKING LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| C E HEATH (INSURANCE BROKING) LIMITED | 25. Apr. 1988 | 25. Apr. 1988 |
| C.E. HEATH & CO. (INSURANCE BROKING) LIMITED | 18. März 1971 | 18. März 1971 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von HEATH INSURANCE BROKING LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2017 |
Welche sind die letzten Einreichungen für HEATH INSURANCE BROKING LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr Alistair Charles Peel als Sekretär am 09. Aug. 2018 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von William Lindsay Mcgowan als Sekretär am 09. Aug. 2018 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Jan. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 13 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Jan. 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 13 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Jan. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 11 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr Matthew Pike als Direktor am 09. Feb. 2015 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Christopher Ross als Geschäftsführer am 09. Feb. 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Jan. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Mark Stephen Mugge als Geschäftsführer am 26. Jan. 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 11 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Jan. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 11 Seiten | AA | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * 9 Alie Street London E1 8DE* am 19. Aug. 2013 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung von Mr William Lindsay Mcgowan als Sekretär | 1 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Hl Corporate Services Limited als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Jan. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr David Christopher Ross am 11. Okt. 2012 | 3 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von HEATH INSURANCE BROKING LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEEL, Alistair Charles | Sekretär | 25 Walbrook EC4N 8AW London The Walbrook Building | 249410010001 | |||||||||||
| PIKE, Matthew William | Geschäftsführer | 25 Walbrook EC4N 8AW London The Walbrook Building | England | British | 187274510001 | |||||||||
| MCGOWAN, William Lindsay | Sekretär | 25 Walbrook EC4N 8AW London The Walbrook Building United Kingdom | 180337270001 | |||||||||||
| ROWE, Nicholas | Sekretär | Amberly House The Cleave OX11 0EL Harwell Oxfordshire | British | 33862660001 | ||||||||||
| SHARP, Pandora | Sekretär | Flat 9 Da Vinci Court 1 Rossetti Road SE16 3EA London | British | 64972020003 | ||||||||||
| WILKINSON, Sidney James | Sekretär | 67 Chessfield Park Little Chalfont HP6 6RU Amersham Buckinghamshire | British | 1138390001 | ||||||||||
| WILKINSON, Sidney James | Sekretär | 67 Chessfield Park Little Chalfont HP6 6RU Amersham Buckinghamshire | British | 1138390001 | ||||||||||
| HL CORPORATE SERVICES LIMITED | Sekretär | Houndsditch EC3A 7AH London 133 United Kingdom |
| 43700080007 | ||||||||||
| BARTON, Michael Keith | Geschäftsführer | Alie Street E1 8DE London 9 | England | United States | 109126210001 | |||||||||
| BLOOMER, William David | Geschäftsführer | Barry Road East Dulwich SE22 0JS London 214 | United Kingdom | British | 72374560002 | |||||||||
| BROADHURST, Timothy Edward | Geschäftsführer | Highfield House Main Road Knockholt TN14 7NU Sevenoaks Kent | United Kingdom | British | 8657480001 | |||||||||
| BRUCE, Michael Andrew | Geschäftsführer | Royston Manor St Peter's Lane Clayworth DN22 9AA Retford Nottinghamshire | United Kingdom | British | 61928170002 | |||||||||
| BURTON, Michael John | Geschäftsführer | 4a Langton Way SE3 7TL London | British | 63922600001 | ||||||||||
| COLOSSO, Adrian | Geschäftsführer | Burnham Road Woodham Mortimer CM9 6SP Maldon Hillside Farm Essex | England | British | 4555310002 | |||||||||
| DEXTER, Neil Edward | Geschäftsführer | 1 Courtlands Prince Imperial Road BR7 5LX Chislehurst Kent | England | British | 42053970001 | |||||||||
| ELDRET, Kenneth George | Geschäftsführer | Broadmead 3 Franklands Gardens RH15 0UJ Burgess Hill West Sussex | British | 34990880001 | ||||||||||
| FIELDING, Richard Walter | Geschäftsführer | West Hall Longburton DT9 5PF Sherborne Dorset | United Kingdom | British | 77656210001 | |||||||||
| HARRISON, Robert Melville | Geschäftsführer | Flint Cottage 53 Ridgway Road GU9 8NR Farnham Surrey | British | 8722560001 | ||||||||||
| HORNER, Frank Henry Leslie | Geschäftsführer | Pettits House Mountnessing Lane Doddinghurst CM15 0SP Brentwood Essex | British | 28353000001 | ||||||||||
| HUGHES, Michael Harold | Geschäftsführer | 881 Ocean Drive Appartment 16 F USA Key Biscayne Florida | British | 65226980002 | ||||||||||
| HUGHES, Paul John | Geschäftsführer | 96 Burnham Road SS9 2JS Leigh On Sea Essex | England | British | 5389800001 | |||||||||
| KAUFMAN, John Banwell | Geschäftsführer | 6 Scotsdale Close BR5 1NU Petts Wood Kent | England | British | 147388510001 | |||||||||
| KIER, Michael Hector | Geschäftsführer | 23 Belmont Road TW2 5DA Twickenham Middlesex | Danish | 8719670001 | ||||||||||
| LETBY, Roger David | Geschäftsführer | 19 Alverton Close Great Notley CM7 8XU Braintree Essex | British | 28585270003 | ||||||||||
| MACKAY, Ian Hamish Noel | Geschäftsführer | 27 Percy Laurie House 217 Upper Richmond Road SW15 6SY London | British | 104334150001 | ||||||||||
| MACKENZIE GREEN, John Garvie | Geschäftsführer | Higher Langdon DT8 3NN Beaminster Dorset | British | 34988570004 | ||||||||||
| MACKENZIE GREEN, John Garvie | Geschäftsführer | Cheesedown Farm Steventon RG25 3AY Basingstoke Hampshire | British | 34988570001 | ||||||||||
| MCCARTHY, Paul Frank | Geschäftsführer | Tor House Station Road Woldingham CR3 7DA Caterham Surrey | British | 65173730001 | ||||||||||
| MONEY, Anthony John | Geschäftsführer | Bevingdon House Belchamp Otten CO10 7BE Sudbury Suffolk | England | British | 8785440001 | |||||||||
| MUGGE, Mark Stephen | Geschäftsführer | 25 Walbrook EC4N 8AW London The Walbrook Building United Kingdom | England | American | 162920630001 | |||||||||
| NEWBERY, Trevor Philip | Geschäftsführer | Mount Lodge 37 Thorpe Esplanade SS1 3BA Southend On Sea Essex | British | 66912140001 | ||||||||||
| NEWBERY, Trevor Philip | Geschäftsführer | Mount Lodge 37 Thorpe Esplanade SS1 3BA Southend On Sea Essex | British | 66912140001 | ||||||||||
| NICHOLS, David William | Geschäftsführer | Fairacre Ravensdale Road South Ascot SL5 9HJ Ascot Berkshire | British | 6384890001 | ||||||||||
| PRESLAND, Peter Eric | Geschäftsführer | Rats Castle Castletons Oak Cranbrook Road TN27 8DY Biddenden Ashford Kent | England | British | 7649630002 | |||||||||
| PROCTOR, Jonathan Paul | Geschäftsführer | 6 Herondale Avenue Wandsworth Common SW18 3JL London | British | 8638320001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei HEATH INSURANCE BROKING LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friary Intermediate Limited | 06. Apr. 2016 | 25 Walbrook EC4N 8AW London The Walbrook Building England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat HEATH INSURANCE BROKING LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Guarantee & debenture | Erstellt am 29. Feb. 2000 Geliefert am 09. März 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to any of the secured parties (as defined) pursuant to all or any of the secured documents (as defined), including the debenture | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of variation made in addition to and modifying the security and trust deed dated 1 september 1989 ("the principal deed") as modified by a deed of variation dated 1 november 1993 (the "first deed of variation"), | Erstellt am 23. Sept. 1999 Geliefert am 01. Okt. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a charge | |
Kurze Angaben All monies (including brokerage) for the time being standing to the credit of or pursuant to lloyds brokers byelaw (no. 5 of 1988) (see form 395 for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Third guarantee and debenture | Erstellt am 31. Dez. 1997 Geliefert am 14. Jan. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the senior finance documents and the debenture as defined therein | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Second guarantee and debenture | Erstellt am 03. Dez. 1997 Geliefert am 22. Dez. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the senior finance documents and the debenture as defined therein | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of variation | Erstellt am 01. Nov. 1993 Geliefert am 10. Nov. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the security and trust deed dated 01/09/89 | |
Kurze Angaben All monies standing to the credit of an insurance broking account. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deposit agreement | Erstellt am 07. Nov. 1991 Geliefert am 12. Nov. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the deposit agreement | |
Kurze Angaben The balances for the time being standing to the credit of any accounts with the bank see form 395 for details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Trust deed | Erstellt am 01. Sept. 1989 Geliefert am 14. Sept. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Kurze Angaben See schedule attached to form 395 for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deposit charge | Erstellt am 08. Nov. 1988 Geliefert am 23. Nov. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All right title & interest of the company in & all sums from time to time standing to the credit of each l/c deposit account in the name of the company opened with the bank. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge document | Erstellt am 16. Apr. 1986 Geliefert am 25. Apr. 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Kurze Angaben A) all sums of money which may now or hereafter be held by or for the account of the bank in the name or the company at the main office of the bank in london together with all interest accruing from time to time thereon. B) all shares stocks, bonds debentures certificates of deposit or other securities (see doc M21 for details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Trust deed | Erstellt am 21. Feb. 1983 Geliefert am 23. Feb. 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge. | |
Kurze Angaben All the company's right title and interest in the monies standing to the credit of the company's "c" account and monies and investments standing to the credit in other iba accounts of the company. (See doc M.20). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0