GNI LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameGNI LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01007530
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von GNI LIMITED?

    • (6523) /

    Wo befindet sich GNI LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Lynton House 7-12 Tavistock Square
    WC1H 9LT London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von GNI LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    INTER COMMODITIES LIMITED08. Apr. 197108. Apr. 1971

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von GNI LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2009

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für GNI LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für GNI LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    12 Seiten4.71

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 18. Juli 2014

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 18. Jan. 2014

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 18. Juli 2013

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 18. Jan. 2013

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 18. Juli 2012

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 18. Jan. 2012

    5 Seiten4.68

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * 62 Wilson Street London EC2A 2BU* am 30. Sept. 2011

    2 SeitenAD01

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 18. Juli 2011

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 18. Jan. 2011

    5 Seiten4.68

    Beendigung der Bestellung von Stephen Harragan als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Karel Harbour als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Karel Harbour als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Nigel Avey als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Nigel Avey als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * Sugar Quay Lower Thames Street London EC3R 6DU* am 28. Jan. 2010

    2 SeitenAD01

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    3 Seiten4.70

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 19. Jan. 2010

    LRESSP

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    Wer sind die Geschäftsführer von GNI LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    GEORGE, Sonia Jane
    Princes Avenue
    N22 7SA London
    16
    England
    United Kingdom
    Sekretär
    Princes Avenue
    N22 7SA London
    16
    England
    United Kingdom
    British125196240002
    COCHRANE, Stephen Robert
    17 Bolton Gardens
    TW11 9AX Teddington
    Middlesex
    Sekretär
    17 Bolton Gardens
    TW11 9AX Teddington
    Middlesex
    British40052090002
    WAKEFIELD, Barry John
    The Old Manse
    27 High Street
    PE26 1AE Ramsey
    Cambridgeshire
    Sekretär
    The Old Manse
    27 High Street
    PE26 1AE Ramsey
    Cambridgeshire
    British27554930001
    WALLIS, Nicholas Charles
    35 Woodstock Road North
    AL1 4QD St Albans
    Hertfordshire
    Sekretär
    35 Woodstock Road North
    AL1 4QD St Albans
    Hertfordshire
    British4190770001
    WOYDA, Jeffrey David
    Partingdale Manor
    Partingdale Lane Mill Hill
    NW7 1NS London
    Sekretär
    Partingdale Manor
    Partingdale Lane Mill Hill
    NW7 1NS London
    British116885950001
    ADLER, Philip Howard
    16 Staverton Road
    NW2 5HL London
    Geschäftsführer
    16 Staverton Road
    NW2 5HL London
    British70968440002
    ARNOWITZ, Larry Harris
    452 Ellridge Circle
    Highland Park 60035 Illinois
    FOREIGN Usa
    Geschäftsführer
    452 Ellridge Circle
    Highland Park 60035 Illinois
    FOREIGN Usa
    American46786860001
    AVEY, Nigel Anthony Bruce
    2 Green Trees
    Ambleside
    CM16 4QT Epping
    Essex
    Geschäftsführer
    2 Green Trees
    Ambleside
    CM16 4QT Epping
    Essex
    EnglandBritish46157050002
    BOARDMAN, Guy Alexander
    86a Priests Lane
    Shenfield
    CM15 8HQ Brentwood
    Essex
    Geschäftsführer
    86a Priests Lane
    Shenfield
    CM15 8HQ Brentwood
    Essex
    British30748220002
    BOULTON, Paul
    17 Springfields
    EN10 7LX Broxbourne
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    17 Springfields
    EN10 7LX Broxbourne
    Hertfordshire
    British38532730001
    BRAYSHAW, David Arthur
    25 Avenue Road
    CM23 5NT Bishop's Stortford
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    25 Avenue Road
    CM23 5NT Bishop's Stortford
    Hertfordshire
    United KingdomBritish119697400001
    BREISLIN, Richard John Henry
    9 Blackthorn Close
    AL4 9RP St. Albans
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    9 Blackthorn Close
    AL4 9RP St. Albans
    Hertfordshire
    United KingdomBritish167444170001
    BURRIDGE, John Grey St Paul
    The Manor House
    Brixton Deverill
    BA12 7EJ Warminster
    Wiltshire
    Geschäftsführer
    The Manor House
    Brixton Deverill
    BA12 7EJ Warminster
    Wiltshire
    United KingdomBritish3718420003
    CANWELL, Stuart
    Springfield House
    22 Springfield Grove
    TW16 6NT Sunbury On Thames
    Middlesex
    Geschäftsführer
    Springfield House
    22 Springfield Grove
    TW16 6NT Sunbury On Thames
    Middlesex
    British141825210001
    CARLISLE, Euan N
    20 Lancaster Road
    SW19 5DD Wimbledon Village
    London
    Geschäftsführer
    20 Lancaster Road
    SW19 5DD Wimbledon Village
    London
    United KingdomBritish108880850001
    CAVALLA, Nicholas Mark
    Flat 1
    16 Lyndhurst Gardens
    NW3 5NR London
    Geschäftsführer
    Flat 1
    16 Lyndhurst Gardens
    NW3 5NR London
    United KingdomBritish84381380001
    COCHRANE, Stephen Robert
    17 Bolton Gardens
    TW11 9AX Teddington
    Middlesex
    Geschäftsführer
    17 Bolton Gardens
    TW11 9AX Teddington
    Middlesex
    EnglandBritish40052090002
    CONQUEST, Simon
    7 Malden Park
    KT3 6AS New Malden
    Surrey
    Geschäftsführer
    7 Malden Park
    KT3 6AS New Malden
    Surrey
    British75258750001
    CRAMER, Patrick
    La Musardiere
    Chemin De Ropre
    1135 Denens
    Switzerland
    Geschäftsführer
    La Musardiere
    Chemin De Ropre
    1135 Denens
    Switzerland
    Swiss52500640001
    DAVIES, Mark Edward Trehearne
    26 Chester Street
    SW1X 7BL London
    Geschäftsführer
    26 Chester Street
    SW1X 7BL London
    EnglandBritish82536300001
    DAVIES, Stephen Arthur James
    Iverwood
    43 Oatlands Chase
    KT13 9RP Weybridge
    Surrey
    Geschäftsführer
    Iverwood
    43 Oatlands Chase
    KT13 9RP Weybridge
    Surrey
    British73623020001
    DAVIES, Tony
    50 Worcester Crescent
    IG8 0LS Woodford Green
    Essex
    Geschäftsführer
    50 Worcester Crescent
    IG8 0LS Woodford Green
    Essex
    United KingdomBritish44889680002
    DAVIS, Kevin Roger
    Apartment 10e 271 Central Park West
    New York
    Ny 10024
    Usa
    Geschäftsführer
    Apartment 10e 271 Central Park West
    New York
    Ny 10024
    Usa
    British49328960008
    DIBBEN, Piers Farquhar
    Trinity Farm
    Rodbourne
    SN16 0EX Malmesbury
    Wiltshire
    Geschäftsführer
    Trinity Farm
    Rodbourne
    SN16 0EX Malmesbury
    Wiltshire
    United KingdomBritish65358540002
    DIZER, Chris
    37 Compton Road
    SW19 7QA London
    Geschäftsführer
    37 Compton Road
    SW19 7QA London
    British62902240001
    DOBELL, Charles Mark Johnson
    63 Lauderdale Tower
    EC2Y 8BY London
    Geschäftsführer
    63 Lauderdale Tower
    EC2Y 8BY London
    British83017500001
    EWEN, Malcolm Henry Stanley
    Wash Farm
    Ferneaux Pelham
    SG9 0JX Buntingford
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Wash Farm
    Ferneaux Pelham
    SG9 0JX Buntingford
    Hertfordshire
    British37441860001
    FELLOWES, Thomas William
    The Old Rectory
    Barking
    IP6 8HH Ipswich
    Suffolk
    Geschäftsführer
    The Old Rectory
    Barking
    IP6 8HH Ipswich
    Suffolk
    British9854990001
    FEW BROWN, Benjamin Geoffrey
    Ashe House
    Cholderton Salisbury
    Wiltshire
    Geschäftsführer
    Ashe House
    Cholderton Salisbury
    Wiltshire
    British46157470001
    FISHER, Marc Anthony
    7 Rangeworth Place
    DA15 7JE Sidcup
    Kent
    Geschäftsführer
    7 Rangeworth Place
    DA15 7JE Sidcup
    Kent
    British75258780001
    FLETCHER, Piers Michael William
    Blackberry Farm Winterslow
    SP5 1QP Salisbury
    Wiltshire
    Geschäftsführer
    Blackberry Farm Winterslow
    SP5 1QP Salisbury
    Wiltshire
    British12056130007
    FOX, Noel
    Inglenook
    Rectory Road,
    RM16 3EH Orsett
    Essex
    Geschäftsführer
    Inglenook
    Rectory Road,
    RM16 3EH Orsett
    Essex
    British88626290001
    FRIEDLOS, Stephen Michael
    Clifford House
    Christmas Hill
    GU4 8HP Guildford
    Surrey
    Geschäftsführer
    Clifford House
    Christmas Hill
    GU4 8HP Guildford
    Surrey
    EnglandBritish82802310001
    GANT, Nicholas
    184a Stock Road
    CM12 0SH Billericay
    Essex
    Geschäftsführer
    184a Stock Road
    CM12 0SH Billericay
    Essex
    British75259390001
    GORMAN, Marcus Samuel
    Old Priors
    Shermanbury Road
    RH13 8EU Partridge Green
    West Sussex
    Geschäftsführer
    Old Priors
    Shermanbury Road
    RH13 8EU Partridge Green
    West Sussex
    British75491280001

    Hat GNI LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Memorandum of pledge for deposits on time deposits and other account balances
    Erstellt am 20. Dez. 2002
    Geliefert am 03. Jan. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present future and conditional claims which dresdner bank ag with all its domestic and foreign branches is entitled as a result of the banking relationship against the company where the company has assumed liability for the obligations of another customer of dresdner bank ag (E.G. as guarantor)
    Kurze Angaben
    All the balances and deposits which the company maintains at present and in future on accounts 4990804794720 together with interest at dresdner bank ag.
    Berechtigte Personen
    • Dresdner Bank Ag
    Transaktionen
    • 03. Jan. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Nov. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Security deed
    Erstellt am 19. Nov. 2001
    Geliefert am 28. Nov. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All debts, obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee under the terms of the security deed
    Kurze Angaben
    By way of first fixed charge (a) all sums and payments on the date of the security dty deed and from time to time thereafter receivable by or on behalf of or for the account of the company by reason or in respect of any transfer or debit of or any any agreement to transfer or debit stock from any eligible stock account of or in the name of or held on behalf of or otherwise referable to the company in crest ost or any transfer by the company of any of its right title or interest to and I n stock represented or to be represented by any credit balance on any such eligible account in crest together with all rights and interests in such sums and payments.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 28. Nov. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Aug. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Security deed
    Erstellt am 04. Jan. 2001
    Geliefert am 22. Jan. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All debts, obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee under or in connection with the facility agreement and/or the security deed or any of the other documentation as defined therein
    Kurze Angaben
    By way of first fixed charge all sums and payments at the date of the security deed and from time to time thereafter receivable by or for the company, by way of first floating charge all eligible stock held by or on behalf of or for the account of the company in crest.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 22. Jan. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Juli 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Security deed
    Erstellt am 05. Juli 2000
    Geliefert am 17. Juli 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All debts, obligations and liabilties due or to become due from the company to the chargee under the terms of the security deed
    Kurze Angaben
    By way of first fixed charge (a) all sums and payments on the date of the security deed and from time to time thereafter receivable by or on behalf of or for the account of the company by reason or in respect of any transfer or debit of or any agreement to transfer or debit stock from any eligible stock account of or in the name of or held on behalf of or otherwise referable to the company in crest or any transfer by the company of any of its right title or interest to and in stock represented or to be represented by any credit balance on any such eligible account in crest together with all rights and interests in such sums and payments. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 17. Juli 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Aug. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Security deed
    Erstellt am 29. Juni 2000
    Geliefert am 30. Juni 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All debts, obligations and liabilties due or to become due from the company to the chargee under the terms of the security deed
    Kurze Angaben
    By way of first fixed charge (a) all sums and payments on the date of the security deed and from time to time thereafter receivable by or on behalf of or for the account of the company by reason or in respect of any transfer or debit of or any agreement to transfer or debit stock from any eligible stock account of or in the name of or held on behalf of or otherwise referable to the company in crest or any transfer by the company of any of its right title or interest to and in stock represented or to be represented by any credit balance on any such eligible account in crest together with all rights and interests in such sums and payments. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of England
    Transaktionen
    • 30. Juni 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Dez. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Security agreement
    Erstellt am 18. Mai 2000
    Geliefert am 26. Mai 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A security interest in and a lien upon all personal propertyn and fixtures of the debtor. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Bank of New York
    Transaktionen
    • 26. Mai 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Jan. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Memorandum of pledge
    Erstellt am 07. Apr. 2000
    Geliefert am 18. Apr. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the memorandum of pledge
    Kurze Angaben
    All balances and deposits plus interest on the following time deposits no. 499 08 047 94700 and other account balances under the no.499 08 047 94702.
    Berechtigte Personen
    • Dresdner Bank Ag
    Transaktionen
    • 18. Apr. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Nov. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Memorandum of pledge
    Erstellt am 07. Apr. 2000
    Geliefert am 18. Apr. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the memorandum of pledge
    Kurze Angaben
    All balances and deposits plus interest on the following time deposits no. 499 08 047 94700 and other account balances under the no.49908047 94700.
    Berechtigte Personen
    • Dresdner Bank Ag
    Transaktionen
    • 18. Apr. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Nov. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental security deed (supplemental to a security deed dated 14 november 1997 as amended by a further deed dated 15 january 1999)
    Erstellt am 21. Mai 1999
    Geliefert am 27. Mai 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever which arise out of or in connection with the provision of cgo settlement bank facilities (as defined in the security deed)
    Kurze Angaben
    All sums and payments on the date of the security deed to be represented by any credit balance on any such eligible account and all monies standing to the credit of the controlled accounts by way of floating charge all eligible stock ,all property rights or interests of the company to eligible stock on the cgo service and all other sums and benefits please refer to form 395 for full details. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor & Company of the Bank of England
    Transaktionen
    • 27. Mai 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Dez. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Supplemental deed in connection with the original security deed dated 10TH november 1997
    Erstellt am 15. Jan. 1999
    Geliefert am 19. Jan. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever arising out of or in connection with the provision of cgo settlement bank facilities
    Kurze Angaben
    All sums and payments on the date of the security deed to be represented by any credit balance on any such eligible account and all monies standing to the credit of the controlled accounts by way of floating charge all eligible stock ,all property rights or interests of the company to eligible stock on the cgo service and all other sums and benefits please refer to form 395 for full details. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of England
    Transaktionen
    • 19. Jan. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Dez. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Security deed
    Erstellt am 08. Juni 1998
    Geliefert am 16. Juni 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever including without limitation liabilities which arise out of or in connection with the provision by the bank to the company of crest settlement bank facilities) including all interest, costs and other charges whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of first fixed charge all sums and payments receivable by the company in crest and all monies standing to the credit of the controlled accounts. By way of first floating charge all eligible stock held by or for the account of the company in crest. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 16. Juni 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Aug. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Security deed
    Erstellt am 14. Nov. 1997
    Geliefert am 14. Nov. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever which arise out of or in connection with the provision of cgo settlement bank facilities (as defined in the security deed)
    Kurze Angaben
    All sums and payments on the date of the security deed and from time to time thereafter receivable by or on behalf of or fro the account of the company by reason or in respect of any transfer or debit, stock from any eligible stock account. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of England
    Transaktionen
    • 14. Nov. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Dez. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Supplement to collateral agreement
    Erstellt am 22. Juli 1996
    Geliefert am 09. Aug. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All amounts due or to become due from the company to the chargee referred to in section 4(a) of the collateral agreement
    Kurze Angaben
    All right title and interest in and to accounts 42 000 1X yyy/99907. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Morgan Guaranty Trust Company of New York
    Transaktionen
    • 09. Aug. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Nov. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Custody agreement
    Erstellt am 17. Aug. 1995
    Geliefert am 21. Aug. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the agreement
    Kurze Angaben
    All the cash from time to time in the cash account and all the shares stocks bonds notes debentures or other securities held for the account of the company.
    Berechtigte Personen
    • Morgan Guaranty Trust Company of New York
    • Jp Morgan S.P.A.
    Transaktionen
    • 21. Aug. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Sept. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 03. März 1995
    Geliefert am 06. März 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a banking services agreement or this deed (as defined in the legal charge)
    Kurze Angaben
    First fixed charge over all sums for the time being, first floating charge over all the right title and interest of the company, stock and other securities, any other interest conferred or to be conferred by such credit balance and any stock and other securities of any kind. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of England
    Transaktionen
    • 06. März 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Dez. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Supplement to collateral agreement
    Erstellt am 03. Nov. 1994
    Geliefert am 11. Nov. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever in relation to the company's use of the euroclear system
    Kurze Angaben
    All of the company's right title and interest in and to account no. 93905 opened by morgan guaranty brussels in the name of the company or such other account as may be agreed by the borrower and morgan guaranty brussels (the "pledged account"), including any credit balance which may appear therein. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Morgan Guaranty Trust Company of New York
    Transaktionen
    • 11. Nov. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Nov. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Collateral agreement
    Erstellt am 03. Nov. 1994
    Geliefert am 11. Nov. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever in relation to the company's use of the euroclear system
    Kurze Angaben
    All "collateral" including but not limited to cash and securities clearance accounts opened in connection with the euroclear system by the brussels office of the chargee on its books in the name of the company. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Morgan Guaranty Trust Company of New York
    Transaktionen
    • 11. Nov. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Nov. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of charge
    Erstellt am 07. Okt. 1983
    Geliefert am 10. Okt. 1983
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Deposit balance of £500,000 held with williams & glyn's bank PLC together with all interest accrued or accuring thereon.
    Berechtigte Personen
    • Williams & Glyn's Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Okt. 1983Registrierung einer Belastung
    • 27. Aug. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of charge
    Erstellt am 15. Juli 1981
    Geliefert am 16. Juli 1981
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Deposit balance of £50,000 held with williams & glyns bank limited together with all interest.
    Berechtigte Personen
    • Williams & Glyn's Bank Limited
    Transaktionen
    • 16. Juli 1981Registrierung einer Belastung
    • 27. Aug. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat GNI LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    19. Jan. 2010Beginn der Liquidation
    29. Nov. 2014Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Simon James Underwood
    62 Wilson Street
    EC2A 2BU London
    Praktiker
    62 Wilson Street
    EC2A 2BU London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0