MONARCH REALISATIONS 11 LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | MONARCH REALISATIONS 11 LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01012703 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von MONARCH REALISATIONS 11 LIMITED?
- (9999) /
Wo befindet sich MONARCH REALISATIONS 11 LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Homelife House 26/32 Oxford Road BH8 8EZ Bournemouth Dorset |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von MONARCH REALISATIONS 11 LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| MCCARTHY & STONE CORPORATE SERVICES LIMITED | 08. Sept. 1994 | 08. Sept. 1994 |
| STEPHANSTYLE LIMITED | 28. Dez. 1989 | 28. Dez. 1989 |
| LIFTWISE LIMITED | 28. Mai 1971 | 28. Mai 1971 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MONARCH REALISATIONS 11 LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Aug. 2007 |
Welche sind die letzten Einreichungen für MONARCH REALISATIONS 11 LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde eingestellt | 1 Seiten | DISS40 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 10. Sept. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. März 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Gary Neil Day am 11. Feb. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Michael John Jennings am 19. Jan. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
Gesellschaftsvertrag und Satzung | 8 Seiten | MA | ||||||||||
Bescheinigung über die Änderung der Firma Company name changed mccarthy & stone corporate services LIMITED\certificate issued on 14/05/09 | 3 Seiten | CERTNM | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Aug. 2007 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 190 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 353 | ||||||||||
legacy | 5 Seiten | 288a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Aug. 2006 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von MONARCH REALISATIONS 11 LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GREEN, Trevor Lindsay | Sekretär | Foxhill 31 Avon Castle Drive BH24 2BB Ringwood Hampshire | British | 981540001 | ||||||
| BALL, Michael David | Geschäftsführer | Mulberry House Trumps Green Road GU25 4JA Virginia Water Surrey | United Kingdom | British | 58961410002 | |||||
| DAY, Gary Neil | Geschäftsführer | Chine View Mansions 2 Mckinley Road West Overcliff BH4 8AQ Bournemouth 1 United Kingdom | United Kingdom | British | 10857490004 | |||||
| JENNINGS, Michael John | Geschäftsführer | 51 Chaddesley Glen Sandbanks BH13 7RE Poole Chameleon Dorset | England | British | 8586280013 | |||||
| PHILLIPS, Howard Peter Stewart | Geschäftsführer | Flamstone Park Bishopstone SP5 4DB Salisbury Wiltshire | England | British | 72535940003 | |||||
| FIELD, Derek Anthony | Geschäftsführer | Autumn Chase Beach Road Upton BH16 5NA Poole Dorset | British | 50673980001 | ||||||
| GRAY, John | Geschäftsführer | Crosstrees Sway Road SO41 8LR Lymington Hampshire | United Kingdom | British | 34578290001 | |||||
| LOVELOCK, Keith | Geschäftsführer | Toogoods House Moorside DT10 1HQ Sturminster Newton Dorset | British | 6219340001 | ||||||
| MCCARTHY, John Sidney | Geschäftsführer | Squalls Estate Squalls Lane Tisbury SP3 6RX Salisbury Wiltshire | England | British | 31054720002 | |||||
| PERRY, Alan | Geschäftsführer | West Park House Croft Bank WR14 4DX Malvern Worcestershire | England | British | 113912990001 | |||||
| THORNE, Matthew Wadman John | Geschäftsführer | The Mount Bannerdown Road Batheaston BA1 8EG Bath Avon | United Kingdom | British | 8469850001 | |||||
| TOWERS, Martin George | Geschäftsführer | Linton House Avenue Des Hirondelles Pool In Wharfedale LS21 1EY Otley West Yorkshire | British | 36252860002 |
Hat MONARCH REALISATIONS 11 LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 02. Dez. 1994 Geliefert am 20. Dez. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the obligors (as defined) to the chargee pursuant to the terms of each finance document (as defined) and to the ancillary bank (as defined) under each ancillary document (as defined) to which any obligor is a party | |
Kurze Angaben First floating charge all undertaking and assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 15. Dez. 1992 Geliefert am 23. Dez. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to national westminster bank PLC(as agent),the banks (or any of them)and national westminster bank PLC (in this capacity the"ancillary bank"on any account whatsoever under the terms of each of the finance documents. | |
Kurze Angaben Please see doc M48 for full details.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 23. Mai 1980 Geliefert am 23. Mai 1980 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed & floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill & bookdebts uncalled capital.. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0