HUNTSWORTH GROUP LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameHUNTSWORTH GROUP LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01015851
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von HUNTSWORTH GROUP LIMITED?

    • Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich HUNTSWORTH GROUP LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    8th Floor, Holborn Gate,
    26 Southampton Buildings,
    WC2A 1AN London
    England
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von HUNTSWORTH GROUP LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    HOLMES & MARCHANT GROUP LIMITED 14. Feb. 200114. Feb. 2001
    HOLMES & MARCHANT HEALTHCARE COMMUNICATIONS LIMITED01. Okt. 199901. Okt. 1999
    HOLMES & MARCHANT COUNSELLOR LIMITED26. Okt. 199326. Okt. 1993
    FRANK BIGGS (P.R.) LIMITED28. Juni 197128. Juni 1971

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von HUNTSWORTH GROUP LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2016

    Welche sind die letzten Einreichungen für HUNTSWORTH GROUP LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Erfüllung der Belastung 010158510018 vollständig

    1 SeitenMR04

    Bestätigungserklärung erstellt am 10. Juni 2018 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2016

    9 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 10. Juni 2017 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2015

    10 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 10. Juni 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital07. Juli 2016

    Kapitalaufstellung am 07. Juli 2016

    • Kapital: GBP 1,000
    SH01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 3 London Wall Buildings London EC2M 5SY zum 8th Floor, Holborn Gate, 26 Southampton Buildings, London WC2A 1AN am 07. Juli 2016

    1 SeitenAD01

    Ernennung von Mr Neil Garth Jones als Direktor am 01. Juli 2016

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Rebecca Adele Horne als Geschäftsführer am 01. Juli 2016

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2014

    4 SeitenAA

    second-filing-of-form-with-form-type

    4 SeitenRP04
    Anmerkungen
    DatumAnmerkung
    28. Sept. 2015Clarification Second filing TM01 for Alison Clarke

    Erfüllung der Belastung 12 vollständig

    2 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 11 vollständig

    2 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 13 vollständig

    2 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 14 vollständig

    2 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 15 vollständig

    2 SeitenMR04

    Ernennung von Mrs Rebecca Adele Horne als Direktor am 01. Juli 2015

    2 SeitenAP01

    Erfüllung der Belastung 17 vollständig

    5 SeitenMR04

    Jahresrückblick erstellt bis 10. Juni 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital14. Juli 2015

    Kapitalaufstellung am 14. Juli 2015

    • Kapital: GBP 1,000
    SH01

    Beendigung der Bestellung eines Geschäftsführers

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Alison Jane Clarke als Geschäftsführer am 14. Juni 2015

    2 SeitenTM01
    Anmerkungen
    DatumAnmerkung
    28. Sept. 2015Clarification A second filed TM01 was registered on 28/09/2015

    Wer sind die Geschäftsführer von HUNTSWORTH GROUP LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    JONES, Neil Garth
    26 Southampton Buildings,
    WC2A 1AN London
    8th Floor, Holborn Gate,
    England
    Geschäftsführer
    26 Southampton Buildings,
    WC2A 1AN London
    8th Floor, Holborn Gate,
    England
    EnglandBritishFinance Director204774750001
    MORROW, Martin
    26 Southampton Buildings,
    WC2A 1AN London
    8th Floor, Holborn Gate,
    England
    Geschäftsführer
    26 Southampton Buildings,
    WC2A 1AN London
    8th Floor, Holborn Gate,
    England
    United KingdomBritishChartered Accountant167225950001
    BROCKWELL, David Paul
    48 Saint Margarets Grove
    HP15 6HP Great Kingshill
    Buckinghamshire
    Sekretär
    48 Saint Margarets Grove
    HP15 6HP Great Kingshill
    Buckinghamshire
    BritishAccountant76990590001
    CULVER EVANS, Philip Frederick
    Bradfield Cottage
    Bradfield Willand
    EX15 2RA Cullompton
    Devon
    Sekretär
    Bradfield Cottage
    Bradfield Willand
    EX15 2RA Cullompton
    Devon
    BritishAccountant93870000001
    HATFIELD, Adam George Roland
    Old Berkeley Cottage
    Common Road
    WD3 5LW Chorleywood
    Hertfordshire
    Sekretär
    Old Berkeley Cottage
    Common Road
    WD3 5LW Chorleywood
    Hertfordshire
    BritishChartered Accountant84503340001
    LAWSON, David Sydney
    15 Montford Mews
    Hazlemere
    HP15 7FR High Wycombe
    Buckinghamshire
    Sekretär
    15 Montford Mews
    Hazlemere
    HP15 7FR High Wycombe
    Buckinghamshire
    BritishChartered Accountant69676920003
    LEES, Jennifer Kathryn
    15-17 Huntsworth Mews
    NW1 6DD London
    Sekretär
    15-17 Huntsworth Mews
    NW1 6DD London
    British24587010002
    WHITE, Jeremy Mark
    14 Parkway
    Ratton
    BN20 9DX Eastbourne
    Sussex
    Sekretär
    14 Parkway
    Ratton
    BN20 9DX Eastbourne
    Sussex
    BritishChartered Accountant51297980001
    WILSON, David John
    65 Chaucer Drive
    HP21 7LH Aylesbury
    Buckinghamshire
    Sekretär
    65 Chaucer Drive
    HP21 7LH Aylesbury
    Buckinghamshire
    British9576840001
    ADAMS, Colin Raymond
    15-17 Huntsworth Mews
    London
    NW1 6DD
    Geschäftsführer
    15-17 Huntsworth Mews
    London
    NW1 6DD
    EnglandBritishFinance Director39245820011
    BOOTON, Richard John
    Alveston Cottage
    Henton
    OX9 4AE Chinnor
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    Alveston Cottage
    Henton
    OX9 4AE Chinnor
    Oxfordshire
    BritishCommercial Director35281360001
    BROADHEAD, Tymon Piers
    Huntsworth Mews
    NW1 6DD London
    15-17
    Geschäftsführer
    Huntsworth Mews
    NW1 6DD London
    15-17
    EnglandBritishAccountant105342600002
    BROCKWELL, David Paul
    48 Saint Margarets Grove
    HP15 6HP Great Kingshill
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    48 Saint Margarets Grove
    HP15 6HP Great Kingshill
    Buckinghamshire
    BritishAccountant76990590001
    CHADLINGTON, Lord
    Huntsworth Mews
    NW1 6DD London
    15-17
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Huntsworth Mews
    NW1 6DD London
    15-17
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director188597840001
    CHADLINGTON, Peter Selwyn, Lord
    Dean Manor
    Dean
    OX7 3LD Chipping Norton
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    Dean Manor
    Dean
    OX7 3LD Chipping Norton
    Oxfordshire
    EnglandBritishCompany Director69986940001
    CLARKE, Alison Jane
    London Wall Buildings
    EC2M 5SY London
    3
    Geschäftsführer
    London Wall Buildings
    EC2M 5SY London
    3
    United KingdomBritishCompany Director93418210001
    CLARKE, Alison Jane
    5 Lyford Road
    SW18 3LU London
    Geschäftsführer
    5 Lyford Road
    SW18 3LU London
    United KingdomBritishPr Consultant93418210001
    COPUS, Martin Noel
    4 Bockmer End Cottage
    SL7 2HL Marlow
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    4 Bockmer End Cottage
    SL7 2HL Marlow
    Buckinghamshire
    BritishExecutive Director87019800001
    CULVER EVANS, Philip Frederick
    Bradfield Cottage
    Bradfield Willand
    EX15 2RA Cullompton
    Devon
    Geschäftsführer
    Bradfield Cottage
    Bradfield Willand
    EX15 2RA Cullompton
    Devon
    United KingdomBritishAccountant93870000001
    DENHAM, Leonard Charles
    Downs Hollow Burford Road
    OX7 5XB Chipping Norton
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    Downs Hollow Burford Road
    OX7 5XB Chipping Norton
    Oxfordshire
    BritishDirector4345380001
    DICKIE, Nigel Hugh
    The Old Lodge
    2 Saint Marys Road
    KT22 8EU Leatherhead
    Surrey
    Geschäftsführer
    The Old Lodge
    2 Saint Marys Road
    KT22 8EU Leatherhead
    Surrey
    United KingdomBritishCompany Director126167930001
    FRENCH, Rosemary Jean
    The Stables The Green
    Stadhampton
    OX44 7UW Oxford
    Geschäftsführer
    The Stables The Green
    Stadhampton
    OX44 7UW Oxford
    BritishPublic Relations Executive45827060001
    HOLMES, John Francis
    The Hill House
    OX10 6HP Ewelme
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    The Hill House
    OX10 6HP Ewelme
    Oxfordshire
    United KingdomBritishDirector10214420001
    HORNE, Rebecca Adele
    London Wall Buildings
    EC2M 5SY London
    3
    Geschäftsführer
    London Wall Buildings
    EC2M 5SY London
    3
    United KingdomBritishAccountant188956200001
    LAWSON, David Sydney
    15 Montford Mews
    Hazlemere
    HP15 7FR High Wycombe
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    15 Montford Mews
    Hazlemere
    HP15 7FR High Wycombe
    Buckinghamshire
    BritishChartered Accountant69676920003
    MARKHAM, Gill Laura
    Holywell Lodge Kingswood Avenue
    Penn
    HP10 8DR High Wycombe
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Holywell Lodge Kingswood Avenue
    Penn
    HP10 8DR High Wycombe
    Buckinghamshire
    EnglandBritishDirector183292880001
    NEWMAN, Helen
    129 High Street
    HP7 0DY Amersham
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    129 High Street
    HP7 0DY Amersham
    Buckinghamshire
    BritishCommunications71259370001
    OWEN, Julie Gay
    9 Swan Terrace
    SL4 5JF Windsor
    Berkshire
    Geschäftsführer
    9 Swan Terrace
    SL4 5JF Windsor
    Berkshire
    BritishPublic Relations Consultant16489900001
    SAVILLE, George
    11 Oakwood
    HP4 3NQ Berkhamsted
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    11 Oakwood
    HP4 3NQ Berkhamsted
    Hertfordshire
    BritishDirector45638180001
    SCOTT, Lesley Christine
    31c Bedford Road
    Moor Park
    HA6 2AY Northwood
    Middlesex
    Geschäftsführer
    31c Bedford Road
    Moor Park
    HA6 2AY Northwood
    Middlesex
    BritishPublic Relations59233080001
    SELMAN, Roger Malcolm
    5 Vineries Bank
    Milespit Hill Mill Hill
    NW7 2RP London
    Geschäftsführer
    5 Vineries Bank
    Milespit Hill Mill Hill
    NW7 2RP London
    United KingdomBritishFinance Director10691510002
    SELMAN, Roger Malcolm
    5 Vineries Bank
    Milespit Hill Mill Hill
    NW7 2RP London
    Geschäftsführer
    5 Vineries Bank
    Milespit Hill Mill Hill
    NW7 2RP London
    United KingdomBritishFinance Director10691510002
    TORR, Jack
    Crackington
    Tape Lane Hurst
    RG10 0DP Reading
    Berks
    Geschäftsführer
    Crackington
    Tape Lane Hurst
    RG10 0DP Reading
    Berks
    BritishDirector32361900001
    WILSON, David John
    65 Chaucer Drive
    HP21 7LH Aylesbury
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    65 Chaucer Drive
    HP21 7LH Aylesbury
    Buckinghamshire
    EnglandBritishAccountant9576840001
    WITHEY, Sally-Ann Patricia
    15-17 Huntsworth Mews
    London
    NW1 6DD
    Geschäftsführer
    15-17 Huntsworth Mews
    London
    NW1 6DD
    EnglandBritishChief Operations Officer109428260052

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei HUNTSWORTH GROUP LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Huntsworth Investments Limited
    26 Southampton Buildings
    WC2A 1AN London
    8th Floor, Holborn Gate
    England
    06. Apr. 2016
    26 Southampton Buildings
    WC2A 1AN London
    8th Floor, Holborn Gate
    England
    Nein
    RechtsformLimited Liability Company
    RegistrierungslandEngland
    RechtsgrundlageCompanies Act 2006 (As Amended)
    RegistrierungsortEngland & Wales
    Registrierungsnummer01894682
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.

    Hat HUNTSWORTH GROUP LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 23. Mai 2014
    Geliefert am 29. Mai 2014
    Vollständig erfüllt
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 29. Mai 2014Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 21. Nov. 2018Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Deed of admission to an omnibus letter of set-off
    Erstellt am 09. Okt. 2012
    Geliefert am 19. Okt. 2012
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Okt. 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 27. Juli 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Omnibus letter of set-off
    Erstellt am 15. März 2011
    Geliefert am 18. März 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Charges by way of first charge its credit balances any sum standing to the credit of an account, whether in sterling or any other currency.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 18. März 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 19. Juni 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Deed of admission to an omnibus letter of set-off
    Erstellt am 19. Apr. 2010
    Geliefert am 22. Apr. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 22. Apr. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 28. März 2011Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte belastete Eigentum freigegeben wurde (MG04)
    • 27. Aug. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off (27 july 2007)
    Erstellt am 06. Apr. 2010
    Geliefert am 07. Apr. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. Apr. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 28. März 2011Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte belastete Eigentum freigegeben wurde (MG04)
    • 27. Aug. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 27TH july 2007 and
    Erstellt am 27. Okt. 2009
    Geliefert am 07. Nov. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. Nov. 2009Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 28. März 2011Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte belastete Eigentum freigegeben wurde (MG04)
    • 27. Aug. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Deed of admission to an omnibus letter of set-off
    Erstellt am 22. Sept. 2008
    Geliefert am 11. Okt. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. Okt. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. März 2011Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte belastete Eigentum freigegeben wurde (MG04)
    • 27. Aug. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    An omnibus letter of set-off
    Erstellt am 27. Juli 2007
    Geliefert am 10. Aug. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company or any one or more of the subsidiaries to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Aug. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. März 2011Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte belastete Eigentum freigegeben wurde (MG04)
    • 27. Aug. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 18 october 2004 and
    Erstellt am 24. Apr. 2007
    Geliefert am 15. Mai 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 15. Mai 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Aug. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 18TH october 2004 and
    Erstellt am 21. Dez. 2006
    Geliefert am 03. Jan. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 03. Jan. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Aug. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 18TH october 2004
    Erstellt am 16. Okt. 2006
    Geliefert am 20. Okt. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 20. Okt. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Aug. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 18TH october 2004 and
    Erstellt am 12. Aug. 2005
    Geliefert am 26. Aug. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Aug. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Aug. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 18 october 2004 and
    Erstellt am 27. Juli 2005
    Geliefert am 04. Aug. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of present or future accounts of the companies or any of them with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 04. Aug. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Aug. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    An omnibus letter of set-off
    Erstellt am 18. Okt. 2004
    Geliefert am 19. Okt. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any su or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank, either in sterling or any other currency.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Okt. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Aug. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of admission to an onmibus letter of set-off dated 13 july 2001
    Erstellt am 18. Mai 2004
    Geliefert am 21. Mai 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any sum or sums standing to the credit of any one or more of any accounts of the companies or any of them.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 21. Mai 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Aug. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 18. Sept. 2000
    Geliefert am 03. Okt. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Undertaking and all property and assets.
    Berechtigte Personen
    • Huntsworth PLC
    Transaktionen
    • 03. Okt. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Juni 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 18. Sept. 2000
    Geliefert am 03. Okt. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 03. Okt. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Juni 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 12. Juli 1990
    Geliefert am 20. Juli 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 20. Juli 1990Registrierung einer Belastung
    • 26. Okt. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0