KESTREL PROPERTIES LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | KESTREL PROPERTIES LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01016673 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von KESTREL PROPERTIES LIMITED?
- Kauf und Verkauf eigener Immobilien (68100) / Grundstücks- und Wohnungswesen
Wo befindet sich KESTREL PROPERTIES LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 55 Baker Street W1U 7EU London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von KESTREL PROPERTIES LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2012 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für KESTREL PROPERTIES LIMITED?
| Jahresabschluss |
|
|---|
Welche sind die letzten Einreichungen für KESTREL PROPERTIES LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | GAZ2 | |||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 21. Juli 2014 | 4 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 4 Seiten | 4.71 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * 15 Grosvenor Street London W1K 4QZ United Kingdom* am 28. Nov. 2013 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 4 Seiten | 4.70 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | RESOLUTIONS | |||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Ian Hawksworth als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Gary Yardley als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 9 vollständig | 5 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 10 vollständig | 5 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 7 vollständig | 5 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 8 vollständig | 5 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 6 vollständig | 5 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 11 vollständig | 5 Seiten | MR04 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 08. Mai 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 08. Mai 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2010 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 08. Mai 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * 40 Broadway London SW1H 0BU* am 29. Nov. 2010 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Balbinder Singh Tattar am 04. Aug. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 08. Mai 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von KESTREL PROPERTIES LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAVEY, Ruth Elizabeth | Sekretär | Broadway SW1H 0BU London 40 | British | 151481900002 | ||||||
| DAS, Soumen | Geschäftsführer | Broadway SW1H 0BU London 40 | United Kingdom | British | 150962550001 | |||||
| TATTAR, Balbinder Singh | Geschäftsführer | 40 Broadway London SW1H 0BU | England | British | 161378770001 | |||||
| BOTTLE, Jeremy Stephen | Sekretär | 39 Farnaby Road Shortlands BR1 4BL Bromley Kent | British | 14465210001 | ||||||
| FOLGER, Susan | Sekretär | 40 Broadway London SW1H 0BU | British | 68599110002 | ||||||
| ABEL, John George | Geschäftsführer | 9 Hutton Gate Hutton Mount CM13 2XA Brentwood Essex | Uk | British | 14465220002 | |||||
| BLACK, William Reginald | Geschäftsführer | Marley Side Marley Heights Kingsley Green GU27 3LU Haslemere Surrey | England | British | 41017610002 | |||||
| FISCHEL, David Andrew | Geschäftsführer | 40 Broadway London SW1H 0BU | United Kingdom | British | 8845220002 | |||||
| HAWKSWORTH, Ian David | Geschäftsführer | 40 Broadway London SW1H 0BU | United Kingdom | British | 115713550001 | |||||
| JOLLY, Brian Anthony | Geschäftsführer | 14 Links Road KT17 3PS Epsom Surrey | United Kingdom | British | 14465250001 | |||||
| MARCUCCILLI, Gary John | Geschäftsführer | 29 Manor Wood Road CR8 4LG Purley Surrey | United Kingdom | British | 65438590002 | |||||
| SAGGERS, John Ian | Geschäftsführer | Galleon House Martlesham Road Little Bealings IP13 6LX Woodbridge Suffolk | British | 35538650002 | ||||||
| SMITH, Aidan Christopher | Geschäftsführer | 50 Wavendon Avenue Chiswick W4 4NS London | United Kingdom | British | 31140320001 | |||||
| YARDLEY, Gary James | Geschäftsführer | 40 Broadway London SW1H 0BU | United Kingdom | British | 55671660002 |
Hat KESTREL PROPERTIES LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Deed of assurance and release | Erstellt am 06. Okt. 1994 Geliefert am 18. Okt. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag In favour of the law debenture trust corporation P.L.C. the principal amount of and interest on the £80,000,000 11 1/4 per cent. First mortgage debenture stock 2021 of capital and counties PLC and all other monies intended to be secured by the above deed and the existing deeds (as defined in the above deed) to which it is supplemental | |
Kurze Angaben Phase 1-4 peterborough business park lynch wood peterborough cambridgeshire together with all buildings erections and fixtures (including tenants fixtures) fixed plant & machinery and the benefit of all existing leases underleases tenencies agreements for lease rights covenants and the benefits of any contracts. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of release and substitution | Erstellt am 17. Feb. 1994 Geliefert am 22. Feb. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag And for further securing in favour of the law debenture trust corporation P.L.C. the principal amount of and interest on the £80,000,000 11 1/4 per cent.first mortgage debenture stock 2021 of capital & counties PLC and all other moneys intended to be secured by the above deed and the existing deeds (as defined in the above deed) to which it is supplemental | |
Kurze Angaben By way of first specific security the capital sum of £70,000,000 and the investments for the time being and from time to time representing the same (no such investments exist at the date hereof). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Trust deed | Erstellt am 14. März 1991 Geliefert am 02. Apr. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag The principal of and interest on sterling pounds 80,000,000 11 1/4% first mortgage debenture stock 2021 and all other moneys due or to become due from capital & counties PLC to the chargee under the trust deed. | |
Kurze Angaben Legal mortgage over the properties listed on the schedule attached to doc M395. Together with all buildings, erections & fixtures, fixed plant and all other particulars as detailed on doc M395 (see doc for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental trust deed | Erstellt am 19. Sept. 1989 Geliefert am 03. Okt. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £150,000,000 first mortgage debenture stock 2027 issued by capital and counties PLC and all other monies intended to be secured by the first supplemental trust deed this deed and the trust deed constituting and securing the above stock | |
Kurze Angaben F/H property k/a land on the east side of wickham road, fareham, hampshire together with the building thereon k/a fareham parkway title no HP231067. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Trust deed | Erstellt am 16. Mai 1988 Erworben am 11. Sept. 1989 Geliefert am 14. Feb. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £50,000,000 | |
Kurze Angaben The f/hold property k/as land on the east side of wickham road,hampshire together with the building k/as fareham parkway t/no.hp 231067. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| First supplemental trust deed | Erstellt am 01. Juni 1987 Erworben am 11. Sept. 1989 Geliefert am 14. Feb. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £100,000,000 | |
Kurze Angaben The f/hold property k/as land on the east side of wickham road,hampshire together with the building k/as fareham parkway t/no.hp 231067. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 28. Dez. 1982 Geliefert am 05. Jan. 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from capital & counties PLC to the chargee on any account whatsoever. | |
Kurze Angaben L/H - somerset house, 18-32 mansell street & 2-3 little somerset street. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 19. Okt. 1981 Geliefert am 21. Okt. 1981 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from capital & counties PLC to lloyds bank LTD on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H 18-32 mansell street and 2-3 little somerset street london title nos: ngl 324350 167485, 81374 + 357258. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge | Erstellt am 22. Dez. 1980 Geliefert am 23. Dez. 1980 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the capital & counties property company LTD to the chargee on any account whatsoever. | |
Kurze Angaben F/H 42-48 high road woodford (even nos) london E18. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge | Erstellt am 22. Dez. 1980 Geliefert am 23. Dez. 1980 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the capital & counties property company LTD to the chargee on any account whatsoever. | |
Kurze Angaben F/H hamos garage site situate at the corner of the broadway and dennis lane stanmore middlesex T. no. Mx 308253 mx 339955. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge on building agreement | Erstellt am 27. Nov. 1980 Geliefert am 16. Dez. 1980 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All the interest of the company in a building agreements d/d 3.7.79 relating to, all that land & premises situate on the west side of molesworth street in the london borough of lewisham. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat KESTREL PROPERTIES LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0