B.D.L. SYSTEMS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | B.D.L. SYSTEMS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01017495 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von B.D.L. SYSTEMS LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich B.D.L. SYSTEMS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Roke Manor Old Salisbury Lane SO51 0ZN Romsey Hampshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von B.D.L. SYSTEMS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Okt. 2022 |
Welche sind die letzten Einreichungen für B.D.L. SYSTEMS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 31. Aug. 2023
| 5 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Okt. 2022 | 3 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Jan. 2023 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Okt. 2021 | 3 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Jan. 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Okt. 2020 | 7 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Jan. 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Okt. 2019 | 8 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Jan. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Okt. 2018 | 8 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Jan. 2019 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 28. Sept. 2018 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Okt. 2017 | 8 Seiten | AA | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Michael James Flowers als Geschäftsführer am 30. Juni 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 28. Sept. 2017 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Okt. 2016 | 8 Seiten | AA | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Andrew Gregory Lewis als Direktor am 19. Jan. 2017 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Sarah Louise Ellard am 03. Jan. 2017 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Michael Edward Luedicke als Geschäftsführer am 31. Okt. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von B.D.L. SYSTEMS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELLARD, Sarah Louise | Sekretär | Old Salisbury Lane SO51 0ZN Romsey Roke Manor Hampshire | British | 43855640011 | ||||||
| ELLARD, Sarah Louise | Geschäftsführer | Old Salisbury Lane SO51 0ZN Romsey Roke Manor Hampshire | England | British | 43855640013 | |||||
| LEWIS, Andrew Gregory | Geschäftsführer | Old Salisbury Lane SO51 0ZN Romsey Roke Manor Hampshire | United Kingdom | British | 222848510001 | |||||
| DAVIES, Michael John | Sekretär | Flambards Arrowsmith Road BH21 3BE Wimborne Dorset | British | 21790880001 | ||||||
| DAVIES, Simon | Sekretär | Flambards Arrowsmith Road BH21 3BE Canford Magna Dorset | British | 97533930001 | ||||||
| BOWERS, Steven John | Geschäftsführer | Old Salisbury Lane SO51 0ZN Romsey Roke Manor Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | 176189250001 | |||||
| CLASBY, Alan Frederick | Geschäftsführer | 20 Moor Road BH18 8BB Broadstone Dorset | England | British | 20904700001 | |||||
| DAVIES, Michael John | Geschäftsführer | Flambards Arrowsmith Road BH21 3BE Wimborne Dorset | British | 21790880001 | ||||||
| DAVIES, Simon Michael | Geschäftsführer | Hightown Hill BH24 3HQ Ringwood Foulford Farm Hampshire | England | British | 97533930002 | |||||
| FLOWERS, Michael James | Geschäftsführer | Old Salisbury Lane SO51 0LZ Romsey Roke Manor Hampshire United Kingdom | United Kingdom | Australian | 188873370002 | |||||
| HELME, Michael John | Geschäftsführer | 1500 Parkway Whiteley PO15 7AF Fareham Chemring House Hampshire United Kingdom | England | British | 91910030002 | |||||
| HILL, Robert Seamus | Geschäftsführer | Cherming House 1500 Parkway Whiteley PO15 7AF Fareham Hampshire | England | British | 59194350003 | |||||
| KINLOCH, Henry, Dr | Geschäftsführer | The Manor House Newton PE13 5EL Wisbech Cambridgeshire | United Kingdom | British | 57563390001 | |||||
| LUEDICKE, Michael Edward | Geschäftsführer | Old Salisbury Lane SO51 0ZN Romsey Roke Manor Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | 172196070001 | |||||
| MCDONALD, David Alexander | Geschäftsführer | Cherming House 1500 Parkway Whiteley PO15 7AF Fareham Hampshire | United Kingdom | British | 163520170001 | |||||
| MOORE, John Jeremy, Major General Sir | Geschäftsführer | Melbourne House Bratton BA13 4RL Westbury Wiltshire | British | 7659750001 | ||||||
| PAPWORTH, Mark Harry | Geschäftsführer | Old Salisbury Lane SO51 0ZN Romsey Roke Manor Hampshire United Kingdom | England | British | 103085690002 | |||||
| PRICE, David John | Geschäftsführer | 1500 Parkway Whiteley PO15 7AF Fareham Chemring House Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | 75259760004 | |||||
| PRIDMORE, Peter Ian | Geschäftsführer | 6 Mountbatten Square Southsea PO4 9XY Portsmouth Hampshire | British | 121877680001 | ||||||
| RAYNER, Paul Adrian | Geschäftsführer | 1500 Parkway Whiteley PO15 7AF Fareham Chemring House Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | 45628680002 | |||||
| WALKER, John Robert, Sir | Geschäftsführer | 4 Telford's Yard E1W 2BQ London | British | 92672010001 | ||||||
| WILLIAMS, Steven Geoffery | Geschäftsführer | 50 Woodlea Road BN13 1BN Worthing Sussex | British | 105948690001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei B.D.L. SYSTEMS LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemring Technology Solutions Limited | 30. Juni 2016 | Old Salisbury Lane SO51 0ZN Romsey Roke Manor Hampshire United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat B.D.L. SYSTEMS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 24. Sept. 2010 Geliefert am 13. Okt. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the obligors to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 19. Nov. 2009 Geliefert am 30. Nov. 2009 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the chargors to any of the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 12. Nov. 2007 Geliefert am 20. Nov. 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the chargors to any of the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee and debenture | Erstellt am 22. Nov. 2006 Geliefert am 30. Nov. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the obligors to any of the secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 03. Apr. 2006 Geliefert am 20. Apr. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 03. Dez. 2004 Geliefert am 08. Dez. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H proerty being land at blackhill road holton heath poole dorset. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge | Erstellt am 30. Apr. 2004 Geliefert am 07. Mai 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £550,000.00 and all other monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben Land at blackhill road holton heath poole dorset t/n DT307552. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 31. Dez. 2002 Geliefert am 20. Jan. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Agreement | Erstellt am 08. Nov. 1999 Geliefert am 10. Nov. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £50,000 due or to become due from the company to the chargees | |
Kurze Angaben A debenture by way of legal charge over the assets of the company. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deposit agreement to secure own liabilities | Erstellt am 16. Aug. 1999 Geliefert am 26. Aug. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All such rights to the repayment of the deposit as the company then had under the terms upon which the deposit was made and the provisions contained in the agreement.account number 7404617. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Chattel mortgage | Erstellt am 05. Dez. 1996 Geliefert am 11. Dez. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben First fixed charge all the equipment and vehicles as follows panasonic uf 280M fax machine 03916904, peripherique 16MB upgrade thinkpad 760 01954006 69-760-160, apex clippercom V34 modem card 03714906 PCMC1A, thinkpad 760 mode cdw cdw 760DWUK, centrex KL486 d x 2-66 00673704 mtmm+kb ENHA10527 see reverse of form 395 for further details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge | Erstellt am 16. Apr. 1996 Geliefert am 24. Apr. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the indemnity (as defined in the charge) | |
Kurze Angaben Sum of up to £122000 standing or to the credit of an account designated bdl systems limited with the bank. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Counter indemnity | Erstellt am 24. Nov. 1995 Geliefert am 08. Dez. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies and obligations payable from the company to the chargee in respect of a tender bond for 480,000,000 italian lira given to centro technico genco militare by banca nazionale del lavoro pursuant to the terms of the charge | |
Kurze Angaben The sum of up to £155,000 standing in or to the credit of an account designated bdl systems limited with lloyds bank PLC. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Single debenture | Erstellt am 25. Nov. 1989 Geliefert am 04. Dez. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Counter indemnity & charge | Erstellt am 24. Jan. 1985 Geliefert am 12. Feb. 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The sum of £62,275 standing in or to be credited to a designated account and all interest due in respect thereof. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 20. Dez. 1979 Geliefert am 03. Jan. 1980 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H land and premises 14 denmark lane, wimbourne road, poole, dorset together with fixtures whatsoever. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0