P.S.E. MACHINERY LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | P.S.E. MACHINERY LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01017792 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von P.S.E. MACHINERY LIMITED?
- (7499) /
Wo befindet sich P.S.E. MACHINERY LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Hydrex House, Serbert Way Portishead BS20 7GD Bristol |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von P.S.E. MACHINERY LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| PLANT (SALES & ENGINEERING NORBURY)LIMITED | 15. Juli 1971 | 15. Juli 1971 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von P.S.E. MACHINERY LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2009 |
Welche sind die letzten Einreichungen für P.S.E. MACHINERY LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 31. Dez. 2010 bis 30. Juni 2011 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 28. Nov. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Carl Mark D'ammassa am 28. Nov. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr Alan James Jordan als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Andrew Wood als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Andrew Wood als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Ernennung von Mr Carl Mark D'ammassa als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Andrew Simcox als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 28. Nov. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2008 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288c | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288c | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2007 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2006 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 353 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 190 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von P.S.E. MACHINERY LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D'AMMASSA, Carl Mark | Geschäftsführer | Hydrex House, Serbert Way Portishead BS20 7GD Bristol | United Kingdom | British | 147037660007 | |||||
| JORDAN, Alan James | Geschäftsführer | Hydrex House, Serbert Way Portishead BS20 7GD Bristol | England | Irish | 150320720001 | |||||
| BOYD, Steven Clive | Sekretär | Martins Nest West Kington SN14 7JE Chippenham Wiltshire | British | 70337230001 | ||||||
| DAVIES, Irona Wendy | Sekretär | Woodbridge Beachley Road Tutshill NP6 7DL Chepstow Gwent | British | 2207330001 | ||||||
| HORSLER, Norman | Sekretär | 5 Ashride Crews Hill EN2 9DE Enfield Middlesex | British | 20571270001 | ||||||
| SEYMOUR, Paul Richard | Sekretär | 14 Campanula Drive Meadow Brook NP10 9JG Rogerstone Newport | British | 75293670002 | ||||||
| SIMCOX, Andrew James | Sekretär | Ashley Drive South Ashley Heath BH24 2JP Ringwood 53 Hampshire United Kingdom | British | 41023640002 | ||||||
| WOOD, Andrew Simon | Sekretär | Shaplands Stoke Bishop BS9 1AY Bristol 5 Avon United Kingdom | British | 33951380003 | ||||||
| DAVIES, Brian Thomas | Geschäftsführer | Woodbridge Rockvilla Lane Beachley Road NP6 2DR Chepstow Gwent | United Kingdom | British | 39854170001 | |||||
| GADOROS, Bela | Geschäftsführer | 63 Gaston Bridge Road TW17 8HF Shepperton Middlesex | British | 20061270001 | ||||||
| HARWIN, Desmond John | Geschäftsführer | 16 Snowdrop Copse RG18 4EJ Thatcham Berkshire | British | 50641280001 | ||||||
| HORSLER, Norman | Geschäftsführer | 5 Ashride Crews Hill EN2 9DE Enfield Middlesex | British | 20571270001 | ||||||
| SIMCOX, Andrew James | Geschäftsführer | Ashley Drive South Ashley Heath BH24 2JP Ringwood 53 Hampshire United Kingdom | England | British | 41023640002 | |||||
| WILSON, Jonathan Mark | Geschäftsführer | Springers Lodge Little Sodbury End, Chipping Sodbury BS37 6QE Bristol | United Kingdom | British | 95200410001 | |||||
| WOOD, Andrew Simon | Geschäftsführer | Shaplands Stoke Bishop BS9 1AY Bristol 5 Avon United Kingdom | United Kingdom | British | 33951380003 |
Hat P.S.E. MACHINERY LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Guarantee & debenture | Erstellt am 25. Feb. 1997 Geliefert am 17. März 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee and debenture | Erstellt am 25. Feb. 1997 Geliefert am 11. März 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag The actual contingent present and/or future obligations and liabilities of the company or any of the borrowers (as defined) to the chargee under/or pursuant to the financing documents (as defined) | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee and debenture | Erstellt am 11. Sept. 1995 Geliefert am 26. Sept. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| First legal charge | Erstellt am 08. Aug. 1988 Geliefert am 12. Aug. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/Hold property k/as oxeney thorney mill road west drayton title no mx 411472. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Single debenture | Erstellt am 26. Juli 1983 Geliefert am 12. Aug. 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies now due, or hereafter to become due, or from time to time accruing due from the company to commercial bank of the near east PLC | |
Kurze Angaben Fixed & floating charge undertaking and all property and assets present and future including goodwill & book debts uncalled capital. (See doc M33 for details). Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0