FRENCH CROISSANT COMPANY LIMITED(THE)
Überblick
| Unternehmensname | FRENCH CROISSANT COMPANY LIMITED(THE) |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01018579 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von FRENCH CROISSANT COMPANY LIMITED(THE)?
- Herstellung von Brot, Back- und Süßwaren (10710) / Verarbeitendes Gewerbe
Wo befindet sich FRENCH CROISSANT COMPANY LIMITED(THE)?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Swinton Meadows Industrial Estate Meadow Way Swinton S64 8AB Rotherham South Yorkshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von FRENCH CROISSANT COMPANY LIMITED(THE)?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2012 |
Welche sind die letzten Einreichungen für FRENCH CROISSANT COMPANY LIMITED(THE)?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||||||||||
Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 27. Sept. 2013
| 4 Seiten | SH01 | ||||||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 3 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 08. Okt. 2013
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Ernennung von Mr David William Boyes als Direktor am 01. Aug. 2013 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 03. Aug. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Peter Baker als Geschäftsführer am 30. Apr. 2013 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 5 Seiten | AA | ||||||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 03. Aug. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 5 Seiten | AA | ||||||||||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 26. Dez. 2011 bis 31. Dez. 2011 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde vom C/O Pitmans the Anchorage 34 Bridge St Reading Berks RG1 2LU United Kingdom geändert | 1 Seiten | AD02 | ||||||||||||||||||
Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse verlegt | 1 Seiten | AD03 | ||||||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 03. Aug. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2010 | 5 Seiten | AA | ||||||||||||||||||
Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse verlegt | 1 Seiten | AD03 | ||||||||||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde geändert | 1 Seiten | AD02 | ||||||||||||||||||
Ernennung von Pitsec Limited als Sekretär | 2 Seiten | AP04 | ||||||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Halliwells Secretaries Limited als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 03. Aug. 2010 | 15 Seiten | AR01 | ||||||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von FRENCH CROISSANT COMPANY LIMITED(THE)?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PITSEC LIMITED | Sekretär | Castle St RG1 7SR Reading 47 Berks United Kingdom |
| 38734010001 | ||||||||||
| BOYES, David William | Geschäftsführer | Meadow Way Swinton S64 8AB Rotherham Swinton Meadows Industrial Estate South Yorkshire | England | British | 180413110001 | |||||||||
| IRWIN, Clifford Edward | Geschäftsführer | South Haining Brockenhurst Road SL5 9HB Ascot Berkshire | England | British | 80267740001 | |||||||||
| LAN, Richard | Geschäftsführer | 80 Westminster Road 17928 Chatham New Jersey | Usa | American | 86052300001 | |||||||||
| BELLEINI, Brian John | Sekretär | 3 Bramley Way Whittington WS14 9SB Lichfield Staffordshire | British | 6230250003 | ||||||||||
| GARAVAN, Charles | Sekretär | Curragrean IRISH Galway Ireland | Irish | 52207090001 | ||||||||||
| POCQ ST JEAN, Felicity Caroline | Sekretär | Woodford House 44 Fairmile Lane KT11 Cobham Surrey | British | 12673540001 | ||||||||||
| HBJGW MANCHESTER SECRETARIES LIMITED | Sekretär | 3 Hardman Square Spinningfields M3 3EB Manchester | 113594300007 | |||||||||||
| BAKER, Peter | Geschäftsführer | 12 Tallow Road TW8 8EU Brentford Middlesex | United Kingdom | British | 112123100001 | |||||||||
| BELLEINI, Brian John | Geschäftsführer | 3 Bramley Way Whittington WS14 9SB Lichfield Staffordshire | British | 6230250003 | ||||||||||
| BRIDSON, John | Geschäftsführer | 18a Bridge Park Ivypark PL21 0AT Plymouth Devon | British | 47307550005 | ||||||||||
| CLARK, Matthew | Geschäftsführer | 4 Adcroft Piece Stapleford CB2 5FD Cambridge | British | 62828780002 | ||||||||||
| CLARKE, Paul Lee | Geschäftsführer | The Willows Went Edge Road Kirk Smeaton WF8 3JS Pontefract West Yorkshire | England | British | 114683580001 | |||||||||
| COWLING, Colin Richard, Director | Geschäftsführer | 18 The Glade Escrick YO19 6JH York | United Kingdom | British | 96639130001 | |||||||||
| GARAVAN, Charles | Geschäftsführer | Curragrean IRISH Galway Ireland | Ireland | Irish | 52207090001 | |||||||||
| HORSMAN, Nigel Anthony | Geschäftsführer | 24 Fosbrook Drive Castle Donington DE74 2UW Derby Derbyshire | British | 38626840001 | ||||||||||
| JONES, David Eurfyl | Geschäftsführer | Greenacres 7 Keepers Lane Codsall WV8 2DP Wolverhampton West Midlands | British | 10978940002 | ||||||||||
| LISTER, John Richard Arkwright | Geschäftsführer | Shipton Mill Long Newnton GL8 8RP Tetbury Gloucestershire | England | British | 18046460001 | |||||||||
| MAYCOCK, Peter Granville | Geschäftsführer | 95 Thorpe Road PE3 6JQ Peterborough Cambridgeshire | United Kingdom | British | 53723130003 | |||||||||
| POCQ ST JEAN, Felicity Caroline | Geschäftsführer | Woodford House 44 Fairmile Lane KT11 Cobham Surrey | British | 12673540001 | ||||||||||
| POCQ ST JEAN, Serge Jacques Jean | Geschäftsführer | Woodford House 44 Fairmile Lane KT11 Cobham Surrey | French | 12673550001 | ||||||||||
| PRICE, Jonathan | Geschäftsführer | 14 The Crescent B92 0BP Hampton In Arden West Midlands | British | 111512800001 | ||||||||||
| PRICE, Martin Raymond | Geschäftsführer | Basse Croft Henley Road Claverdon CV35 8PS Warwick Warwickshire | British | 10978960001 |
Hat FRENCH CROISSANT COMPANY LIMITED(THE) Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 04. Juli 2006 Geliefert am 12. Juli 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All the book and other debts revenues and claims the proceeds of insurance. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Assignment | Erstellt am 28. Juli 2004 Geliefert am 13. Aug. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £381,649.72 due from william price and sons limited to the chargee | |
Kurze Angaben All right title and interest to repayment from the inland revenue of corporation tax paid in respect of a prebs scheme. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 31. März 2004 Geliefert am 15. Apr. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All the book debts of the company. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Chattel mortgage | Erstellt am 11. März 2004 Geliefert am 18. März 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The mortgaged chattels, the benefit of any guarantee, warranty or to the obligation in relation to the mortgaged chattels.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 11. März 2004 Geliefert am 18. März 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Equipment mortgage | Erstellt am 04. Aug. 1998 Geliefert am 05. Aug. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben For details of equipment charged please refer to form M395.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture containing fixed and floating charges | Erstellt am 31. Juli 1998 Geliefert am 05. Aug. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Single debenture | Erstellt am 31. Aug. 1984 Geliefert am 10. Sept. 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 30. Jan. 1984 Geliefert am 31. Jan. 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H property known as shop no 3, part of unit 2 by the road, willesden title no ngl 179550 together with all fixtures (including trade fixtures) fixed plant & machinery present & future upon the above premises. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Single debenture | Erstellt am 30. Nov. 1982 Geliefert am 08. Dez. 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed & floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including book debts goodwill & uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0