BEDFORDSHIRE NEWSPAPERS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | BEDFORDSHIRE NEWSPAPERS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01021920 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von BEDFORDSHIRE NEWSPAPERS LIMITED?
- Zeitungsverlag (58130) / Information und Kommunikation
Wo befindet sich BEDFORDSHIRE NEWSPAPERS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 6 Snow Hill EC1A 2AY City Of London London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von BEDFORDSHIRE NEWSPAPERS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| UNIQUE NEWSPAPERS LIMITED | 19. Juli 1996 | 19. Juli 1996 |
| EMAP UNIQUE NEWSPAPERS LIMITED | 20. Juni 1994 | 20. Juni 1994 |
| TOWN CRIER LIMITED | 16. Apr. 1985 | 16. Apr. 1985 |
| ADPOWER PROMOTIONS LIMITED | 23. Aug. 1971 | 23. Aug. 1971 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BEDFORDSHIRE NEWSPAPERS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Dez. 2017 |
Welche sind die letzten Einreichungen für BEDFORDSHIRE NEWSPAPERS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation | 10 Seiten | LIQ14 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von David John King als Geschäftsführer am 31. Dez. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Peter Michael Mccall als Sekretär am 31. Dez. 2019 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Unex House - Suite B Bourges Boulevard Peterborough Cambridgeshire PE1 1NG zum 6 Snow Hill City of London London EC1A 2AY am 08. Apr. 2019 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||
Vermögensübersicht | 10 Seiten | LIQ02 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Dez. 2017 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 23. Juli 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Ashley Gilroy Mark Highfield als Geschäftsführer am 05. Juni 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 26. Juli 2017 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 02. Jan. 2016 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 02. Aug. 2016 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 02. Aug. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 11-13 Mill Street Bedford Bedfordshire MK40 3EU zum Unex House - Suite B Bourges Boulevard Peterborough Cambridgeshire PE1 1NG am 06. Aug. 2015 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 03. Jan. 2015 | 9 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 28. Dez. 2013 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr David John King am 01. Juli 2014 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Ashley Gilroy Mark Highfield am 01. Juli 2014 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Mr Peter Michael Mccall am 01. Juli 2014 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 02. Aug. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 29. Dez. 2012 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 02. Aug. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von BEDFORDSHIRE NEWSPAPERS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBOTT, Jane Dorothy | Sekretär | Sawatdi East Road PE8 4BX Oundle Northhampshire | British | 102874790001 | ||||||
| HARRIS, Christopher Ian | Sekretär | 6 Baker Court Thrapston NN14 4XA Kettering Northamptonshire | British | 53420880002 | ||||||
| LISLE, Vincent Thomas | Sekretär | 5 Otters Holt Durkar WF4 3QE Wakefield West Yorkshire | British | 88104040001 | ||||||
| MCCALL, Peter Michael | Sekretär | Orchard Brae House, 30 Queensferry Road EH4 2HS Edinburgh 8th Floor Scotland | 158805550001 | |||||||
| PATRICK, David John | Sekretär | 21 East Street NN1 5JZ Northampton | British | 119390850002 | ||||||
| STEELE, Toby Andrew Murray | Sekretär | 62 Dynevor Close Bromham MK43 8UD Bedford Bedfordshire | British | 91907510001 | ||||||
| VALDERAZ, Anne | Sekretär | 37 Manor Lane Alconbury PE17 5EH Huntingdon Cambridgeshire | British | 48965240001 | ||||||
| WALMSLEY, Derek Kerr | Sekretär | Sennen Grange Road MK43 7EU Felmersham North Bedfordshire | British | 16754910001 | ||||||
| YEOMANS, Graham Arthur | Sekretär | 13 Beagle Ridge Drive Acomb YO2 3JH York North Yorkshire | British | 602760001 | ||||||
| ALLEN, Frederick John | Geschäftsführer | 6 Glebe Close Horringer IP29 5PR Bury St Edmunds Suffolk | British | 30121880001 | ||||||
| BAILLIE, John Andrew Main | Geschäftsführer | Yew Cottage Main Road, Uffington PE9 4SN Stamford Lincolnshire | British | 76483990001 | ||||||
| BOWDLER, Timothy John | Geschäftsführer | 2-11 St Vincent Place EH3 5BQ Edinburgh | United Kingdom | British | 37521870002 | |||||
| CAMMIADE, Danny | Geschäftsführer | Holyrood Road EH8 8AS Edinburgh 108 Scotland | England | British | 251394160001 | |||||
| CHIAPPELLI, Marco Luigi Autimio | Geschäftsführer | 21 Braid Farm Road EH10 6LE Edinburgh | Scotland | British | 474360001 | |||||
| CLARK, Stephen Robert | Geschäftsführer | 114 Hillesden Avenue Elstow MK42 9AJ Bedford Bedfordshire | British | 60851690002 | ||||||
| ELLIS, Michael John | Geschäftsführer | 40 King Street Somersham PE17 3EJ Huntingdon Cambridgeshire | England | British | 178022450001 | |||||
| EVANS, Michael Joseph | Geschäftsführer | The Manor House 59 Church Street Nassington PE8 6QG Peterborough Cambridgeshire | England | British | 30037370001 | |||||
| FEETHAM, Robert Anthony | Geschäftsführer | 4 The Charters Uffington PE9 4UD Stamford Lincolnshire | England | British | 64401770001 | |||||
| FRY, John Anthony | Geschäftsführer | Church Hill NR15 1TD Saxlingham Nethergate Old Rectory Norfolk Uk | England | British | 136914890001 | |||||
| HARRIS, Christopher Ian | Geschäftsführer | 31 Kettering Road Isham NN14 1HQ Kettering Northamptonshire | British | 53420880003 | ||||||
| HIGHFIELD, Ashley Gilroy Mark | Geschäftsführer | Orchard Brae House 30 Queensferry Road EH4 2HS Edinburgh 8th Floor Scotland | United Kingdom | British | 164400440001 | |||||
| JOHNSTON, Frederick Patrick Mair | Geschäftsführer | 1 Grange Terrace EH9 2LD Edinburgh | British | 328390001 | ||||||
| JOHNSTON, Michael Frederick | Geschäftsführer | 19 Webster Gardens W5 5NA London | British | 64615750001 | ||||||
| KING, David John | Geschäftsführer | Orchard Brae House 30 Queensferry Road EH4 2HS Edinburgh 8th Floor Scotland | United Kingdom | British | 179020430001 | |||||
| LANKESTER, David Robin Archibald | Geschäftsführer | 11 Bath Row PE9 2QU Stamford Lincolnshire | British | 49804010002 | ||||||
| LAWLER, Thomas Philip | Geschäftsführer | Glenlair Cottage 15 Nab Lane BD18 4EH Shipley West Yorkshire | British | 7475760001 | ||||||
| MURRAY, Grant | Geschäftsführer | Holyrood Road EH8 8AS Edinburgh 108 Scotland | United Kingdom | British | 159877110001 | |||||
| NIZOL, David Frederick | Geschäftsführer | 18 Hallam Close CM15 0NW Brentwood Essex | British | 109032760001 | ||||||
| PATERSON, Stuart Randall | Geschäftsführer | 41 Fernielaw Avenue EH13 0EF Edinburgh Midlothian | Scotland | British | 64281400001 | |||||
| RATCLIFFE, Neil Anthony | Geschäftsführer | Red Oaks Mill Road Lower Shiplake RG9 3LN Henley On Thames Oxfordshire | United Kingdom | British | 122955650001 | |||||
| RICHARDSON, Michael Robert | Geschäftsführer | 4 Saint Marys Close Felmersham MK43 7JP Bedford Bedfordshire | England-Uk | British | 74383790001 | |||||
| TOULMIN, George Michael | Geschäftsführer | The West Wing Thorp Arch Hall LS23 7AW Wetherby West Yorkshire | British | 9253330001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei BEDFORDSHIRE NEWSPAPERS LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johnston Press Plc | 06. Apr. 2016 | 30 Queensferry Road EH4 2HS Edinburgh Orchard Brae House Scotland | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat BEDFORDSHIRE NEWSPAPERS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 01. Juli 1996 Geliefert am 19. Juli 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the facility agreement, the other finance documents, the rbs facilities, the bridging facility and the rbs guarantee and/or any deed or document supplemental thereto, whether actual, contingent, sole, joint and/or several or otherwise, including, without limitation, all obligations to indemnify the chargee (the "secured obligations") | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 18. Apr. 1983 Geliefert am 07. Mai 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben (Please see doc M22). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge | Erstellt am 16. Okt. 1981 Geliefert am 29. Okt. 1981 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All book debts & other debts due, owing or incurred to the company present & future. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 12. Dez. 1980 Geliefert am 18. Dez. 1980 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H lands & premises being the old court house, priory road, st. Ives, cambridgeshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 09. Feb. 1978 Geliefert am 21. Feb. 1978 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H lands and premises being:- 83 victoria rd, new chesterton, cambridgeshire, together with all fixtures. Title no:- GB 8203. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 17. Aug. 1977 Geliefert am 24. Aug. 1977 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Floating charge (see doc M18 for details). Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat BEDFORDSHIRE NEWSPAPERS LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gläubiger-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0