JJB SPORTS PLC

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameJJB SPORTS PLC
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformAktiengesellschaft
    Unternehmensnummer 01024895
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von JJB SPORTS PLC?

    • Einzelhandel mit Sportartikeln, Angelgeräten, Campingartikeln, Booten und Fahrrädern (47640) / Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen
    • Einzelhandel mit Bekleidung in spezialisierten Geschäften (47710) / Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen
    • Einzelhandel mit Schuhen in spezialisierten Geschäften (47721) / Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen
    • Einzelhandel mit Lederwaren in spezialisierten Geschäften (47722) / Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen

    Wo befindet sich JJB SPORTS PLC?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Kpmg Llp
    1 St Peter'S Square
    M2 3AE Manchester
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von JJB SPORTS PLC?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis29. Jan. 2012

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für JJB SPORTS PLC?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für JJB SPORTS PLC?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Verzichtserklärung auf herrenlose Güter

    1 SeitenBONA

    Verzichtserklärung auf herrenlose Güter

    1 SeitenBONA

    Verzichtserklärung auf herrenlose Güter

    1 SeitenBONA

    Verzichtserklärung auf herrenlose Güter

    1 SeitenBONA

    Verzichtserklärung auf herrenlose Güter

    1 SeitenBONA

    Verzichtserklärung auf herrenlose Güter

    1 SeitenBONA

    Verzichtserklärung auf herrenlose Güter

    1 SeitenBONA

    Verzichtserklärung auf herrenlose Güter

    1 SeitenBONA

    Verzichtserklärung auf herrenlose Güter

    1 SeitenBONA

    Verzichtserklärung auf herrenlose Güter

    1 SeitenBONA

    Verzichtserklärung auf herrenlose Güter

    1 SeitenBONA

    Verzichtserklärung auf herrenlose Güter

    1 SeitenBONA

    Verzichtserklärung auf herrenlose Güter

    1 SeitenBONA

    Verzichtserklärung auf herrenlose Güter

    1 SeitenBONA

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 25. Sept. 2015

    25 Seiten2.24B

    Mitteilung über den Übergang von der Verwaltung zur Auflösung am 25. Sept. 2015

    25 Seiten2.35B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 02. Juli 2015

    24 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 02. Jan. 2014

    24 Seiten2.24B

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Kpmg Llp 1 St Peter's Square Manchester M2 3AE zum Kpmg Llp 1 St Peter's Square Manchester M2 3AE am 29. Jan. 2015

    2 SeitenAD01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Kpmg Llp Kpmg Llp St. James's Square Manchester Lancashire M2 6DS zum Kpmg Llp 1 St Peter's Square Manchester M2 3AE am 29. Jan. 2015

    2 SeitenAD01

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 02. Juli 2014

    27 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 02. Jan. 2014

    25 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 02. Juli 2013

    27 Seiten2.24B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B

    Wer sind die Geschäftsführer von JJB SPORTS PLC?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    WILLIAMS, David Robert
    1 St Peter's Square
    M2 3AE Manchester
    Kpmg Llp
    Sekretär
    1 St Peter's Square
    M2 3AE Manchester
    Kpmg Llp
    161503180001
    ADAMS, David Alexander Robertson
    Three Elm Lane
    TN11 0AB Tonbridge
    Applegarth
    Kent
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Three Elm Lane
    TN11 0AB Tonbridge
    Applegarth
    Kent
    United Kingdom
    EnglandBritish55757700003
    BERNSTEIN, Richard Philip
    1 St Peter's Square
    M2 3AE Manchester
    Kpmg Llp
    Geschäftsführer
    1 St Peter's Square
    M2 3AE Manchester
    Kpmg Llp
    EnglandBritish3324230004
    CHRISTENSEN, Lawrence Richard
    1 St Peter's Square
    M2 3AE Manchester
    Kpmg Llp
    Geschäftsführer
    1 St Peter's Square
    M2 3AE Manchester
    Kpmg Llp
    United KingdomBritish171869320001
    CORLISS, Robert James
    1 St Peter's Square
    M2 3AE Manchester
    Kpmg Llp
    Geschäftsführer
    1 St Peter's Square
    M2 3AE Manchester
    Kpmg Llp
    UsaAmerican170571310001
    MCTIGHE, Michael
    1 St Peter's Square
    M2 3AE Manchester
    Kpmg Llp
    Geschäftsführer
    1 St Peter's Square
    M2 3AE Manchester
    Kpmg Llp
    United KingdomBritish156709120001
    PINSENT, Matthew Clive, Sir
    1 St Peter's Square
    M2 3AE Manchester
    Kpmg Llp
    Geschäftsführer
    1 St Peter's Square
    M2 3AE Manchester
    Kpmg Llp
    United KingdomBritish148640400001
    WILLIAMS, David Robert
    1 St Peter's Square
    M2 3AE Manchester
    Kpmg Llp
    Geschäftsführer
    1 St Peter's Square
    M2 3AE Manchester
    Kpmg Llp
    United KingdomBritish157062220001
    ASHBY, Jonathan
    Hinckley Court
    CW12 4WE Congleton
    1
    Cheshire
    Sekretär
    Hinckley Court
    CW12 4WE Congleton
    1
    Cheshire
    British134682180001
    GREENWOOD, John David
    1 Brookside
    Euxton
    PR7 6HR Chorley
    Lancashire
    Sekretär
    1 Brookside
    Euxton
    PR7 6HR Chorley
    Lancashire
    British4527320003
    MADELEY, David Phillip
    Mill Lane
    WA15 0RD Ashley
    One Castle Mill
    Cheshire
    Sekretär
    Mill Lane
    WA15 0RD Ashley
    One Castle Mill
    Cheshire
    British128847520001
    MANNING, Richard Denley John
    Challenge Way
    Martland Park
    WN5 0LD Wigan
    Lancashire
    Sekretär
    Challenge Way
    Martland Park
    WN5 0LD Wigan
    Lancashire
    British77961690001
    BEEVER, David Milton Maxwell
    Warren Farm House
    South Drive
    GU25 4JS Wentworth
    Surrey
    Geschäftsführer
    Warren Farm House
    South Drive
    GU25 4JS Wentworth
    Surrey
    United KingdomBritish35274610001
    BENZIE, Alan Athol Emslie
    Oakbarn, Higher House Farm
    Hocker Lane
    SK10 4SD Over Alderley
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Oakbarn, Higher House Farm
    Hocker Lane
    SK10 4SD Over Alderley
    Cheshire
    EnglandBritish83412170001
    BEST, Roger Clive
    Stanner House
    Grimsargh
    PR2 5JE Preston
    Geschäftsführer
    Stanner House
    Grimsargh
    PR2 5JE Preston
    EnglandBritish114728210001
    CLARE, John Charles
    The Cottage Pinkneys Drive
    SL6 6QD Pinkneys Green
    Berkshire
    Geschäftsführer
    The Cottage Pinkneys Drive
    SL6 6QD Pinkneys Green
    Berkshire
    EnglandBritish16875650001
    COPPOCK, Lawrence Patrick
    The Close
    Church Lane
    SO51 0QH Braishfield
    Hampshire
    Geschäftsführer
    The Close
    Church Lane
    SO51 0QH Braishfield
    Hampshire
    EnglandUnited Kingdom152718990001
    DUNN, Barry John Keith
    The Farm House
    Back Lane Heath Charnock
    PR6 9DJ Chorley
    Geschäftsführer
    The Farm House
    Back Lane Heath Charnock
    PR6 9DJ Chorley
    United KingdomBritish60493690005
    FOSTER, George William
    9 Richmond Green
    Richmond Road
    WA14 2UB Bowdon
    Cheshire
    Geschäftsführer
    9 Richmond Green
    Richmond Road
    WA14 2UB Bowdon
    Cheshire
    United KingdomBritish106832100001
    GREENWOOD, John David
    1 Brookside
    Euxton
    PR7 6HR Chorley
    Lancashire
    Geschäftsführer
    1 Brookside
    Euxton
    PR7 6HR Chorley
    Lancashire
    United KingdomBritish4527320003
    HUNTER, Thomas Blane, Sir
    Ladykirk House
    Ladykirk Estate
    KA9 2SF Monkton
    Geschäftsführer
    Ladykirk House
    Ladykirk Estate
    KA9 2SF Monkton
    United KingdomBritish97904280003
    JONES, David Charles, Sir
    Whinbrae Wheatley Lane
    Ben Rhydding
    LS29 8SF Ilkley
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Whinbrae Wheatley Lane
    Ben Rhydding
    LS29 8SF Ilkley
    West Yorkshire
    EnglandBritish11515940001
    JONES, Keith John
    Challenge Way
    Martland Park
    WN5 0LD Wigan
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Challenge Way
    Martland Park
    WN5 0LD Wigan
    Lancashire
    United KingdomBritish161521440001
    KNIGHT, Thomas William
    Flat 5 Eastfield House
    15 Moor Road South
    NE3 1ND Gosforth
    Geschäftsführer
    Flat 5 Eastfield House
    15 Moor Road South
    NE3 1ND Gosforth
    British11423040008
    LANE SMITH, Roger
    Bradford Lane
    Nether Alderley
    SK10 4TR Macclesfield
    Bradford Lane Farm
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Bradford Lane
    Nether Alderley
    SK10 4TR Macclesfield
    Bradford Lane Farm
    Cheshire
    United KingdomBritish109062130002
    MADELEY, David Phillip
    Mill Lane
    WA15 0RD Ashley
    One Castle Mill
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Mill Lane
    WA15 0RD Ashley
    One Castle Mill
    Cheshire
    EnglandBritish128847520001
    MANNING, Richard Denley John
    Challenge Way
    Martland Park
    WN5 0LD Wigan
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Challenge Way
    Martland Park
    WN5 0LD Wigan
    Lancashire
    EnglandBritish77961690002
    RIGBY, Mary
    Greystone Farm 1 Hall Lane
    Parbold
    WN8 7BD Wigan
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Greystone Farm 1 Hall Lane
    Parbold
    WN8 7BD Wigan
    Lancashire
    British28471030002
    RONNIE, Christopher
    Grove House
    83 Knutsford Road
    SK9 6JH Wilmslow
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Grove House
    83 Knutsford Road
    SK9 6JH Wilmslow
    Cheshire
    EnglandScottish79360390002
    SHARPE, Duncan James
    Waddington Old Hall Clitheroe Road
    Waddington
    BB7 3HP Clitheroe
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Waddington Old Hall Clitheroe Road
    Waddington
    BB7 3HP Clitheroe
    Lancashire
    British13873080002
    THOMAS, Andrew Gerald
    Greenlands
    Forest Road, Little Budworth
    CW6 9ES Tarporley
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Greenlands
    Forest Road, Little Budworth
    CW6 9ES Tarporley
    Cheshire
    British2024880001
    TRANTER, Colin Albert
    Off Sandy Lane
    Lower Peover
    WA16 9JF Knutsford
    Woodside Cottage
    Cheshire
    Uk
    Geschäftsführer
    Off Sandy Lane
    Lower Peover
    WA16 9JF Knutsford
    Woodside Cottage
    Cheshire
    Uk
    United KingdomBritish138755910001
    WAUDBY, Roy
    Western 12 Packman Lane
    Kirkella
    HU10 7TL Hull
    North Humberside
    Geschäftsführer
    Western 12 Packman Lane
    Kirkella
    HU10 7TL Hull
    North Humberside
    British8652040001
    WHELAN, David
    The Manor House
    Miry Lane Parbold
    WN8 7TA Wigan
    Lancashire
    Geschäftsführer
    The Manor House
    Miry Lane Parbold
    WN8 7TA Wigan
    Lancashire
    United KingdomBritish4527330001
    WILLIAMS, Peter Wodehouse
    Rayners Road
    SW15 2AY London
    3
    Geschäftsführer
    Rayners Road
    SW15 2AY London
    3
    EnglandBritish135547730001

    Hat JJB SPORTS PLC Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 27. Apr. 2012
    Geliefert am 04. Mai 2012
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and from each other chargor (except as guarantor for the company) to each finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H land on the south west side of challenge way, wigan, t/no: GM718947; f/h land and buildings lying to the south of challenge way, wigan; and f/h land and buildings lying on the south side of challenge way, wigan, t/no:GM811303 (for details of all other property charged, please refer to the MG01 document) fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC (As Security Agent for the Finance Parties)
    Transaktionen
    • 04. Mai 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 04. Okt. 2012Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte belastete Eigentum freigegeben wurde (MG04)
    • 09. Okt. 2012Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte belastete Eigentum freigegeben wurde (MG04)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 03. Juni 2009
    Geliefert am 17. Juni 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and each other chargor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery (for details of properties charged please refer to the form 395). see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 17. Juni 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Okt. 2012Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte belastete Eigentum freigegeben wurde (MG04)
    • 09. Okt. 2012Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte belastete Eigentum freigegeben wurde (MG04)
    A charge over an account
    Erstellt am 03. Juni 2009
    Geliefert am 12. Juni 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    With full title guarantee charged by way of first fixed charge all of the rights, title and interest from time totime in and to each charged asset see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. Juni 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Dez. 2009Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte belastete Eigentum freigegeben wurde (MG04)
    • 17. Feb. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Account charge
    Erstellt am 17. Dez. 2008
    Geliefert am 24. Dez. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the secured parties on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All of the chargor's rights,title and interest from time to time in and to each charged asset see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC as Agent and Trustee for Itself and Bank of Scotland PLC and Kaupthing Singer & Friedlander Limited
    Transaktionen
    • 24. Dez. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Juli 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 06. Okt. 2008
    Geliefert am 11. Okt. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Kaupthing Singer & Friedlander Limited
    Transaktionen
    • 11. Okt. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Juli 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 26. Sept. 2008
    Geliefert am 02. Okt. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 02. Okt. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Dez. 2009Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte belastete Eigentum freigegeben wurde (MG04)
    • 17. Feb. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 26. Sept. 2008
    Geliefert am 29. Sept. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the chargors to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 29. Sept. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Okt. 2012Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte belastete Eigentum freigegeben wurde (MG04)
    • 09. Okt. 2012Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte belastete Eigentum freigegeben wurde (MG04)
    Mortgage of bank account as amended by supplemental deed
    Erstellt am 13. Juni 2005
    Geliefert am 23. Juni 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All its right title and interest in and to the deposit, the account numbered 611079 and agreement dated 26 february 2001. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Thomas Blane Hunter, James Cairns Mcmahon and Robert Mcdougall Glennie, as Trustees of the Tbhunter Trust for Children
    Transaktionen
    • 23. Juni 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Feb. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Mortgage of bank account as amended by supplemental deed
    Erstellt am 13. Juni 2005
    Geliefert am 23. Juni 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All its right title and interest in and to the deposit, the account numbered 611061 and agreement dated 26 february 2001. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Thomas Blane Hunter and James Cairns Mcmahon as Partners in the Firm of Westcoast Capital
    Transaktionen
    • 23. Juni 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Feb. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Mortgage of bank account as amended by supplemental deed
    Erstellt am 13. Juni 2005
    Geliefert am 23. Juni 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All its right title and interest in and to the deposit, the account numbered 611053 and agreement dated 26 february 2001. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Thomas Blane Hunter and James Cairns Mcmahon as Partners in the Firm of Westcoast Capital
    Transaktionen
    • 23. Juni 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Feb. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Mortgage of bank account as amended by supplemental deed
    Erstellt am 13. Juni 2005
    Geliefert am 23. Juni 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All its right title and interest in and to the deposit, the account numbered 611020 and agreement dated 26 february 2001. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Thomas Blane Hunter and James Cairns Mcmahon as Partners in the Firm of Westcoast Capital
    Transaktionen
    • 23. Juni 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Feb. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Mortgage of bank account as amended by supplemental deed
    Erstellt am 13. Juni 2005
    Geliefert am 23. Juni 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All its right title and interest in and to the deposit, the account numbered 611038 and agreement dated 26 february 2001. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Thomas Blane Hunter
    Transaktionen
    • 23. Juni 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Feb. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Mortgage of bank account as amended by supplemental deed
    Erstellt am 13. Juni 2005
    Geliefert am 23. Juni 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All its right title and interest in and to the deposit, the account numbered 611046 and agreement dated 26 february 2001. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Thomas Blane Hunter
    Transaktionen
    • 23. Juni 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Feb. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Mortgage of bank account
    Erstellt am 26. Feb. 2001
    Geliefert am 03. März 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys, obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee under the loan note instrument in respect of the mortgage notes (as defined)
    Kurze Angaben
    All its right, title and interest in and to the deposit (as defined). See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Thomas Blane Hunter
    Transaktionen
    • 03. März 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Feb. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Mortgage of bank account
    Erstellt am 26. Feb. 2001
    Geliefert am 03. März 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys, obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee under the loan note instrument in respect of the mortgage notes (as defined)
    Kurze Angaben
    All its right, title and interest in and to the deposit (as defined). See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Thomas Blane Hunter
    Transaktionen
    • 03. März 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Feb. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Mortgage of bank account
    Erstellt am 26. Feb. 2001
    Geliefert am 03. März 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys, obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee under the loan note instrument in respect of the mortgage notes (as defined)
    Kurze Angaben
    All its right, title and interest in and to the deposit (as defined). See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Thomas Blane Hunter, Marion Agnes Hunter and Robert Mcdougall Glennieas Trustees of the Tb Hunter's Charitable Trust
    Transaktionen
    • 03. März 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Feb. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Mortgage of bank account
    Erstellt am 26. Feb. 2001
    Geliefert am 03. März 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys, obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee under the loan note instrument in respect of the mortgage notes (as defined)
    Kurze Angaben
    All its right, title and interest in and to the deposit (as defined). See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Thomas Blane Hunter and Robert Mcdougall Glennie as Trustees of the Tb Hunter Trust Forchildren
    Transaktionen
    • 03. März 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Feb. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Mortgage of bank account
    Erstellt am 26. Feb. 2001
    Geliefert am 03. März 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys, obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee under the loan note instrument in respect of the mortgage notes (as defined)
    Kurze Angaben
    All its right, title and interest in and to the deposit (as defined). See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Thomas Blane Hunter and James Cairns Mcmahon as Partners in the Firm of Westcoast Capital
    Transaktionen
    • 03. März 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Feb. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Mortgage of bank account
    Erstellt am 26. Feb. 2001
    Geliefert am 03. März 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys, obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee under the loan note instrument in respect of the mortgage notes (as defined)
    Kurze Angaben
    All its right, title and interest in and to the deposit (as defined). See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Thomas Blane Hunter and James Cairns Mcmahon as Partners in the Firm of Westcoast Capital
    Transaktionen
    • 03. März 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Feb. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Mortgage of bank account
    Erstellt am 26. Feb. 2001
    Geliefert am 03. März 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys, obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee under the loan note instrument in respect of the mortgage notes (as defined)
    Kurze Angaben
    All its right, title and interest in and to the deposit (as defined). See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Thomas Blane Hunter and James Cairns Mcmahon as Partners in the Firm of Westcoast Capital
    Transaktionen
    • 03. März 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Feb. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Security deposit agreement
    Erstellt am 11. Sept. 1998
    Geliefert am 16. Sept. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the counter-indemnity and under the security deposit agreement
    Kurze Angaben
    The deposit and all rights and benefits accruing or arising in connection therewith. Deposit means the amount credited to the account from time to time in sterling (initially being the sum of £170,478,001) including all interest credited thereto.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Ubs Ag
    Transaktionen
    • 16. Sept. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. März 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 12. Nov. 1993
    Geliefert am 19. Nov. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land and buildings on the north side of leopold street, wigan, greater manchester t/no gm 347289.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Nov. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Sept. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 20. Mai 1993
    Geliefert am 03. Juni 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land and buildings west of wallgate wigan gtr manchester t/n GM167976.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 03. Juni 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Okt. 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 13. Okt. 1992
    Geliefert am 23. Okt. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    54 and 56 wallgate wigan greater manchester title no: GM150634.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. Okt. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Okt. 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 12. Juni 1992
    Geliefert am 22. Juni 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    36 & 38 whitechapel & 25-31 (odd) williamson street liverpool merseyside t/no ms 332264.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 22. Juni 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Sept. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat JJB SPORTS PLC Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    30. Apr. 2009Datum der Sitzung zur Genehmigung des CVA
    16. Juni 2010Datum des Abschlusses oder der Beendigung des CVA
    Freiwillige Unternehmenssanierung (CVA)
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Richard Dixon Fleming
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praktiker
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    2
    DatumTyp
    22. März 2011Datum der Sitzung zur Genehmigung des CVA
    01. Okt. 2012Datum des Abschlusses oder der Beendigung des CVA
    Freiwillige Unternehmenssanierung (CVA)
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Brian Green
    Kpmg Llp
    St James' Square
    M2 6DS Manchester
    Praktiker
    Kpmg Llp
    St James' Square
    M2 6DS Manchester
    3
    DatumTyp
    01. Okt. 2012Beginn der Verwaltung
    25. Sept. 2015Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Richard Dixon Fleming
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praktiker
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Brian Green
    Kpmg Llp
    St James' Square
    M2 6DS Manchester
    Praktiker
    Kpmg Llp
    St James' Square
    M2 6DS Manchester
    David James Costley-Wood
    Kpmg Llp
    St James Square
    M2 6DS Manchester
    Praktiker
    Kpmg Llp
    St James Square
    M2 6DS Manchester

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0