JNL LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameJNL LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01028914
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von JNL LIMITED?

    • (7499) /

    Wo befindet sich JNL LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    James Street West
    Green Park
    BA1 2BU Bath
    Avon
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von JNL LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    JOHNSONS NEWS LIMITED24. Okt. 198824. Okt. 1988
    JOHNSONS WHOLESALE NEWS LIMITED 17. Juni 198617. Juni 1986
    JOHNSONS NEWS GROUP LIMITED28. Juni 198528. Juni 1985
    JOHNSONS CENTRAL NEWSAGENCY LIMITED27. Okt. 197127. Okt. 1971

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von JNL LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Juni 2010

    Welche sind die letzten Einreichungen für JNL LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Beendigung der Liquidation

    1 SeitenL64.07

    Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung

    2 SeitenF10.2

    Gerichtsbeschluss zur Liquidation

    1 SeitenCOCOMP

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2010

    6 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 10. Jan. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital20. Jan. 2011

    Kapitalaufstellung am 20. Jan. 2011

    • Kapital: GBP 100,000
    SH01

    Jahresrückblick erstellt bis 01. Jan. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2009

    6 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 01. Jan. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Änderung der Details des Direktors für Stephen Leslie Green am 25. Jan. 2010

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2008

    6 SeitenAA

    legacy

    4 Seiten363a

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2007

    6 SeitenAA

    legacy

    2 Seiten363a

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2006

    6 SeitenAA

    legacy

    2 Seiten363a

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2005

    6 SeitenAA

    legacy

    2 Seiten363a

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2004

    6 SeitenAA

    legacy

    7 Seiten363s

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2003

    5 SeitenAA

    legacy

    7 Seiten363s
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    annual-return22. Jan. 2004

    legacy

    363(288)

    legacy

    7 Seiten363s
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    annual-return27. Mai 2003

    legacy

    363(288)

    Wer sind die Geschäftsführer von JNL LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    SCOBLE, Claire Louise
    Tunbridge House
    Tunbridge Road
    BS40 8SX Chew Magna
    Bristol
    Sekretär
    Tunbridge House
    Tunbridge Road
    BS40 8SX Chew Magna
    Bristol
    BritishDirector97068300001
    GREEN, Stephen Leslie
    Felindre
    Bakers Lane Chilcompton
    BA3 4EW Radstock
    Avon
    Geschäftsführer
    Felindre
    Bakers Lane Chilcompton
    BA3 4EW Radstock
    Avon
    EnglandBritishAccountant119954050001
    PEARCE, Malcolm Victor Lawrence
    Lady Farm
    Chelwood
    BS39 4NN Bristol
    Geschäftsführer
    Lady Farm
    Chelwood
    BS39 4NN Bristol
    EnglandBritishChairman5325360001
    SMITH, Stuart Raymond
    55 Park Road
    BA1 3EE Bath
    Sekretär
    55 Park Road
    BA1 3EE Bath
    British2734740002
    BLUNDELL, David
    Stables Cottage
    1 Edgecombe Mews Weston
    BA1 4DA Bath
    Avon
    Geschäftsführer
    Stables Cottage
    1 Edgecombe Mews Weston
    BA1 4DA Bath
    Avon
    BritishWholesale News Director24479210001
    DAVIES, John Richard
    Station House
    16 Station Road Lower Weston
    BA1 3DX Bath
    Geschäftsführer
    Station House
    16 Station Road Lower Weston
    BA1 3DX Bath
    BritishComputer Manager57592520001
    DIACONO, Michael Christopher St. George
    Chilcombe House Chilcombe Bottom
    Batheaston
    BA1 8EL Bath
    Geschäftsführer
    Chilcombe House Chilcombe Bottom
    Batheaston
    BA1 8EL Bath
    BritishBusiness Development Director37693980003
    HURWORTH, Edward
    Compton Cottage 180 Leesons Hill
    BR7 6QL Chislehurst
    Kent
    Geschäftsführer
    Compton Cottage 180 Leesons Hill
    BR7 6QL Chislehurst
    Kent
    BritishManaging Director3974550001
    JONES, William Geoffrey
    Sellars Stile
    Bengrove Camerton
    BA3 1PH Bath
    Avon
    Geschäftsführer
    Sellars Stile
    Bengrove Camerton
    BA3 1PH Bath
    Avon
    BritishDivisional Director33856200001
    PETLEY, Kevin Frederick
    43 Oak Drive
    North Bradley
    BA14 0SW Trowbridge
    Wiltshire
    Geschäftsführer
    43 Oak Drive
    North Bradley
    BA14 0SW Trowbridge
    Wiltshire
    BritishSales Director67052070001
    RUSHTON, Andrew John
    10 Springfield Place
    BA1 5RA Bath
    Avon
    Geschäftsführer
    10 Springfield Place
    BA1 5RA Bath
    Avon
    BritishSolicitor18261700001
    SHAW, Nicholas Richard George
    Whites Croft
    North Road
    BA2 6JD Bath
    Avon
    Geschäftsführer
    Whites Croft
    North Road
    BA2 6JD Bath
    Avon
    BritishWholesale Divisional Director4938440001
    SHOLL, David Alexander
    4 Nightingale Way
    Midsomer Norton
    BA3 4NL Bath
    Geschäftsführer
    4 Nightingale Way
    Midsomer Norton
    BA3 4NL Bath
    BritishCompany Director48929140001
    SILLS, Colin Anthony
    Sutherland House 159 Oldmixon Road
    Hutton
    BS24 9QB Weston Super Mare
    Avon
    Geschäftsführer
    Sutherland House 159 Oldmixon Road
    Hutton
    BS24 9QB Weston Super Mare
    Avon
    BritishFinance Director3829790001
    STALL, Leonard Alexander
    First Floor Apartments
    4 Kings Gardens
    BN3 2PE Hove
    East Sussex
    Geschäftsführer
    First Floor Apartments
    4 Kings Gardens
    BN3 2PE Hove
    East Sussex
    BritishManaging Director51326370001
    TOWNLEY, John Robert
    4 Finland Street
    SE16 1TP London
    Geschäftsführer
    4 Finland Street
    SE16 1TP London
    BritishNewspaper & Magazine Distribut72000900001
    VOSS, Alan
    10 The Mead
    Crocombe Lane Timsbury
    BA3 1NS Bath
    Geschäftsführer
    10 The Mead
    Crocombe Lane Timsbury
    BA3 1NS Bath
    BritishPersonnel Training Director57592640002

    Hat JNL LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 13. Juli 1994
    Geliefert am 15. Juli 1994
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 15. Juli 1994Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 08. Juli 1994
    Geliefert am 16. Juli 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/as 1 hayes place, wellsway, bath, avon. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. Juli 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Mai 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 06. Juli 1994
    Geliefert am 16. Juli 1994
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property k/as 8 brassmill enterprise centre, bath, avon. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. Juli 1994Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 06. Juli 1994
    Geliefert am 16. Juli 1994
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property k/as 10 brassmill enterprise centre, bath, avon. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. Juli 1994Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 06. Juli 1994
    Geliefert am 16. Juli 1994
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property k/as 9 brassmill enterprise centre, bath, avon. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. Juli 1994Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 06. Juli 1994
    Geliefert am 16. Juli 1994
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property k/as 13 brassmill enterprise centre, bath, avon. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. Juli 1994Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 06. Juli 1994
    Geliefert am 16. Juli 1994
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property k/as 11 brassmill enterprise centre, bath, avon. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. Juli 1994Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 06. Juli 1994
    Geliefert am 16. Juli 1994
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property k/as 12 brassmill enterprise centre, bath, avon. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. Juli 1994Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 01. Juli 1992
    Geliefert am 20. Juli 1992
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    1 hayes place bear flat bath avon and/or the proceeds of sale thereof title no: AV35542. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 20. Juli 1992Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 07. Jan. 1991
    Geliefert am 11. Jan. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £700,000 all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan note of even date.
    Kurze Angaben
    All estates or interest in any freehold or/leasehold property.
    Berechtigte Personen
    • S Robinson & Co Limited
    Transaktionen
    • 11. Jan. 1991Registrierung einer Belastung
    • 14. Jan. 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 09. Jan. 1989
    Geliefert am 16. Jan. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property k/a news house cordwallis st maidenhead berkshire and the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. Jan. 1989Registrierung einer Belastung
    • 14. Mai 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 14. März 1988
    Geliefert am 31. März 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Unit 13, brassmill enterprise centre brassmill lane bath, avon and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 31. März 1988Registrierung einer Belastung
    • 09. Sept. 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 14. März 1988
    Geliefert am 31. März 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Unit 12 brassmill enterprise centre brassmill lane bath, avon and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 31. März 1988Registrierung einer Belastung
    • 09. Sept. 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 14. März 1988
    Geliefert am 31. März 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Unit 11, brassmill enterprise centre brassmill lane bath, avon and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 31. März 1988Registrierung einer Belastung
    • 09. Sept. 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 14. März 1988
    Geliefert am 31. März 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Unit 10 brasmill enterprise centre brassmill lane bath, avon. And/or the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 31. März 1988Registrierung einer Belastung
    • 09. Sept. 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 14. März 1988
    Geliefert am 31. März 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Unit 9 brassmill enterprise centre brassmill lane bath, avon. And/or the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 31. März 1988Registrierung einer Belastung
    • 09. Sept. 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 14. März 1988
    Geliefert am 31. März 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Unit 8, brassmill enterprise centre brassmill lane bath, avon, and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 31. März 1988Registrierung einer Belastung
    • 09. Sept. 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge
    Erstellt am 29. Dez. 1983
    Geliefert am 06. Jan. 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    For further securing all monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to a debenture dated 5/4/72.
    Kurze Angaben
    A specific charge over all book debts & other debts due or owing to the company present & future.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 06. Jan. 1984Registrierung einer Belastung
    • 27. Mai 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 05. Apr. 1972
    Geliefert am 25. Apr. 1972
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Undertaking and all property and assets present and future including goodwill of fixed & floating charges (see doc 8).
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Apr. 1972Registrierung einer Belastung
    • 27. Mai 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat JNL LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    14. Feb. 2011Antragsdatum
    10. Juli 2018Abschluss der Liquidation
    30. März 2011Beginn der Liquidation
    07. Nov. 2018Aufgelöst am
    Zwangsliquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    The Official Receiver Or London
    21 Bloomsbury Street
    London
    WC1B 3SS
    Praktiker
    21 Bloomsbury Street
    London
    WC1B 3SS

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0