BBI ENZYMES (UK) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameBBI ENZYMES (UK) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01034731
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von BBI ENZYMES (UK) LIMITED?

    • Herstellung anderer chemischer Erzeugnisse n.e.c. (20590) / Verarbeitendes Gewerbe

    Wo befindet sich BBI ENZYMES (UK) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    BERRY SMITH LLP
    Haywood House Dumfries Place
    CF10 3GA Cardiff
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von BBI ENZYMES (UK) LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    BIOZYME LABORATORIES LIMITED15. Dez. 197115. Dez. 1971

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BBI ENZYMES (UK) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2020

    Welche sind die letzten Einreichungen für BBI ENZYMES (UK) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    1 SeitenDS01

    Bestätigungserklärung erstellt am 10. Apr. 2022 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2020

    8 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 10. Apr. 2021 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2019

    8 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Alan Edward Peterson als Geschäftsführer am 06. Aug. 2020

    1 SeitenTM01

    Bestätigungserklärung erstellt am 10. Apr. 2020 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2018

    8 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 10. Apr. 2019 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Beendigung der Bestellung von Alexander Heinrich Werner Poempner als Geschäftsführer am 27. Nov. 2018

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Richard George Armitt Couzens als Direktor am 01. Nov. 2018

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr Alan Edward Peterson als Direktor am 01. Nov. 2018

    2 SeitenAP01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2017

    9 SeitenAA

    Änderung der Details des Direktors für Mr Alexander Heinrich Werner Poempner am 01. Feb. 2018

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Mario Pietro Gualano am 01. Feb. 2018

    2 SeitenCH01

    Bestätigungserklärung erstellt am 10. Apr. 2018 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Beendigung der Bestellung von Liam Mark Taylor als Geschäftsführer am 16. Jan. 2018

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Lyn Dafydd Rees als Geschäftsführer am 16. Jan. 2018

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Alexander Heinrich Werner Poempner als Direktor am 16. Jan. 2018

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr Mario Pietro Gualano als Direktor am 16. Jan. 2018

    2 SeitenAP01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2016

    9 SeitenAA

    Änderung der Details des Direktors für Mr Liam Mark Taylor am 02. Juli 2016

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Liam Taylor am 02. Juli 2017

    2 SeitenCH01

    Wer sind die Geschäftsführer von BBI ENZYMES (UK) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    COUZENS, Richard George Armitt
    Pen-Y-Fan Industrial Estate
    Crumlin
    NP11 3EF Newport
    Parkway
    Wales
    Geschäftsführer
    Pen-Y-Fan Industrial Estate
    Crumlin
    NP11 3EF Newport
    Parkway
    Wales
    United KingdomBritish253439790001
    GUALANO, Mario Pietro
    Pen-Y-Fan Industrial Estate
    Crumlin
    NP11 3EF Newport
    Parkway
    Wales
    Geschäftsführer
    Pen-Y-Fan Industrial Estate
    Crumlin
    NP11 3EF Newport
    Parkway
    Wales
    EnglandBritish242829200001
    ANDERSON, Colin David
    Bettws-Y-Coed Road
    Cyncoed
    CF23 6PN Cardiff
    50
    Sekretär
    Bettws-Y-Coed Road
    Cyncoed
    CF23 6PN Cardiff
    50
    United Kingdom44628230005
    JOHNSTON, Malcolm James
    107 Lavender Sweep
    Clapham
    SW11 1EA London
    Sekretär
    107 Lavender Sweep
    Clapham
    SW11 1EA London
    British42155660001
    LLOYD SMITH, Lynda Joan
    Green Gables
    Gwmavon
    NP4 9LF Blaenavon
    Gwent
    Sekretär
    Green Gables
    Gwmavon
    NP4 9LF Blaenavon
    Gwent
    British18589240001
    ROOKE, Joanne Bowden
    Rose Cottage
    36 Thistlecroft Road
    KT12 5QZ Walton On Thames
    Surrey
    Sekretär
    Rose Cottage
    36 Thistlecroft Road
    KT12 5QZ Walton On Thames
    Surrey
    British51172180006
    ANDERSON, Colin David
    Bettws-Y-Coed Road
    Cyncoed
    CF23 6PN Cardiff
    50
    Geschäftsführer
    Bettws-Y-Coed Road
    Cyncoed
    CF23 6PN Cardiff
    50
    United KingdomUnited Kingdom44628230005
    BARRY, Douglas John
    c/o Alere Inc
    Sawyer Road
    Suite 200
    02453 Waltham
    51
    Ma
    Usa
    Geschäftsführer
    c/o Alere Inc
    Sawyer Road
    Suite 200
    02453 Waltham
    51
    Ma
    Usa
    UsaAmerican199784920001
    CHESHAM, John, Doctor
    3 Southwell Close
    Broad Oak
    HR2 8DZ Hereford
    Herefordshire
    Geschäftsführer
    3 Southwell Close
    Broad Oak
    HR2 8DZ Hereford
    Herefordshire
    British58105320002
    COYNE, Raymond
    3 Bayfield Avenue
    Frimley
    GU16 5TT Camberley
    Surrey
    Geschäftsführer
    3 Bayfield Avenue
    Frimley
    GU16 5TT Camberley
    Surrey
    United KingdomBritish9354490001
    DOMINGO, Moreeda
    The Beeches
    54 Pen-Y-Pound
    NP7 7RW Abergavenny
    Gwent
    Geschäftsführer
    The Beeches
    54 Pen-Y-Pound
    NP7 7RW Abergavenny
    Gwent
    British7705640001
    DOMINGO, Rashid
    43 Plas Derwen View
    NP7 9SX Abergavenny
    Gwent
    Geschäftsführer
    43 Plas Derwen View
    NP7 9SX Abergavenny
    Gwent
    British7705630002
    HIGGINS, Irving John
    Cotswold Graze Hill
    Ravensden
    MK44 2TF Bedford
    Bedfordshire
    Geschäftsführer
    Cotswold Graze Hill
    Ravensden
    MK44 2TF Bedford
    Bedfordshire
    British46344530001
    JONES, Graham Spencer
    5 Basildene Close
    Gilwern
    NP7 0AW Abergavenny
    Gwent
    Geschäftsführer
    5 Basildene Close
    Gilwern
    NP7 0AW Abergavenny
    Gwent
    British26990860001
    MCNAMARA, Jay
    51 Sawyer Road
    Suite 200
    Waltham
    C/O Alere Inc
    Ma 02453
    Usa
    Geschäftsführer
    51 Sawyer Road
    Suite 200
    Waltham
    C/O Alere Inc
    Ma 02453
    Usa
    UsaAmerican174859180001
    PETERSON, Alan Edward
    Pen-Y-Fan Industrial Estate
    Crumlin
    NP11 3EF Newport
    Parkway
    Wales
    Geschäftsführer
    Pen-Y-Fan Industrial Estate
    Crumlin
    NP11 3EF Newport
    Parkway
    Wales
    United KingdomBritish28231980004
    POEMPNER, Alexander Heinrich Werner
    Pen-Y-Fan Industrial Estate
    Crumlin
    NP11 3EF Newport
    Parkway
    Wales
    Geschäftsführer
    Pen-Y-Fan Industrial Estate
    Crumlin
    NP11 3EF Newport
    Parkway
    Wales
    GermanyGerman209810980001
    REES, Lyn Dafydd
    73 Ty Glas Avenue
    Llanishen
    CF14 5DX Cardiff
    The Courtyard
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    73 Ty Glas Avenue
    Llanishen
    CF14 5DX Cardiff
    The Courtyard
    United Kingdom
    WalesBritish108878140002
    TAYLOR, Liam Mark
    73 Ty Glas Avenue
    Llanishen
    CF14 5DX Cardiff
    The Courtyard
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    73 Ty Glas Avenue
    Llanishen
    CF14 5DX Cardiff
    The Courtyard
    United Kingdom
    WalesAustralian152099150002
    ADAM BIOTECHNOLOGY LIMITED
    73 Ty Glas Avenue
    Llanishen
    CF14 5DX Cardiff
    The Courtyard
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    73 Ty Glas Avenue
    Llanishen
    CF14 5DX Cardiff
    The Courtyard
    United Kingdom
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer1912259
    124189850002
    BBI ENZYMES LIMITED
    73 Ty Glas Avenue
    Llanishen
    CF14 5DX Cardiff
    The Courtyard
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    73 Ty Glas Avenue
    Llanishen
    CF14 5DX Cardiff
    The Courtyard
    United Kingdom
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer2815159
    45563930008
    CRANFIELD BIOTECHNOLOGY LIMITED
    C/O Theratase Ltd
    Golden Gate Tyglas Avenue
    CF14 5DX Cardiff
    Geschäftsführer
    C/O Theratase Ltd
    Golden Gate Tyglas Avenue
    CF14 5DX Cardiff
    45920430005

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei BBI ENZYMES (UK) LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Bbi Solutions Oem Limited
    Haywood House
    Dumfries Place
    CF10 3GA Cardiff
    C/O Berry Smith Llp
    Wales
    06. Apr. 2016
    Haywood House
    Dumfries Place
    CF10 3GA Cardiff
    C/O Berry Smith Llp
    Wales
    Nein
    RechtsformPrivate Company Limited By Shares
    RegistrierungslandEngland & Wales
    RechtsgrundlageEngland & Wales
    RegistrierungsortCompanies House, Uk
    Registrierungsnummer08368483
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.

    Hat BBI ENZYMES (UK) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal mortgage
    Erstellt am 14. Sept. 2011
    Geliefert am 17. Sept. 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a unit 6 gilchrist thomas industrial estate blaenavon t/nos. CYM177636 and WA324229 with the benefit of all rights, licences, guarantees, rent deposits, contracts, deeds undertakings & warranties relating to the property. Any shares or membership rights in any management company for the property. Any goodwill of any business from time to time carried on at the property. Any rental & other money payable and any lease licence or other interest created in respect of the property & all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 17. Sept. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 19. Sept. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal mortgage
    Erstellt am 06. Juli 2011
    Geliefert am 19. Juli 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H broadoak enterprise village broadoak road sittingbourne t/nos K756811 K759614 K759616 and K180636 with the benefit of all rights, licences, guarantees, rent deposits, contracts, deeds undertakings & warranties relating to the property. Any shares or membership rights in any management company for the property. Any goodwill of any business from time to time carried on at the property. Any rental & other money payable and any lease licence or other interest created in respect of the property & all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Juli 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 14. Sept. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal mortgage
    Erstellt am 06. Juli 2011
    Geliefert am 19. Juli 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H unit 15 gilchrist thomas industrial estate blaenavon t/no WA333047 with the benefit of all rights, licences, guarantees, rent deposits, contracts, deeds undertakings & warranties relating to the property. Any shares or membership rights in any management company for the property. Any goodwill of any business from time to time carried on at the property. Any rental & other money payable and any lease licence or other interest created in respect of the property & all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Juli 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 14. Sept. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 06. Juli 2011
    Geliefert am 19. Juli 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Juli 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 14. Sept. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 18. Juni 2009
    Geliefert am 19. Juni 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a land adjoining unit 6 gilchrist thomas industrial estate, blaenavon.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Juni 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Juli 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 18. Juni 2009
    Geliefert am 19. Juni 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a unit 6 gilchrist thomas industrial estate, blaenavon.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Juni 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Juli 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 18. Juni 2009
    Geliefert am 19. Juni 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a land and buildings unit 15 gilchrist thomas industrial estate, blaenavon.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Juni 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Juli 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Deed of accession and charge
    Erstellt am 07. Okt. 2008
    Geliefert am 28. Okt. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and all the other companies to the chargee
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over all property and assets present and future, including goodwill, debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 28. Okt. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Juli 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Charge of deposit
    Erstellt am 28. Apr. 2004
    Geliefert am 05. Mai 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The deposit initially of £40,000 credited to account designation 36046175 witht he bank and any addition to that deposit and any deposit or account from time to time of any other currency description or designation.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 05. Mai 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Juli 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 04. Apr. 2004
    Geliefert am 13. Apr. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and theratase PLC (the borrower) to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Kbc Bank N.V., London Branch
    Transaktionen
    • 13. Apr. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Mai 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 20. Dez. 1994
    Geliefert am 28. Dez. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a unit 15 gilchrist thomas industrial estate blaenavon gwent title number WA333047 and the proceeds of sale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 28. Dez. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Apr. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 20. Dez. 1994
    Geliefert am 28. Dez. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a land adjoining unit 6 gilchrist thomas estate blaenavon gwent title number WA324229 and the proceeds of sale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 28. Dez. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Apr. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 20. Dez. 1994
    Geliefert am 28. Dez. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a unit 6 gilchrist-thomas estate blaenavon gwent south wales and the proceeds of sale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 28. Dez. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Apr. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 15. Sept. 1994
    Geliefert am 20. Sept. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 20. Sept. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Apr. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 19. Okt. 1987
    Geliefert am 02. Nov. 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or biozyme laboratories international limited. To the chargee on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 02. Nov. 1987Registrierung einer Belastung
    • 16. März 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 21. Apr. 1986
    Geliefert am 09. Mai 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £65,000.00 and all other monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    All that piece or parcel of land situate at gilchrist thomas industrial estate, blaenavon, in the county of gwent. Together with the factory erected thereon k/a:- unit 15 gilchrist thomas industrial estate.
    Berechtigte Personen
    • Torfaen Borough Council.
    Transaktionen
    • 09. Mai 1986Registrierung einer Belastung
    • 13. Apr. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 21. Apr. 1986
    Geliefert am 29. Apr. 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Unit 15 gilchrist thomas estate blaenavon, gwent.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 29. Apr. 1986Registrierung einer Belastung
    • 01. März 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 04. Juni 1985
    Geliefert am 24. Juni 1985
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Unit 6, gilchrist thomas estate, blaenavon, gwent.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 24. Juni 1985Registrierung einer Belastung
    • 01. März 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 10. Jan. 1972
    Geliefert am 14. Jan. 1972
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Undertaking and all property and goodwill assets present and future including uncalled capital. Fixed & floating charge (see doc 7 for details).
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 14. Jan. 1972Registrierung einer Belastung
    • 02. Feb. 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0