BBI ENZYMES (UK) LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | BBI ENZYMES (UK) LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01034731 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von BBI ENZYMES (UK) LIMITED?
- Herstellung anderer chemischer Erzeugnisse n.e.c. (20590) / Verarbeitendes Gewerbe
Wo befindet sich BBI ENZYMES (UK) LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | BERRY SMITH LLP Haywood House Dumfries Place CF10 3GA Cardiff |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von BBI ENZYMES (UK) LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| BIOZYME LABORATORIES LIMITED | 15. Dez. 1971 | 15. Dez. 1971 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BBI ENZYMES (UK) LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2020 |
Welche sind die letzten Einreichungen für BBI ENZYMES (UK) LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 10. Apr. 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2020 | 8 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 10. Apr. 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2019 | 8 Seiten | AA | ||
Beendigung der Bestellung von Alan Edward Peterson als Geschäftsführer am 06. Aug. 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 10. Apr. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 8 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 10. Apr. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Beendigung der Bestellung von Alexander Heinrich Werner Poempner als Geschäftsführer am 27. Nov. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||
Ernennung von Mr Richard George Armitt Couzens als Direktor am 01. Nov. 2018 | 2 Seiten | AP01 | ||
Ernennung von Mr Alan Edward Peterson als Direktor am 01. Nov. 2018 | 2 Seiten | AP01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 9 Seiten | AA | ||
Änderung der Details des Direktors für Mr Alexander Heinrich Werner Poempner am 01. Feb. 2018 | 2 Seiten | CH01 | ||
Änderung der Details des Direktors für Mr Mario Pietro Gualano am 01. Feb. 2018 | 2 Seiten | CH01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 10. Apr. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Beendigung der Bestellung von Liam Mark Taylor als Geschäftsführer am 16. Jan. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Lyn Dafydd Rees als Geschäftsführer am 16. Jan. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||
Ernennung von Mr Alexander Heinrich Werner Poempner als Direktor am 16. Jan. 2018 | 2 Seiten | AP01 | ||
Ernennung von Mr Mario Pietro Gualano als Direktor am 16. Jan. 2018 | 2 Seiten | AP01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 9 Seiten | AA | ||
Änderung der Details des Direktors für Mr Liam Mark Taylor am 02. Juli 2016 | 2 Seiten | CH01 | ||
Änderung der Details des Direktors für Mr Liam Taylor am 02. Juli 2017 | 2 Seiten | CH01 | ||
Wer sind die Geschäftsführer von BBI ENZYMES (UK) LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUZENS, Richard George Armitt | Geschäftsführer | Pen-Y-Fan Industrial Estate Crumlin NP11 3EF Newport Parkway Wales | United Kingdom | British | 253439790001 | |||||||||
| GUALANO, Mario Pietro | Geschäftsführer | Pen-Y-Fan Industrial Estate Crumlin NP11 3EF Newport Parkway Wales | England | British | 242829200001 | |||||||||
| ANDERSON, Colin David | Sekretär | Bettws-Y-Coed Road Cyncoed CF23 6PN Cardiff 50 | United Kingdom | 44628230005 | ||||||||||
| JOHNSTON, Malcolm James | Sekretär | 107 Lavender Sweep Clapham SW11 1EA London | British | 42155660001 | ||||||||||
| LLOYD SMITH, Lynda Joan | Sekretär | Green Gables Gwmavon NP4 9LF Blaenavon Gwent | British | 18589240001 | ||||||||||
| ROOKE, Joanne Bowden | Sekretär | Rose Cottage 36 Thistlecroft Road KT12 5QZ Walton On Thames Surrey | British | 51172180006 | ||||||||||
| ANDERSON, Colin David | Geschäftsführer | Bettws-Y-Coed Road Cyncoed CF23 6PN Cardiff 50 | United Kingdom | United Kingdom | 44628230005 | |||||||||
| BARRY, Douglas John | Geschäftsführer | c/o Alere Inc Sawyer Road Suite 200 02453 Waltham 51 Ma Usa | Usa | American | 199784920001 | |||||||||
| CHESHAM, John, Doctor | Geschäftsführer | 3 Southwell Close Broad Oak HR2 8DZ Hereford Herefordshire | British | 58105320002 | ||||||||||
| COYNE, Raymond | Geschäftsführer | 3 Bayfield Avenue Frimley GU16 5TT Camberley Surrey | United Kingdom | British | 9354490001 | |||||||||
| DOMINGO, Moreeda | Geschäftsführer | The Beeches 54 Pen-Y-Pound NP7 7RW Abergavenny Gwent | British | 7705640001 | ||||||||||
| DOMINGO, Rashid | Geschäftsführer | 43 Plas Derwen View NP7 9SX Abergavenny Gwent | British | 7705630002 | ||||||||||
| HIGGINS, Irving John | Geschäftsführer | Cotswold Graze Hill Ravensden MK44 2TF Bedford Bedfordshire | British | 46344530001 | ||||||||||
| JONES, Graham Spencer | Geschäftsführer | 5 Basildene Close Gilwern NP7 0AW Abergavenny Gwent | British | 26990860001 | ||||||||||
| MCNAMARA, Jay | Geschäftsführer | 51 Sawyer Road Suite 200 Waltham C/O Alere Inc Ma 02453 Usa | Usa | American | 174859180001 | |||||||||
| PETERSON, Alan Edward | Geschäftsführer | Pen-Y-Fan Industrial Estate Crumlin NP11 3EF Newport Parkway Wales | United Kingdom | British | 28231980004 | |||||||||
| POEMPNER, Alexander Heinrich Werner | Geschäftsführer | Pen-Y-Fan Industrial Estate Crumlin NP11 3EF Newport Parkway Wales | Germany | German | 209810980001 | |||||||||
| REES, Lyn Dafydd | Geschäftsführer | 73 Ty Glas Avenue Llanishen CF14 5DX Cardiff The Courtyard United Kingdom | Wales | British | 108878140002 | |||||||||
| TAYLOR, Liam Mark | Geschäftsführer | 73 Ty Glas Avenue Llanishen CF14 5DX Cardiff The Courtyard United Kingdom | Wales | Australian | 152099150002 | |||||||||
| ADAM BIOTECHNOLOGY LIMITED | Geschäftsführer | 73 Ty Glas Avenue Llanishen CF14 5DX Cardiff The Courtyard United Kingdom |
| 124189850002 | ||||||||||
| BBI ENZYMES LIMITED | Geschäftsführer | 73 Ty Glas Avenue Llanishen CF14 5DX Cardiff The Courtyard United Kingdom |
| 45563930008 | ||||||||||
| CRANFIELD BIOTECHNOLOGY LIMITED | Geschäftsführer | C/O Theratase Ltd Golden Gate Tyglas Avenue CF14 5DX Cardiff | 45920430005 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei BBI ENZYMES (UK) LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bbi Solutions Oem Limited | 06. Apr. 2016 | Haywood House Dumfries Place CF10 3GA Cardiff C/O Berry Smith Llp Wales | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat BBI ENZYMES (UK) LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Legal mortgage | Erstellt am 14. Sept. 2011 Geliefert am 17. Sept. 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The f/h property k/a unit 6 gilchrist thomas industrial estate blaenavon t/nos. CYM177636 and WA324229 with the benefit of all rights, licences, guarantees, rent deposits, contracts, deeds undertakings & warranties relating to the property. Any shares or membership rights in any management company for the property. Any goodwill of any business from time to time carried on at the property. Any rental & other money payable and any lease licence or other interest created in respect of the property & all other payments whatever in respect of the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 06. Juli 2011 Geliefert am 19. Juli 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H broadoak enterprise village broadoak road sittingbourne t/nos K756811 K759614 K759616 and K180636 with the benefit of all rights, licences, guarantees, rent deposits, contracts, deeds undertakings & warranties relating to the property. Any shares or membership rights in any management company for the property. Any goodwill of any business from time to time carried on at the property. Any rental & other money payable and any lease licence or other interest created in respect of the property & all other payments whatever in respect of the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 06. Juli 2011 Geliefert am 19. Juli 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H unit 15 gilchrist thomas industrial estate blaenavon t/no WA333047 with the benefit of all rights, licences, guarantees, rent deposits, contracts, deeds undertakings & warranties relating to the property. Any shares or membership rights in any management company for the property. Any goodwill of any business from time to time carried on at the property. Any rental & other money payable and any lease licence or other interest created in respect of the property & all other payments whatever in respect of the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 06. Juli 2011 Geliefert am 19. Juli 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 18. Juni 2009 Geliefert am 19. Juni 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a land adjoining unit 6 gilchrist thomas industrial estate, blaenavon. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 18. Juni 2009 Geliefert am 19. Juni 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a unit 6 gilchrist thomas industrial estate, blaenavon. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 18. Juni 2009 Geliefert am 19. Juni 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a land and buildings unit 15 gilchrist thomas industrial estate, blaenavon. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of accession and charge | Erstellt am 07. Okt. 2008 Geliefert am 28. Okt. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and all the other companies to the chargee | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over all property and assets present and future, including goodwill, debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge of deposit | Erstellt am 28. Apr. 2004 Geliefert am 05. Mai 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The deposit initially of £40,000 credited to account designation 36046175 witht he bank and any addition to that deposit and any deposit or account from time to time of any other currency description or designation. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 04. Apr. 2004 Geliefert am 13. Apr. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and theratase PLC (the borrower) to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 20. Dez. 1994 Geliefert am 28. Dez. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The f/h property k/a unit 15 gilchrist thomas industrial estate blaenavon gwent title number WA333047 and the proceeds of sale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 20. Dez. 1994 Geliefert am 28. Dez. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The f/h property k/a land adjoining unit 6 gilchrist thomas estate blaenavon gwent title number WA324229 and the proceeds of sale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 20. Dez. 1994 Geliefert am 28. Dez. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The f/h property k/a unit 6 gilchrist-thomas estate blaenavon gwent south wales and the proceeds of sale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 15. Sept. 1994 Geliefert am 20. Sept. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 19. Okt. 1987 Geliefert am 02. Nov. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or biozyme laboratories international limited. To the chargee on any account whatsoever. | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 21. Apr. 1986 Geliefert am 09. Mai 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £65,000.00 and all other monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben All that piece or parcel of land situate at gilchrist thomas industrial estate, blaenavon, in the county of gwent. Together with the factory erected thereon k/a:- unit 15 gilchrist thomas industrial estate. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 21. Apr. 1986 Geliefert am 29. Apr. 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Unit 15 gilchrist thomas estate blaenavon, gwent. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 04. Juni 1985 Geliefert am 24. Juni 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Unit 6, gilchrist thomas estate, blaenavon, gwent. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 10. Jan. 1972 Geliefert am 14. Jan. 1972 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Undertaking and all property and goodwill assets present and future including uncalled capital. Fixed & floating charge (see doc 7 for details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0