WELLFULL DEVELOPMENTS LIMITED

WELLFULL DEVELOPMENTS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameWELLFULL DEVELOPMENTS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01037810
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von WELLFULL DEVELOPMENTS LIMITED?

    • (7011) /

    Wo befindet sich WELLFULL DEVELOPMENTS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    United Kingdom
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von WELLFULL DEVELOPMENTS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2011

    Welche sind die letzten Einreichungen für WELLFULL DEVELOPMENTS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ2

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2011

    8 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 09. Juli 2011

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital30. Aug. 2011

    Kapitalaufstellung am 30. Aug. 2011

    • Kapital: GBP 100
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2010

    6 SeitenAA

    Vorheriger Abrechnungszeitraum verkürzt von 31. März 2010 bis 30. März 2010

    3 SeitenAA01

    Jahresrückblick erstellt bis 09. Juli 2010

    3 SeitenAR01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Maurice Moses Benady am 01. Mai 2010

    3 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Christopher George White am 01. März 2010

    3 SeitenCH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2009

    5 SeitenAA

    legacy

    4 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten353

    legacy

    1 Seiten190

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    1 Seiten287

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2008

    10 SeitenAA

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Section 175- company business 10/11/2008
    RES13

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Section 175- company business 10/11/2008
    RES13

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Section 175 company business 10/11/2008
    RES13

    Beschlüsse

    Resolutions
    4 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    incorporation

    Beschluss zur Änderung der Gesellschaftervereinbarung

    RES01
    capital

    Beschlüsse

    Section 175 10/11/2008
    RES13

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    4 Seiten288a

    legacy

    4 Seiten288a

    legacy

    3 Seiten363a

    Wer sind die Geschäftsführer von WELLFULL DEVELOPMENTS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    REIT (CORPORATE SERVICES) LIMITED
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    Sekretär
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    79571870001
    BENADY, Maurice Moses
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    Gibraltar
    Geschäftsführer
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    Gibraltar
    GibraltarBritishSolicitor69435160001
    WHITE, Christopher George
    Line Wall Road
    57-63 Gibraltar
    Geschäftsführer
    Line Wall Road
    57-63 Gibraltar
    GibraltarBritishBarrister At Law80132540006
    TRAFALGAR OFFICERS LIMITED
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    3rd Floor
    Geschäftsführer
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    3rd Floor
    135316290001
    HOLLAND, Philip John
    9 Royle Close
    Chalfont St. Peter
    SL9 0BA Buckinghamshire
    Sekretär
    9 Royle Close
    Chalfont St. Peter
    SL9 0BA Buckinghamshire
    BritishChief Acc74688330002
    ROBERTS, Geoffrey Michael
    Brenchley 8 Hamilton Road
    DA15 7HB Sidcup
    Kent
    Sekretär
    Brenchley 8 Hamilton Road
    DA15 7HB Sidcup
    Kent
    British29217560001
    WHITE, Christine
    31 Denmark Street
    WD17 4YA Watford
    Hertfordshire
    Sekretär
    31 Denmark Street
    WD17 4YA Watford
    Hertfordshire
    British74900200002
    BLOOMFIELD, David William
    Hillcroft
    The Drive Harefield Place
    UB10 8AQ Ickenham
    Middlesex
    Geschäftsführer
    Hillcroft
    The Drive Harefield Place
    UB10 8AQ Ickenham
    Middlesex
    BritishCompany Director7927670001
    CLEGG, Barry Stuart
    The Gate House
    18a Ducks Hill Road
    HA6 2NR Northwood
    Middlesex
    Geschäftsführer
    The Gate House
    18a Ducks Hill Road
    HA6 2NR Northwood
    Middlesex
    United KingdomBritishCompany Director11296610002
    CULL, David Geoffrey Maurice
    8 Centennial Court
    High Street
    WD3 1AW Rickmansworth
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    8 Centennial Court
    High Street
    WD3 1AW Rickmansworth
    Hertfordshire
    BritishCompany Director84076630001
    DOSSETT, Roger John
    Charlecote
    Harewood Road
    HP8 4UA Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Charlecote
    Harewood Road
    HP8 4UA Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    EnglandBritishCompany Director116927100001
    HOLLAND, Philip John
    61 Badgers Gate
    LU6 2BF Dunstable
    Bedfordshire
    Geschäftsführer
    61 Badgers Gate
    LU6 2BF Dunstable
    Bedfordshire
    EnglandBritishChief Accountant163838050001
    MALONE, Kenneth Daniel
    One Tree Cottage 18 Woodside Avenue
    HP9 1JJ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    One Tree Cottage 18 Woodside Avenue
    HP9 1JJ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    BritishChartered Surveyor60687110001
    TAYLOR, Robert Patrick
    Lanreath Ditton Hill
    KT6 5EH Surbiton
    Surrey
    Geschäftsführer
    Lanreath Ditton Hill
    KT6 5EH Surbiton
    Surrey
    EnglandBritishCompany Director7862560003
    REIT(CORPORATE DIRECTORS) LIMITED
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    Geschäftsführer
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    74030120002

    Hat WELLFULL DEVELOPMENTS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 15. Sept. 2004
    Geliefert am 29. Sept. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the chargor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of fixed charge the real property other than the real property listed in part ii of schedule 2 of the debenture; all plant and machinery etc. and all related property rights; all debts; all of its securities and intellectual property rights; all goodwill and uncalled capital; and the insurance policies and the insurance proceeds. By way of assignment the insurance policies and the insurance proceeds; all rental income; any guarantee of rental income contained in or relating to any lease document; any hedging arrangements; each managing agent agreement; and each building contract and all related property rights. By way of first floating charge (I) the whole of its assets present and future and (ii) the whole of its assets situated in scotland.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hypo Real Estate Bank International (The "Security Trustee")
    Transaktionen
    • 29. Sept. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Supplemental debenture
    Erstellt am 24. Aug. 1998
    Geliefert am 25. Aug. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee as security trustee for the secured parties (as defined in the composite guarantee and mortgage debenture), the payment and discharge of which are the subject of covenants, undertakings, guarnatees, and agreements contained in the composite guarantee and mortgage debenture and the supplemental debenture
    Kurze Angaben
    F/H units 10, 11 and 14 regents wharf, all saints street, islington t/n-NGL688863 and all f/h land on the south side of high street and on the west side of three close lane berkhamsted t/n-HD1067 together with the proceeds of sale of the same together with any property and land already charged to the security trustee by way of legal mortgage by the company.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Aug. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Feb. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 01. Dez. 1997
    Geliefert am 02. Dez. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    93-101 high street and the land at the rear of rex cinema berkhampstead t/n HD1067.
    Berechtigte Personen
    • Commerzbank Ag
    Transaktionen
    • 02. Dez. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Juni 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of assignment
    Erstellt am 14. Aug. 1992
    Geliefert am 17. Aug. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or worth (london) limited to the chargee pursuant to the credit facility (as amended and restated) and as secured by the legal charge and the equitable charge (all as defined)
    Kurze Angaben
    Assignment of all rents recievable pursuant to a lease dated 22ND december 1989.
    Berechtigte Personen
    • Royal Bank of Canada
    Transaktionen
    • 17. Aug. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Feb. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee and mortgage debenture
    Erstellt am 04. Aug. 1992
    Geliefert am 19. Aug. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to national westminster bank PLC as "security trustee" for itself and the secured parties (all as defined therein) and to the secured parties on any account whatsoever under the terms of this deed
    Kurze Angaben
    See form 395 for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Aug. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Feb. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 29. Juni 1992
    Geliefert am 02. Juli 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Units 12 and 13,regents wharf,all saints st,london N.1.t/no.ngl 637226 with all blds and fixtures fixed charge all plant machinery and other chattels. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • The Co-Operative Bank Public Limited Company
    Transaktionen
    • 02. Juli 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Jan. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 25. Okt. 1991
    Geliefert am 26. Okt. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from estates & general PLC to the chargee not exceeding £5,500,000
    Kurze Angaben
    Units 10,11 and 14 regents wharf. All saints street, islington. London N1. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Okt. 1991Registrierung einer Belastung
    • 18. Feb. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 23. März 1989
    Geliefert am 03. Apr. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee in respect of the profit share under the terms of an agreement d/d 10/11/88
    Kurze Angaben
    Land and building situate at all saints street in the l/b of islington under the t/nos ngl 303459 ngl 362885 ngl 283674 and ngl 277155 (part).
    Berechtigte Personen
    • Gle (Properties) Limited
    Transaktionen
    • 03. Apr. 1989Registrierung einer Belastung
    • 11. Jan. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    First legal charge
    Erstellt am 04. Jan. 1988
    Geliefert am 07. Jan. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or estates & general investments PLC to the chargee on any account whatsoever under the terms of a loan agreement dated 9 dec 87 and this charge
    Kurze Angaben
    F/Hold property 20/24 broadwick street and 85/86 berwick street title no ln 143538.. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Canada
    Transaktionen
    • 07. Jan. 1988Registrierung einer Belastung
    • 11. Jan. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0