MOAT HOUSE (CATERERS) LIMITED

MOAT HOUSE (CATERERS) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameMOAT HOUSE (CATERERS) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01043175
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von MOAT HOUSE (CATERERS) LIMITED?

    • Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich MOAT HOUSE (CATERERS) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Suite 64 Waterhouse Business Park
    2 Cromar Way
    CM1 2QE Chelmsford
    Essex
    England
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MOAT HOUSE (CATERERS) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2015

    Welche sind die letzten Einreichungen für MOAT HOUSE (CATERERS) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Bestätigungserklärung erstellt am 13. Juni 2017 mit Aktualisierungen

    6 SeitenCS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2015

    19 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 09. Juni 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital09. Juni 2016

    Kapitalaufstellung am 09. Juni 2016

    • Kapital: GBP 1,000
    SH01

    Änderung der Details des Sekretärs für Sally Ann Coughlan am 02. Jan. 2016

    1 SeitenCH03

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 68 Waterhouse Business Park 2 Cromar Way Chelmsford Essex CM1 2QE zum Suite 64 Waterhouse Business Park 2 Cromar Way Chelmsford Essex CM1 2QE am 07. Dez. 2015

    1 SeitenAD01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2014

    16 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Matthew Alexander Rosenberg als Geschäftsführer am 06. Juli 2015

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Martin Quinn als Direktor am 06. Juli 2015

    2 SeitenAP01

    Jahresrückblick erstellt bis 09. Juni 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital11. Juni 2015

    Kapitalaufstellung am 11. Juni 2015

    • Kapital: GBP 1,000
    SH01

    Änderung der Details des Direktors für Matthew Alexander Rosenberg am 23. Sept. 2014

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Sekretärs für Sally Ann Coughlan am 02. Okt. 2014

    1 SeitenCH03

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2013

    19 SeitenAA

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Queens Court 9-17 Eastern Road Romford Essex RM1 3NG zum 68 Waterhouse Business Park 2 Cromar Way Chelmsford Essex CM1 2QE am 29. Sept. 2014

    1 SeitenAD01

    Ein Teil des Eigentums oder Unternehmens wurde entlassen und ist nicht mehr Teil der Belastung 29

    14 SeitenMR05

    Jahresrückblick erstellt bis 09. Juni 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital01. Juli 2014

    Kapitalaufstellung am 01. Juli 2014

    • Kapital: GBP 1,000
    SH01

    Beendigung der Bestellung von Erwin Rieck als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2012

    22 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 09. Juni 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Beendigung der Bestellung von W2001 Two Cv als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von W2001 Britannia Llc als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2011

    19 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 09. Juni 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Wer sind die Geschäftsführer von MOAT HOUSE (CATERERS) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    COUGHLAN, Sally Ann
    Waterhouse Business Park
    2 Cromar Way
    CM1 2QE Chelmsford
    Suite 64
    Essex
    England
    Sekretär
    Waterhouse Business Park
    2 Cromar Way
    CM1 2QE Chelmsford
    Suite 64
    Essex
    England
    British107832420001
    QUINN, Martin Joseph
    34 Francis Grove, Wimbledon
    SW19 4DT London
    Westmont Management Limited
    England
    Geschäftsführer
    34 Francis Grove, Wimbledon
    SW19 4DT London
    Westmont Management Limited
    England
    EnglandIrishAsset Manager186571310001
    BURGESS, Keith John
    3 Queen Annes Gate
    White House Walk
    GU9 9AN Farnham
    Surrey
    Sekretär
    3 Queen Annes Gate
    White House Walk
    GU9 9AN Farnham
    Surrey
    British7009790002
    CHRISTIAN, Tracy Joanne
    19 Lovell Walk
    RM13 7ND Rainham
    Essex
    Sekretär
    19 Lovell Walk
    RM13 7ND Rainham
    Essex
    British102667300001
    JONES, Vanessa
    Stables House
    Castle Hill
    RH1 4LB Bletchingley
    Surrey
    Sekretär
    Stables House
    Castle Hill
    RH1 4LB Bletchingley
    Surrey
    British72146200001
    PURVIS, Martin Terence Alan
    Fenetters
    Melfort Road
    TN6 1QT Crowborough
    East Sussex
    Sekretär
    Fenetters
    Melfort Road
    TN6 1QT Crowborough
    East Sussex
    British7901050001
    WALLER, Ronald John
    Brindles 118 Hanging Hill Lane
    CM13 2HN Brentwood
    Essex
    Sekretär
    Brindles 118 Hanging Hill Lane
    CM13 2HN Brentwood
    Essex
    British1210620001
    WATERS, Jonathan Roy
    Maldon Road
    CO3 3BQ Colchester
    237
    Essex
    Sekretär
    Maldon Road
    CO3 3BQ Colchester
    237
    Essex
    British129848360001
    ALLSOP, Heather Louise
    62 Prebend Street
    N1 8PS London
    Geschäftsführer
    62 Prebend Street
    N1 8PS London
    BritishInvestment Banker101912850001
    BAIRSTOW, John
    Frieze Cottage Coxtie Green Road
    South Weald
    CM14 5RE Brentwood
    Essex
    Geschäftsführer
    Frieze Cottage Coxtie Green Road
    South Weald
    CM14 5RE Brentwood
    Essex
    BritishCompany Director537400001
    BELL, Gerald James
    Cavewood Rectory Lane
    Datchworth
    SG3 6RD Knebworth
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Cavewood Rectory Lane
    Datchworth
    SG3 6RD Knebworth
    Hertfordshire
    BritishCompany Director47018930002
    BOULD, Andrew Robin Douglas
    508 Uxbridge Road
    HA5 4SG Pinner
    Middlesex
    Geschäftsführer
    508 Uxbridge Road
    HA5 4SG Pinner
    Middlesex
    BritishCompany Director36875610001
    CAIRNS, Michael Anthony
    Birchlands
    Old Avenue
    KT13 0PY Weybridge
    Surrey
    Geschäftsführer
    Birchlands
    Old Avenue
    KT13 0PY Weybridge
    Surrey
    United KingdomBritishCompany Director36488470001
    COLES, Alan Clifford
    The Knoll
    Grendon
    NN7 1JG Northampton
    Beeches, 5
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    The Knoll
    Grendon
    NN7 1JG Northampton
    Beeches, 5
    Northamptonshire
    EnglandBritishChartered Accountant101144900002
    COLLYER, Brian Charles
    49 Route De Croissy
    78110 Le Vesinet
    France
    Geschäftsführer
    49 Route De Croissy
    78110 Le Vesinet
    France
    CanadianInvestment Banker101144260001
    COPPEL, Andrew Maxwell
    Orchard House
    8 Claremont Park Road
    KT10 9LT Esher
    Surrey
    Geschäftsführer
    Orchard House
    8 Claremont Park Road
    KT10 9LT Esher
    Surrey
    EnglandBritishGroup Chief Executive14330100002
    FINKLEMAN, Michael David
    Charlewood
    Manor Crescent, Seer Green
    HP9 2QX Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Charlewood
    Manor Crescent, Seer Green
    HP9 2QX Beaconsfield
    Buckinghamshire
    BritishCompany Director66057660001
    GOIN, Russell Todd
    4 Rue Jadin
    75017
    FOREIGN Paris
    France
    Geschäftsführer
    4 Rue Jadin
    75017
    FOREIGN Paris
    France
    AmericanBanker108675490001
    HERSEY, David Michael
    Greenways
    Ridgeway Hutton Mount
    CM13 2LS Brentwood
    Essex
    Geschäftsführer
    Greenways
    Ridgeway Hutton Mount
    CM13 2LS Brentwood
    Essex
    BritishCompany Director17567250001
    KABALAN, Fadi
    Keyes House
    Dolphin Square
    SW1V 3NA London
    Suite 311
    Geschäftsführer
    Keyes House
    Dolphin Square
    SW1V 3NA London
    Suite 311
    EnglandBritishChartered Accountant133846470001
    KRAIS, Ashley Simon
    74 Marsh Lane
    NW7 4NT London
    Geschäftsführer
    74 Marsh Lane
    NW7 4NT London
    United KingdomBritishCompany Director105921220001
    LE POIDEVIN, Andrew Daryl
    Kinneil
    34 Bulstrode Way
    SL9 7QU Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Kinneil
    34 Bulstrode Way
    SL9 7QU Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    EnglandBritishDirector4958800007
    MAIDEN, George Barry
    Fourwinds Long Walk
    HP8 4AW Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Fourwinds Long Walk
    HP8 4AW Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    BritishAccountant8832120001
    MARCUS, Martin Alan
    17 Monkhams Drive
    IG8 0LG Woodford Green
    Essex
    Geschäftsführer
    17 Monkhams Drive
    IG8 0LG Woodford Green
    Essex
    BritishCompany Director35543430001
    MENARD, Veronique Pascale Dominique
    Goldman Sachs International
    Peterborough Court, 133 Fleet Street
    EC4A 2BB London
    Goldman Sachs International
    England
    Geschäftsführer
    Goldman Sachs International
    Peterborough Court, 133 Fleet Street
    EC4A 2BB London
    Goldman Sachs International
    England
    United KingdomFrenchBanker141156250001
    METCALFE, Michael Stuart
    Harwil 37 Howards Thicket
    SL9 7NT Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Harwil 37 Howards Thicket
    SL9 7NT Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    EnglandBritishCompany Director40294180002
    MOORE, Richard John
    2 Maple Wood
    Bedhampton
    PO9 3JB Havant
    Hampshire
    Geschäftsführer
    2 Maple Wood
    Bedhampton
    PO9 3JB Havant
    Hampshire
    EnglandBritishCompany Director101144680001
    MULAHASANI, Heather Louise
    Goldman Sachs International
    Peterborough Court, 133 Fleet Street
    EC4A 2BB London
    Goldman Sachs International
    Geschäftsführer
    Goldman Sachs International
    Peterborough Court, 133 Fleet Street
    EC4A 2BB London
    Goldman Sachs International
    EnglandBritishBanker136994090001
    OGDEN, Kathryn
    14 Arundel Court
    43-47 Arundel Gardens
    W11 2LP London
    Geschäftsführer
    14 Arundel Court
    43-47 Arundel Gardens
    W11 2LP London
    AmericanAnalyst114248790002
    PORTER, Allan William
    147 Worrin Road
    CM15 8JR Shenfield
    Essex
    Geschäftsführer
    147 Worrin Road
    CM15 8JR Shenfield
    Essex
    BritishChartered Accountant17567090001
    RIECK, Erwin Joseph
    Queens Court
    9-17 Eastern Road
    RM1 3NG Romford
    Queens Court
    Essex
    England
    Geschäftsführer
    Queens Court
    9-17 Eastern Road
    RM1 3NG Romford
    Queens Court
    Essex
    England
    GermanChief Executive Officer108675520002
    ROSENBERG, Matthew Alexander
    Waterhouse Business Park
    2 Cromar Way
    CM1 2QE Chelmsford
    68
    Essex
    England
    Geschäftsführer
    Waterhouse Business Park
    2 Cromar Way
    CM1 2QE Chelmsford
    68
    Essex
    England
    EnglandBritishAsset Manager134723670001
    SCOBLE, Timothy James
    57 Old Road
    Wheatley
    OX33 1NX Oxford
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    57 Old Road
    Wheatley
    OX33 1NX Oxford
    Oxfordshire
    United KingdomBritishDirector83743120001
    W2001 BRITANNIA LLC
    The Corporation Trust Company
    1209 Orange Street
    Wilmington
    The Corporation Trust Company
    County Of Newcastle
    Usa
    Geschäftsführer
    The Corporation Trust Company
    1209 Orange Street
    Wilmington
    The Corporation Trust Company
    County Of Newcastle
    Usa
    RechtsformLIMITED LIABILITY COMPANY
    Art des AusweisesNicht-EWR
    RechtsgrundlageDELAWARE LIMITED LIABILITY COMPANY ACT
    152068200001
    W2001 TWO CV
    Strawinskylaan 1207
    1077 Xx Amsterdam
    Strawinskylaan 1207
    Netherlands
    Geschäftsführer
    Strawinskylaan 1207
    1077 Xx Amsterdam
    Strawinskylaan 1207
    Netherlands
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer34207195
    152068300001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei MOAT HOUSE (CATERERS) LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Waterhouse Business Park
    2 Cromar Way
    CM1 2QE Chelmsford
    Suite 64
    Essex
    England
    06. Apr. 2016
    Waterhouse Business Park
    2 Cromar Way
    CM1 2QE Chelmsford
    Suite 64
    Essex
    England
    Nein
    RechtsformPrivate Company Limited By Shares
    RegistrierungslandUnited Kingdom
    RechtsgrundlageCompanies Act 1985
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer416937
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.

    Hat MOAT HOUSE (CATERERS) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A composite guarantee and debenture
    Erstellt am 23. Feb. 2005
    Geliefert am 04. März 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to the secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Goldman Sachs Credit Partners, L.P.
    Transaktionen
    • 04. März 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Juli 2014Ein Teil des Grundstücks oder Unternehmens wurde freigegeben und ist nicht mehr Teil der Belastung (MR05)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 24. Nov. 2004
    Geliefert am 14. Dez. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to the secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of legal mortgage all estates or interests in the f/h, l/h and other immovable property. By way of fixed charge all estates or interests in any f/h, l/h and other immovable property, all stocks shares debentures bonds notes and loan capital, the goodwill, all copyrights and patents. By way of floating charge the undertaking and all its property assets and rights. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Goldman Sachs Credit Partners, L.P.
    Transaktionen
    • 14. Dez. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. März 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 18. Juni 2004
    Geliefert am 25. Juni 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Law Debenture Trust Coproration PLC
    Transaktionen
    • 25. Juni 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Feb. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental deed to the shepperton legal mortgage
    Erstellt am 08. Juni 2004
    Geliefert am 11. Juni 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor including the company to the security trustee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    L/H property k/a shepperton moat house felix lane walton on thames surrey t/no SY471582 and proceeds of sale and all buildings and trade and other fixtures fixed charge all plant machinery vehicles computers and office and other equipment floating charge all undertaking and all property, assets and rights present and future. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC (As Agent and Security Trustee for the Junior Term Lenders Defined in Theterm Facility Agreement)
    Transaktionen
    • 11. Juni 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Nov. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental deed to the composite guarantee and debenture
    Erstellt am 08. Juni 2004
    Geliefert am 11. Juni 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor including the company to the security trustee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of legal mortgage the legally mortgaged property and sale thereof, by way of fixed charge all stocks, shares, the goodwill and uncalled capital, all copyrights, patents, by way of floating charge the undertaking, all property, assets and rights. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC (As Agent and Security Trustee for the Junior Term Lenders Defined in Theterm Facility Agreement)
    Transaktionen
    • 11. Juni 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Nov. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 25. März 2004
    Geliefert am 26. März 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor including the company to the security trustee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of legal mortgage the legally mortgaged property and sale thereof, by way of fixed charge all stocks, shares, the goodwill and uncalled capital, all copyrights, patents, by way of floating charge the undertaking, all property, assets and rights. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC (As Agent and Security Trustee for the Junior Term Lenders)
    Transaktionen
    • 26. März 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Nov. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 23. Jan. 2004
    Geliefert am 28. Jan. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor (including the company) to any of the secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    L/H property being shepperton moat house, felix lane, walton on thames, surrey t/no. SY471582. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC (As Agent and Security Trustee for the Junior Term Lenders Defined in Theterm Facility Agreement)
    Transaktionen
    • 28. Jan. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Nov. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 01. Juli 1991
    Geliefert am 06. Juli 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Holiday inn great north road seaton burn newcastle upon tyne tyne and wear with buildings and fixtures thereon by way of a assigns the goodwill of the business (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 06. Juli 1991Registrierung einer Belastung
    • 30. Dez. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 29. Dez. 1986
    Geliefert am 16. Jan. 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The dover stage hotel, camden crescent, dover kent and/or the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. Jan. 1987Registrierung einer Belastung
    • 21. Juni 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 29. Dez. 1986
    Geliefert am 16. Jan. 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The grand hotel, colmore row, birmignham, west midlands and/or the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. Jan. 1987Registrierung einer Belastung
    • 01. Dez. 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 06. Nov. 1986
    Geliefert am 24. Nov. 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The property k/a drury lane, moat house, 10 drury lane london WC2 t/no ngl 279811 and ngl 474818 including all buildings now or hereafter to be erected thereon, and all trade and other fixtures, fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Swiss Volksbank
    Transaktionen
    • 24. Nov. 1986Registrierung einer Belastung
    • 18. März 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 08. Okt. 1986
    Geliefert am 24. Okt. 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Telford moat house, foregate telford centre, telford, shropshire, all trade and other fixtures, goodwill, benefit of licences.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 24. Okt. 1986Registrierung einer Belastung
    • 01. Dez. 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 07. Jan. 1986
    Geliefert am 27. Jan. 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Drury lane, moat house, 10 drury lane, high holborn london. WC2B 5RE.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 27. Jan. 1986Registrierung einer Belastung
    Legal mortgage
    Erstellt am 31. Okt. 1983
    Geliefert am 02. Nov. 1983
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land & buildings situate at belmont road, hereford known as the hereford moat house title no HW27333.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Lombard & Ulster Limited
    Transaktionen
    • 02. Nov. 1983Registrierung einer Belastung
    Legal mortgage
    Erstellt am 19. Apr. 1982
    Geliefert am 29. Apr. 1982
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/Hold property 80 bootham, yorks.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 29. Apr. 1982Registrierung einer Belastung
    • 01. Dez. 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 19. Apr. 1982
    Geliefert am 28. Apr. 1982
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/Hold property rose & crown inn, harnham road, harnham, near salisbury, wiltshire.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 28. Apr. 1982Registrierung einer Belastung
    Legal mortgage
    Erstellt am 19. Apr. 1982
    Geliefert am 28. Apr. 1982
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/Hold property 35 and 37 harnham road, east harnham, salisbury, wiltshire.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 28. Apr. 1982Registrierung einer Belastung
    Legal mortgage
    Erstellt am 19. Apr. 1982
    Geliefert am 28. Apr. 1982
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Epping forest lodge (formely epping foreest motel) high street, epping essex CM1 4AL. Title no. Ex 237108.. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 28. Apr. 1982Registrierung einer Belastung
    Legal mortgage
    Erstellt am 19. Apr. 1982
    Geliefert am 28. Apr. 1982
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Europa lodge hotel, hinckley road, leicester, forest east blaby leicester title no lt 110788. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 28. Apr. 1982Registrierung einer Belastung
    Legal mortgage
    Erstellt am 19. Apr. 1982
    Geliefert am 28. Apr. 1982
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Westone hotel, weston favell, northampton. Title no. Nn 52384. f/hold property coachmans house and part of westone hotel, weston favell, northampton.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 28. Apr. 1982Registrierung einer Belastung
    Legal mortgage
    Erstellt am 19. Apr. 1982
    Geliefert am 28. Apr. 1982
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/Hold property 45 park drive, leicester forest east, leicester.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 28. Apr. 1982Registrierung einer Belastung
    • 24. Mai 1984Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 19. Apr. 1982
    Geliefert am 28. Apr. 1982
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Oxford europa lodge, wolvercote roundabant. Oxford title no. On 15968. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 28. Apr. 1982Registrierung einer Belastung
    Legal mortgage
    Erstellt am 19. Apr. 1982
    Geliefert am 28. Apr. 1982
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    314 banbury road, oxford. Title no on 8860.. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 28. Apr. 1982Registrierung einer Belastung
    Legal mortgage
    Erstellt am 19. Apr. 1982
    Geliefert am 28. Apr. 1982
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Car parts adjoining viking hotel, yorks, north yorkshire. Title no. Nyk 12585 f/hold property viking hotel. North street, yorks.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 28. Apr. 1982Registrierung einer Belastung
    • 01. Dez. 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 19. Apr. 1982
    Geliefert am 28. Apr. 1982
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Leasehold 4 chapel street, stratford upon avon, warwick. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 28. Apr. 1982Registrierung einer Belastung

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0