MOAT HOUSE (CATERERS) LIMITED
Überblick
Unternehmensname | MOAT HOUSE (CATERERS) LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 01043175 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von MOAT HOUSE (CATERERS) LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich MOAT HOUSE (CATERERS) LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Suite 64 Waterhouse Business Park 2 Cromar Way CM1 2QE Chelmsford Essex England |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MOAT HOUSE (CATERERS) LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2015 |
Welche sind die letzten Einreichungen für MOAT HOUSE (CATERERS) LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 13. Juni 2017 mit Aktualisierungen | 6 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 19 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 09. Juni 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Sally Ann Coughlan am 02. Jan. 2016 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 68 Waterhouse Business Park 2 Cromar Way Chelmsford Essex CM1 2QE zum Suite 64 Waterhouse Business Park 2 Cromar Way Chelmsford Essex CM1 2QE am 07. Dez. 2015 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 16 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Matthew Alexander Rosenberg als Geschäftsführer am 06. Juli 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Martin Quinn als Direktor am 06. Juli 2015 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 09. Juni 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Matthew Alexander Rosenberg am 23. Sept. 2014 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Sally Ann Coughlan am 02. Okt. 2014 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 19 Seiten | AA | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Queens Court 9-17 Eastern Road Romford Essex RM1 3NG zum 68 Waterhouse Business Park 2 Cromar Way Chelmsford Essex CM1 2QE am 29. Sept. 2014 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ein Teil des Eigentums oder Unternehmens wurde entlassen und ist nicht mehr Teil der Belastung 29 | 14 Seiten | MR05 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 09. Juni 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Erwin Rieck als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 22 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 09. Juni 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von W2001 Two Cv als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von W2001 Britannia Llc als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 19 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 09. Juni 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von MOAT HOUSE (CATERERS) LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUGHLAN, Sally Ann | Sekretär | Waterhouse Business Park 2 Cromar Way CM1 2QE Chelmsford Suite 64 Essex England | British | 107832420001 | ||||||||||||
QUINN, Martin Joseph | Geschäftsführer | 34 Francis Grove, Wimbledon SW19 4DT London Westmont Management Limited England | England | Irish | Asset Manager | 186571310001 | ||||||||||
BURGESS, Keith John | Sekretär | 3 Queen Annes Gate White House Walk GU9 9AN Farnham Surrey | British | 7009790002 | ||||||||||||
CHRISTIAN, Tracy Joanne | Sekretär | 19 Lovell Walk RM13 7ND Rainham Essex | British | 102667300001 | ||||||||||||
JONES, Vanessa | Sekretär | Stables House Castle Hill RH1 4LB Bletchingley Surrey | British | 72146200001 | ||||||||||||
PURVIS, Martin Terence Alan | Sekretär | Fenetters Melfort Road TN6 1QT Crowborough East Sussex | British | 7901050001 | ||||||||||||
WALLER, Ronald John | Sekretär | Brindles 118 Hanging Hill Lane CM13 2HN Brentwood Essex | British | 1210620001 | ||||||||||||
WATERS, Jonathan Roy | Sekretär | Maldon Road CO3 3BQ Colchester 237 Essex | British | 129848360001 | ||||||||||||
ALLSOP, Heather Louise | Geschäftsführer | 62 Prebend Street N1 8PS London | British | Investment Banker | 101912850001 | |||||||||||
BAIRSTOW, John | Geschäftsführer | Frieze Cottage Coxtie Green Road South Weald CM14 5RE Brentwood Essex | British | Company Director | 537400001 | |||||||||||
BELL, Gerald James | Geschäftsführer | Cavewood Rectory Lane Datchworth SG3 6RD Knebworth Hertfordshire | British | Company Director | 47018930002 | |||||||||||
BOULD, Andrew Robin Douglas | Geschäftsführer | 508 Uxbridge Road HA5 4SG Pinner Middlesex | British | Company Director | 36875610001 | |||||||||||
CAIRNS, Michael Anthony | Geschäftsführer | Birchlands Old Avenue KT13 0PY Weybridge Surrey | United Kingdom | British | Company Director | 36488470001 | ||||||||||
COLES, Alan Clifford | Geschäftsführer | The Knoll Grendon NN7 1JG Northampton Beeches, 5 Northamptonshire | England | British | Chartered Accountant | 101144900002 | ||||||||||
COLLYER, Brian Charles | Geschäftsführer | 49 Route De Croissy 78110 Le Vesinet France | Canadian | Investment Banker | 101144260001 | |||||||||||
COPPEL, Andrew Maxwell | Geschäftsführer | Orchard House 8 Claremont Park Road KT10 9LT Esher Surrey | England | British | Group Chief Executive | 14330100002 | ||||||||||
FINKLEMAN, Michael David | Geschäftsführer | Charlewood Manor Crescent, Seer Green HP9 2QX Beaconsfield Buckinghamshire | British | Company Director | 66057660001 | |||||||||||
GOIN, Russell Todd | Geschäftsführer | 4 Rue Jadin 75017 FOREIGN Paris France | American | Banker | 108675490001 | |||||||||||
HERSEY, David Michael | Geschäftsführer | Greenways Ridgeway Hutton Mount CM13 2LS Brentwood Essex | British | Company Director | 17567250001 | |||||||||||
KABALAN, Fadi | Geschäftsführer | Keyes House Dolphin Square SW1V 3NA London Suite 311 | England | British | Chartered Accountant | 133846470001 | ||||||||||
KRAIS, Ashley Simon | Geschäftsführer | 74 Marsh Lane NW7 4NT London | United Kingdom | British | Company Director | 105921220001 | ||||||||||
LE POIDEVIN, Andrew Daryl | Geschäftsführer | Kinneil 34 Bulstrode Way SL9 7QU Gerrards Cross Buckinghamshire | England | British | Director | 4958800007 | ||||||||||
MAIDEN, George Barry | Geschäftsführer | Fourwinds Long Walk HP8 4AW Chalfont St Giles Buckinghamshire | British | Accountant | 8832120001 | |||||||||||
MARCUS, Martin Alan | Geschäftsführer | 17 Monkhams Drive IG8 0LG Woodford Green Essex | British | Company Director | 35543430001 | |||||||||||
MENARD, Veronique Pascale Dominique | Geschäftsführer | Goldman Sachs International Peterborough Court, 133 Fleet Street EC4A 2BB London Goldman Sachs International England | United Kingdom | French | Banker | 141156250001 | ||||||||||
METCALFE, Michael Stuart | Geschäftsführer | Harwil 37 Howards Thicket SL9 7NT Gerrards Cross Buckinghamshire | England | British | Company Director | 40294180002 | ||||||||||
MOORE, Richard John | Geschäftsführer | 2 Maple Wood Bedhampton PO9 3JB Havant Hampshire | England | British | Company Director | 101144680001 | ||||||||||
MULAHASANI, Heather Louise | Geschäftsführer | Goldman Sachs International Peterborough Court, 133 Fleet Street EC4A 2BB London Goldman Sachs International | England | British | Banker | 136994090001 | ||||||||||
OGDEN, Kathryn | Geschäftsführer | 14 Arundel Court 43-47 Arundel Gardens W11 2LP London | American | Analyst | 114248790002 | |||||||||||
PORTER, Allan William | Geschäftsführer | 147 Worrin Road CM15 8JR Shenfield Essex | British | Chartered Accountant | 17567090001 | |||||||||||
RIECK, Erwin Joseph | Geschäftsführer | Queens Court 9-17 Eastern Road RM1 3NG Romford Queens Court Essex England | German | Chief Executive Officer | 108675520002 | |||||||||||
ROSENBERG, Matthew Alexander | Geschäftsführer | Waterhouse Business Park 2 Cromar Way CM1 2QE Chelmsford 68 Essex England | England | British | Asset Manager | 134723670001 | ||||||||||
SCOBLE, Timothy James | Geschäftsführer | 57 Old Road Wheatley OX33 1NX Oxford Oxfordshire | United Kingdom | British | Director | 83743120001 | ||||||||||
W2001 BRITANNIA LLC | Geschäftsführer | The Corporation Trust Company 1209 Orange Street Wilmington The Corporation Trust Company County Of Newcastle Usa |
| 152068200001 | ||||||||||||
W2001 TWO CV | Geschäftsführer | Strawinskylaan 1207 1077 Xx Amsterdam Strawinskylaan 1207 Netherlands |
| 152068300001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei MOAT HOUSE (CATERERS) LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qmh Limited | 06. Apr. 2016 | Waterhouse Business Park 2 Cromar Way CM1 2QE Chelmsford Suite 64 Essex England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat MOAT HOUSE (CATERERS) LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
A composite guarantee and debenture | Erstellt am 23. Feb. 2005 Geliefert am 04. März 2005 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to the secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Composite guarantee and debenture | Erstellt am 24. Nov. 2004 Geliefert am 14. Dez. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to the secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of legal mortgage all estates or interests in the f/h, l/h and other immovable property. By way of fixed charge all estates or interests in any f/h, l/h and other immovable property, all stocks shares debentures bonds notes and loan capital, the goodwill, all copyrights and patents. By way of floating charge the undertaking and all its property assets and rights. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 18. Juni 2004 Geliefert am 25. Juni 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Supplemental deed to the shepperton legal mortgage | Erstellt am 08. Juni 2004 Geliefert am 11. Juni 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor including the company to the security trustee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben L/H property k/a shepperton moat house felix lane walton on thames surrey t/no SY471582 and proceeds of sale and all buildings and trade and other fixtures fixed charge all plant machinery vehicles computers and office and other equipment floating charge all undertaking and all property, assets and rights present and future. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Supplemental deed to the composite guarantee and debenture | Erstellt am 08. Juni 2004 Geliefert am 11. Juni 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor including the company to the security trustee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of legal mortgage the legally mortgaged property and sale thereof, by way of fixed charge all stocks, shares, the goodwill and uncalled capital, all copyrights, patents, by way of floating charge the undertaking, all property, assets and rights. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Composite guarantee and debenture | Erstellt am 25. März 2004 Geliefert am 26. März 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor including the company to the security trustee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of legal mortgage the legally mortgaged property and sale thereof, by way of fixed charge all stocks, shares, the goodwill and uncalled capital, all copyrights, patents, by way of floating charge the undertaking, all property, assets and rights. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 23. Jan. 2004 Geliefert am 28. Jan. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor (including the company) to any of the secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben L/H property being shepperton moat house, felix lane, walton on thames, surrey t/no. SY471582. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage | Erstellt am 01. Juli 1991 Geliefert am 06. Juli 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Holiday inn great north road seaton burn newcastle upon tyne tyne and wear with buildings and fixtures thereon by way of a assigns the goodwill of the business (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 29. Dez. 1986 Geliefert am 16. Jan. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The dover stage hotel, camden crescent, dover kent and/or the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 29. Dez. 1986 Geliefert am 16. Jan. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The grand hotel, colmore row, birmignham, west midlands and/or the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 06. Nov. 1986 Geliefert am 24. Nov. 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The property k/a drury lane, moat house, 10 drury lane london WC2 t/no ngl 279811 and ngl 474818 including all buildings now or hereafter to be erected thereon, and all trade and other fixtures, fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 08. Okt. 1986 Geliefert am 24. Okt. 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Telford moat house, foregate telford centre, telford, shropshire, all trade and other fixtures, goodwill, benefit of licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 07. Jan. 1986 Geliefert am 27. Jan. 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Drury lane, moat house, 10 drury lane, high holborn london. WC2B 5RE. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 31. Okt. 1983 Geliefert am 02. Nov. 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H land & buildings situate at belmont road, hereford known as the hereford moat house title no HW27333.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 19. Apr. 1982 Geliefert am 29. Apr. 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/Hold property 80 bootham, yorks.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 19. Apr. 1982 Geliefert am 28. Apr. 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/Hold property rose & crown inn, harnham road, harnham, near salisbury, wiltshire.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 19. Apr. 1982 Geliefert am 28. Apr. 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/Hold property 35 and 37 harnham road, east harnham, salisbury, wiltshire.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 19. Apr. 1982 Geliefert am 28. Apr. 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Epping forest lodge (formely epping foreest motel) high street, epping essex CM1 4AL. Title no. Ex 237108.. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 19. Apr. 1982 Geliefert am 28. Apr. 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Europa lodge hotel, hinckley road, leicester, forest east blaby leicester title no lt 110788. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 19. Apr. 1982 Geliefert am 28. Apr. 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Westone hotel, weston favell, northampton. Title no. Nn 52384. f/hold property coachmans house and part of westone hotel, weston favell, northampton.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 19. Apr. 1982 Geliefert am 28. Apr. 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/Hold property 45 park drive, leicester forest east, leicester.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 19. Apr. 1982 Geliefert am 28. Apr. 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Oxford europa lodge, wolvercote roundabant. Oxford title no. On 15968. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 19. Apr. 1982 Geliefert am 28. Apr. 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 314 banbury road, oxford. Title no on 8860.. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 19. Apr. 1982 Geliefert am 28. Apr. 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Car parts adjoining viking hotel, yorks, north yorkshire. Title no. Nyk 12585 f/hold property viking hotel. North street, yorks.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 19. Apr. 1982 Geliefert am 28. Apr. 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Leasehold 4 chapel street, stratford upon avon, warwick. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0