TOREX RETAIL ONLINE COMPUTER SERVICES LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | TOREX RETAIL ONLINE COMPUTER SERVICES LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01044892 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von TOREX RETAIL ONLINE COMPUTER SERVICES LIMITED?
- (7499) /
Wo befindet sich TOREX RETAIL ONLINE COMPUTER SERVICES LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | BENEDICT MACKENZIE 62 Wilson Street EC2A 2BU London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von TOREX RETAIL ONLINE COMPUTER SERVICES LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| ALPHAMERIC ONLINE COMPUTER SERVICES LIMITED | 11. Juni 2002 | 11. Juni 2002 |
| ALPHAMERIC SOLUTIONS LIMITED | 01. März 1996 | 01. März 1996 |
| ALPHAMERIC KEYBOARDS LIMITED | 06. März 1972 | 06. März 1972 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von TOREX RETAIL ONLINE COMPUTER SERVICES LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Juni 2007 |
Welche sind die letzten Einreichungen für TOREX RETAIL ONLINE COMPUTER SERVICES LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 3 Seiten | 4.71 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 10. Sept. 2009 | 5 Seiten | 4.68 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 190 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 353 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2007 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 225 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von TOREX RETAIL ONLINE COMPUTER SERVICES LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COOKSLEY, Graeme Roy | Sekretär | Chamer Russweg 19 6300 Zug Switzerland | New Zealander | 126903810001 | ||||||
| ISAACSON, Kirk Jeffrey, Mr. | Geschäftsführer | 1110 Fox Glen Drive St Charles Illinois 60174 Usa | Usa | Other | 123425810001 | |||||
| HORN, Nigel David | Sekretär | Featherbow House Ratley OX15 6DS Banbury Oxfordshire | British | 109926660001 | ||||||
| ISAACSON, Kirk Jeffrey, Mr. | Sekretär | 1110 Fox Glen Drive St Charles Illinois 60174 Usa | Other | 123425810001 | ||||||
| JOHNSON, Robin Simon | Sekretär | 25 Thirlmere Road Muswell Hill N10 2DL London | British | 11498320001 | ||||||
| JOHNSTON, John William | Sekretär | Alremans Wylye Road Hanging Langford SP3 4NN Salisbury Wiltshire | British | 57851480001 | ||||||
| LEEK, Marcus | Sekretär | 7 Gloster Drive CV8 2TU Kenilworth Warwickshire | British | 115960470001 | ||||||
| MINIKIN, Claire Louise | Sekretär | Dunholme Manor Close KT24 6SA East Horsley Surrey | British | 77770730001 | ||||||
| OLLIS, Stephen Anthony | Sekretär | Cornerways 41 Sangers Drive RH6 8AL Horley Surrey | British | 64363660001 | ||||||
| SOULSBY, James Andrew | Sekretär | Bramshott Lodge Woolmer Hill GU27 1QA Haslemere Surrey | British | 38342300002 | ||||||
| WARRINGTON, Lorri | Sekretär | Applecroft Plaistow Road Ifold RH14 0TU Billingshurst West Sussex | British | 84757210001 | ||||||
| BLACKBURNE, Geoffrey Robert | Geschäftsführer | 14 Wheatears Drive West Wellow SO51 6RA Romsey Hampshire | British | 39171140001 | ||||||
| CANNING, Philip Francis | Geschäftsführer | 63 Ivar Gardens Lychpit RG24 8YD Basingstoke Hampshire | British | 34793910001 | ||||||
| CANNING, Phillip Francis | Geschäftsführer | Roeside Bradshaw Lane, Chapel En Le Frith SK23 9UL High Peak Derbyshire | British | 70379550001 | ||||||
| COOKSLEY, Graeme | Geschäftsführer | 19 Charmer Fussweg Zug 6300 Switzerland | New Zealander | 122786180001 | ||||||
| EVANS, David Victor | Geschäftsführer | Whiteside 99 Hatch Lane Old Basing RG24 7EG Basingstoke Hampshire | British | 6221420001 | ||||||
| GREENOUGH, Michael | Geschäftsführer | 711 Pintail Court Granbury Texas 76049 Usa | Canadian | 123427350001 | ||||||
| HORN, Nigel David | Geschäftsführer | Featherbow House Ratley OX15 6DS Banbury Oxfordshire | British | 109926660001 | ||||||
| HORNSTEIN, Rodney Maxwell | Geschäftsführer | 40 Fairfax Road NW6 4HA London | England | British | 4322180001 | |||||
| JOHNSTON, David James | Geschäftsführer | 33 Frensham Vale Lower Bourne GU10 3HS Farnham Surrey | England | British | 76164390001 | |||||
| JOHNSTON, John William | Geschäftsführer | Alremans Wylye Road Hanging Langford SP3 4NN Salisbury Wiltshire | British | 57851480001 | ||||||
| LEEK, Marcus | Geschäftsführer | 7 Gloster Drive CV8 2TU Kenilworth Warwickshire | British | 115960470001 | ||||||
| MCLAREN, Michael Gerald | Geschäftsführer | October House 4 The Mount Drive RH2 0EZ Reigate Surrey | England | British | 68561640002 | |||||
| MEADE, Michael Gerald | Geschäftsführer | 54 Clapham Common North Side SW4 9RX London | England | British,Irish | 142059750001 | |||||
| MINIKIN, Claire Louise | Geschäftsführer | Dunholme Manor Close KT24 6SA East Horsley Surrey | British | 77770730001 | ||||||
| MITCHELL, Robert Neil Whyte | Geschäftsführer | 50 Leckford Road Jericho OX2 6HY Oxford Oxfordshire | British | 116745740001 | ||||||
| MORCOMBE, Alan William | Geschäftsführer | Waverley House Kitcombe Wood GU34 3ND Faringdon Hampshire | British | 32807230004 | ||||||
| PEARMAN, Mark Chalice | Geschäftsführer | The Old Rectory Honiley CV8 1NP Kenilworth Warwickshire | United Kingdom | British | 57516220003 | |||||
| PRINCE, Ian Robert | Geschäftsführer | Underley Lodge Horsell Park GU21 4LY Woking Surrey | British | 29848090001 | ||||||
| PRINCE, Peter | Geschäftsführer | 8 The Chase SL5 7UJ Ascot Berkshire | United States Of America | British | 125228870001 | |||||
| RANDALL, Martin Keith | Geschäftsführer | Jacks Platt Duddleswell TN22 3JR Uckfield East Sussex | United Kingdom | British | 40012240002 | |||||
| SMITH, Kenneth Ronald | Geschäftsführer | Telconia Close Headley Down GU35 8ED Bordon 7 Hampshire | United Kingdom | British | 34793900002 | |||||
| SMITH, Kenneth Ronald | Geschäftsführer | Telconia Close Headley Down GU35 8ED Bordon 7 Hampshire | United Kingdom | British | 34793900002 | |||||
| TAYLOR, Keith Wilhall | Geschäftsführer | Dove Cottage Sly Corner Lee Common HP16 9LD Great Missenden Bucks | England | British | 119095470001 | |||||
| THOMPSON, Richard James | Geschäftsführer | 19 Fairfields Drive Ravenshead NG15 9HR Nottingham Nottinghamshire | England | British | 64550460002 |
Hat TOREX RETAIL ONLINE COMPUTER SERVICES LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Fixed charge | Erstellt am 26. Feb. 1991 Geliefert am 05. März 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All property rights in letters patent/trade mark/name with associated goodwill (please see doc 395 tc ref 353C for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating charge | Erstellt am 16. Mai 1989 Geliefert am 24. Mai 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben First fixed charge on all book and other debts. Floating charge on all the. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Assignment | Erstellt am 29. Feb. 1984 Geliefert am 13. März 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a hire purchase agreement dated 29/02/84 | |
Kurze Angaben All rights and interest in the lease dated 29/2/84 together with all monies now or hereafter to become payable under the lease and tog. With the benefit of all guarantees indemnities negotiable instruments and securities taken by the company in connection with lease. (See doc. M23). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge | Erstellt am 13. Jan. 1984 Geliefert am 19. Jan. 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All book and other debts now & from time to time owing to the company. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Letter of instruction and charge. | Erstellt am 04. Dez. 1979 Geliefert am 11. Dez. 1979 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All and any sums of money owing or becoming due to the company from griffin factors limited under or by virtue of a factoring agreement executed by the company on 12 march 1979 or any other factoring agreement between the company and griffin factors limited. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Floating charge | Erstellt am 20. März 1979 Geliefert am 22. März 1979 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a factoring agreement dated 12 march 1979. | |
Kurze Angaben Floating charge over undertaking and all property present and future including uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat TOREX RETAIL ONLINE COMPUTER SERVICES LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0