WIBL RUNOFF LIMITED
Überblick
Unternehmensname | WIBL RUNOFF LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 01048591 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von WIBL RUNOFF LIMITED?
- Tätigkeit von Versicherungsvertretern und -maklern (66220) / Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
Wo befindet sich WIBL RUNOFF LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Frp Advisory Llp Kings Orchard 1 Queen Street BS2 0HQ Bristol |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von WIBL RUNOFF LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
WINDSOR INSURANCE BROKERS LIMITED | 02. Okt. 1987 | 02. Okt. 1987 |
S.W.TAYLOR & CO. LIMITED | 21. Feb. 1985 | 21. Feb. 1985 |
S.W.TAYLOR AND COMPANY(BROKERS)LIMITED | 06. Apr. 1972 | 06. Apr. 1972 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von WIBL RUNOFF LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Sept. 2017 |
Welche sind die letzten Einreichungen für WIBL RUNOFF LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 8 Seiten | LIQ13 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 28. Nov. 2022 | 7 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 28. Nov. 2021 | 6 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 28. Nov. 2020 | 6 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 28. Nov. 2019 | 6 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 5 Seiten | LIQ01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 16 Eastcheap London EC3M 1BD United Kingdom zum Frp Advisory Llp Kings Orchard 1 Queen Street Bristol BS2 0HQ am 21. Jan. 2019 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 13. Nov. 2018
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Andrew Timothy Bastow als Geschäftsführer am 17. Okt. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr William David Bloomer als Direktor am 17. Okt. 2018 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Angus Kenneth Cameron als Geschäftsführer am 17. Okt. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 28. Sept. 2018 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 3 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2017 | 23 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 29. Sept. 2017 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Angus Kenneth Cameron am 19. Juli 2017 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Withdrawal of a person with significant control statement on 26. Sept. 2017 | 2 Seiten | PSC09 | ||||||||||
Notification of Ostrakon Capital (2) Limited as a person with significant control on 06. Apr. 2016 | 2 Seiten | PSC02 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr William David Bloomer am 19. Aug. 2016 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von WIBL RUNOFF LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOORE, Andrew John | Sekretär | 1 Queen Street BS2 0HQ Bristol Frp Advisory Llp Kings Orchard | 215225040001 | |||||||||||
BLOOMER, William David | Geschäftsführer | 1 Queen Street BS2 0HQ Bristol Frp Advisory Llp Kings Orchard | United Kingdom | British | Solicitor | 214179860001 | ||||||||
BEARRYMAN, David John | Sekretär | Fenchurch Street EC3M 4BS London 71 England | 161661640001 | |||||||||||
BEARRYMAN, David John | Sekretär | 2 Norman Avenue KT17 3AB Epsom Surrey | British | 58767780002 | ||||||||||
BLAKE, Matt | Sekretär | Eastcheap EC3M 1BD London 16 United Kingdom | 192167350001 | |||||||||||
BODENHAM, Andrew John | Sekretär | 4 Cadogan Gardens TN1 2UL Tunbridge Wells Kent | British | 31364500002 | ||||||||||
HASLER, Brian Edward | Sekretär | 2 Orchard Way Hurst Green RH8 9DJ Oxted Surrey | British | 2762180001 | ||||||||||
HALCO SECRETARIES LIMITED | Sekretär | Fleet Place EC4M 7RD London 5 England |
| 146855460001 | ||||||||||
ANDERSON, David Grant | Geschäftsführer | Garden Flat 52 Fellows Road NW3 3LG London | England | British | Insurance Broker | 71257520001 | ||||||||
BAKER, David Robert | Geschäftsführer | Fairleigh 6 North Hermitage SY3 7JW Shrewsbury Salop | British | Accountant | 3592210001 | |||||||||
BASTABLE, Kevin George | Geschäftsführer | 47 Sylvia Court Wenlock Barn Estate N1 7PE London | British | Insurance Broker | 89918500001 | |||||||||
BASTOW, Andrew Timothy | Geschäftsführer | Eastcheap EC3M 1BD London 16 United Kingdom | United Kingdom | British | Head Of Compliance And Risk | 197611070001 | ||||||||
BELL, Malcolm Rennison | Geschäftsführer | Wren Cottage 313a Petersham Road Ham TW10 7DB Richmond Surrey | British | Insurance Broker | 38020090001 | |||||||||
BENNETT, John Duncan Irvine | Geschäftsführer | Coram Street Farm IP7 5NE Hadleigh Suffolk | United Kingdom | British | Insurance Broker | 82156080001 | ||||||||
BIRTWISTLE, Ian Michael | Geschäftsführer | 2 Church Meadow Greenfield OL3 7LY Oldham | United Kingdom | British | Insurance Broker | 142497640001 | ||||||||
BLOOMER, William David | Geschäftsführer | Eastcheap EC3M 1BD London 16 United Kingdom | United Kingdom | British | Solicitor | 214179860001 | ||||||||
BURTON, Christopher John | Geschäftsführer | 9 Gables Avenue WD6 4SP Borehamwood Hertfordshire | British | Accountant | 2382240001 | |||||||||
CAMERON, Angus Kenneth | Geschäftsführer | Eastcheap EC3M 1BD London 16 United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 220169380001 | ||||||||
CLIFTON, John Edward Graham | Geschäftsführer | 32 Gypsy Lane Great Amwell SG12 9RN Ware Hertfordshire | British | Insurance Broker | 59277640001 | |||||||||
COOK, Brian Arthur | Geschäftsführer | 6 St Marys Drive Riverhead TN13 2AR Sevenoaks Kent | British | Insurance Broker | 29458790001 | |||||||||
CROCKER, Nicholas Peter | Geschäftsführer | 11 Saint Johns Road CM24 8JP Stansted Essex | British | Insurance Broker | 76461100001 | |||||||||
EAGLES, Michael David | Geschäftsführer | 25 Upbrook Mews W2 3HG London | British | Insurance Broker | 7514420001 | |||||||||
EARLE, Charles Henry Diccon | Geschäftsführer | 1 Riseholme Seven Hills Road KT11 1ES Cobham Surrey | British | Insurance Broker | 52208160001 | |||||||||
EVANS, Christopher Peter Richard | Geschäftsführer | Neuadd Felingwm Uchaf SA32 7QD Carmarthen Carmarthenshire | British | Insurance Broker | 98066500001 | |||||||||
FAUX, Graham Alan | Geschäftsführer | Fenchurch Street EC3M 4BS London 71 England | England | British | Finance Director | 125907390001 | ||||||||
GAMMELL, Thomas Francis | Geschäftsführer | 11 Royal Oak Lane SG5 3QT Pirton Hertfordshire | British | Insurance Executive | 78551000001 | |||||||||
HARRISON, Bryan | Geschäftsführer | Flat 5 9 Paddington Street Marylebone W1M 3LA London | British | Insurance Broker | 29458810005 | |||||||||
KELLY, Richard Paul | Geschäftsführer | 32 Larkfield KT11 1DE Cobham Surrey | United Kingdom | British | Insurance Broker | 142497600001 | ||||||||
LAKEY, Simon John | Geschäftsführer | 8 Waldegrave Gardens RM14 1UR Upminster Essex | England | British | Insurance Broker | 11860990002 | ||||||||
LANKESTER, Simon Francis | Geschäftsführer | Melvill House Newdigate Road Beare Green RH5 4QD Dorking Surrey | British | Insurance Broker | 5149180001 | |||||||||
LOW, David Hamilton | Geschäftsführer | 1 Sparkes Cottages Graham Terrace SW1W 8HW Belgravia London | United Kingdom | British | Insurance Broker | 14050600003 | ||||||||
LOWE, Jeremy Mark Kisdon | Geschäftsführer | 12 Bramble Way Leavenheath CO6 4UN Colchester Essex | British | Insurance Broker | 31522370001 | |||||||||
LUSHER, Simon John | Geschäftsführer | Newlands Mill Vue Road CM2 6NP Chelmsford Essex | British | Insurance Broker | 36156500001 | |||||||||
MAJOR, Roger Stephen | Geschäftsführer | Barclay Ashford Road TN26 3LT High Halden Kent | British | Reinsurance Broker | 39179300001 | |||||||||
MCKIM, Michael John | Geschäftsführer | Kine House 35 Hartshead Lane Hartshead WF15 8AL Liversedge West Yorkshire | British | Insurance Broker | 25443180002 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei WIBL RUNOFF LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ostrakon Capital (2) Limited | 06. Apr. 2016 | Eastcheap EC3M 1BD London 16 United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Wie lauten die letzten Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss für WIBL RUNOFF LIMITED?
Benachrichtigt am | Aufgehört am | Erklärung |
---|---|---|
12. Juli 2016 | 12. Juli 2016 | Das Unternehmen hat die erforderlichen Schritte zur Ermittlung, ob eine Person eine registrierungspflichtige Person oder eine registrierungspflichtige relevante juristische Person in Bezug auf das Unternehmen ist, noch nicht abgeschlossen. |
Hat WIBL RUNOFF LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Erstellt am 17. Dez. 2009 Geliefert am 21. Dez. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due by each obligor to the chargee on any account whatsover under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 31. Aug. 2007 Geliefert am 14. Sept. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or any other obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 31. Aug. 2007 Geliefert am 12. Sept. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or any other obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, book debts, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Guarantee & debenture | Erstellt am 25. Juli 2006 Geliefert am 01. Aug. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Guarantee & debenture | Erstellt am 15. Jan. 2003 Geliefert am 30. Jan. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of variation made in addition to and modifying the security and trust deed dated 31ST august 1989 as modified by a deed of variation dated 26TH november 1993,the deeds being made pursuant to the lloyd's brokers byelaw (no.5 Of 1988) | Erstellt am 15. Okt. 1999 Geliefert am 04. Nov. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag The payment of all costs charges expenses and other liabilities properly incurred by lloyd's it's delegates or agents or any receiver appointed under the security and trust deed or otherwise in relation thereto and the payment of all debts due owing or incurred in repect of insurance transactions | |
Kurze Angaben All monies for the time being standing to the credit of or pursuant to the byelaw or otherwise acquired to be paid into an insurance broking account of the company please refer to form 395 for full details. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed | Erstellt am 23. Dez. 1993 Geliefert am 11. Jan. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee or its agents or any receiver under the deeds dated 31ST august 1989 and 23RD december 1993 and the insurance transactions (as defined) | |
Kurze Angaben All cash and other assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Security and trust deed | Erstellt am 31. Aug. 1989 Geliefert am 11. Sept. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Kurze Angaben All monies (including brokerage) for the time being standing to the credit of or pursuant to lloyd's brokers byelaw (no 5 of 1988). (see form 395 for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Trust deed | Erstellt am 21. Feb. 1983 Geliefert am 23. Feb. 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All that company's right title & interest in the monies standing to the credit of the company's 'c' a/C. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Hat WIBL RUNOFF LIMITED Insolvenzverfahren?
Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0