MORGAM NEWS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | MORGAM NEWS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01048796 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von MORGAM NEWS LIMITED?
- Andere Dienstleistungen n.a. (96090) / Sonstige Dienstleistungsbereiche
Wo befindet sich MORGAM NEWS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 1 More London Place SE1 2AF London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von MORGAM NEWS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| MORGAM NEWSAGENCY SERVICES LIMITED | 07. Apr. 1972 | 07. Apr. 1972 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MORGAM NEWS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 24. Feb. 2018 |
Welche sind die letzten Einreichungen für MORGAM NEWS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 12 Seiten | LIQ13 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 21. Feb. 2020 | 10 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse Tesco House Shire Park Kestrel Way Welwyn Garden City AL7 1GA verlegt | 2 Seiten | AD03 | ||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde vom Tesco House Shire Park Kestrel Way Welwyn Garden City AL7 1GA United Kingdom zum Tesco House Shire Park Kestrel Way Welwyn Garden City AL7 1GA geändert | 2 Seiten | AD02 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Apex Road Brownhills Walsall West Midlands WS8 7HU United Kingdom zum 1 More London Place London SE1 2AF am 15. März 2019 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 6 Seiten | LIQ01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Steven Blair als Geschäftsführer am 08. Feb. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Jonny Mcquarrie als Geschäftsführer am 08. Feb. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Tracey Clements als Geschäftsführer am 08. Feb. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Robert John Welch als Direktor am 08. Feb. 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Tesco Services Limited als Geschäftsführer am 08. Feb. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 12. Okt. 2018 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 24. Feb. 2018 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Cessation of Morgam Holdings Limited as a person with significant control on 20. Dez. 2017 | 1 Seiten | PSC07 | ||||||||||
Notification of One Stop Stores Limited as a person with significant control on 20. Dez. 2017 | 2 Seiten | PSC02 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 25. Feb. 2017 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Steven Blair als Direktor am 17. Okt. 2017 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Jonny Mcquarrie als Direktor am 17. Okt. 2017 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 12. Okt. 2017 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Ernennung von Mrs Tracey Clements als Direktor am 31. Aug. 2017 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Tesco Services Limited als Direktor am 31. Aug. 2017 | 2 Seiten | AP02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Tracey Clements als Geschäftsführer am 22. Feb. 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von MORGAM NEWS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVERITT, Mark Edward | Sekretär | More London Place SE1 2AF London 1 | 160903270001 | |||||||||||
| EVERITT, Mark Edward | Geschäftsführer | More London Place SE1 2AF London 1 | United Kingdom | British | 107529830027 | |||||||||
| WELCH, Robert John | Geschäftsführer | More London Place SE1 2AF London 1 | United Kingdom | British | 212146700001 | |||||||||
| MCAULEY, Ann | Sekretär | 14 Oakhall Drive Dorridge B93 8UA Solihull West Midlands | British | 3954600002 | ||||||||||
| MILLS, Nigel John | Sekretär | Fairfield Lodge Fencer Hill Park Gosforth NE3 2EA Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | British | 1537420008 | ||||||||||
| MOORE, Martin Stephen | Sekretär | 93 Prospect Lane B91 1HS Solihull West Midlands | British | 3238160001 | ||||||||||
| BARTON, Tracy Jayne | Geschäftsführer | Delamare Road EN8 9SL Cheshunt Tesco House Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 160642760001 | |||||||||
| BLAIR, Steven | Geschäftsführer | Brownhills WS8 7HU Walsall Apex Road West Midlands United Kingdom | United Kingdom | British | 239167430001 | |||||||||
| BYTHEWAY, Neil Trevor | Geschäftsführer | Delamare Road EN8 9SL Cheshunt Tesco House Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 160637140001 | |||||||||
| CLEMENTS, Tracey | Geschäftsführer | Brownhills WS8 7HU Walsall Apex Road West Midlands United Kingdom | United Kingdom | British | 198102550001 | |||||||||
| CLEMENTS, Tracey | Geschäftsführer | Brownhills WS8 7HU Walsall Apex Road West Midlands United Kingdom | United Kingdom | British | 198102550001 | |||||||||
| GILES, Anthony Edward | Geschäftsführer | Home Farm Cottage Pepper Street Inkberrow WR7 4EJ Worcester | British | 3555100002 | ||||||||||
| HYDE, Richard Charles | Geschäftsführer | 41 Staplehurst Road Hall Green B28 9AR Birmingham West Midlands | British | 3555090001 | ||||||||||
| KING, Andrew Paul | Geschäftsführer | Brownhills WS8 7HU Walsall Apex Road West Midlands United Kingdom | England | British | 200246970001 | |||||||||
| LINSELL, Richard Charles | Geschäftsführer | 6 Aubrey Close West Town PO11 0SU Hayling Island Hampshire | England | British | 1595570002 | |||||||||
| LLOYD, Jonathan Mark | Geschäftsführer | Delamare Road EN8 9SL Cheshunt Tesco House Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 160028560001 | |||||||||
| MCAULEY, Ann | Geschäftsführer | 14 Oakhall Drive Dorridge B93 8UA Solihull West Midlands | British | 3954600002 | ||||||||||
| MCQUARRIE, Jonny | Geschäftsführer | Brownhills WS8 7HU Walsall Apex Road West Midlands United Kingdom | United Kingdom | British | 239167420001 | |||||||||
| MILLS, Nigel John | Geschäftsführer | Fairfield Lodge Fencer Hill Park Gosforth NE3 2EA Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | United Kingdom | British | 1537420008 | |||||||||
| MOORE, Andrew William | Geschäftsführer | 24 Ashwell Drive Shirley B90 3LR Solihull West Midlands | British | 78389210001 | ||||||||||
| MOORE, Martin Stephen | Geschäftsführer | Hollington Lodge Whitley Hill B95 5DL Henley In Arden West Midlands | British | 3238160002 | ||||||||||
| MOORE, Robert Philip | Geschäftsführer | The Old Vicarage Lower Quinton CV37 8SH Stratford Upon Avon Warwickshire | United Kingdom | British | 3238150001 | |||||||||
| NEVILLE-ROLFE, Lucy Jeanne, Ms. | Geschäftsführer | Delamare Road EN8 9SL Cheshunt Tesco House Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 148079740001 | |||||||||
| REED, Anthony William | Geschäftsführer | Brownhills WS8 7TS Walsall Apex Road West Midlands United Kingdom | United Kingdom | British | 160544960001 | |||||||||
| STOKOE, Martin Geoffrey | Geschäftsführer | 1 Exelby Close Whitebridge Park NE3 5LG Gosforth Tyne & Wear | United Kingdom | British | 49671990001 | |||||||||
| WILLIAMS, Mark Benjamin | Geschäftsführer | Brownhills WS8 7HU Walsall Apex Road West Midlands United Kingdom | United Kingdom | British | 208244710001 | |||||||||
| TESCO SERVICES LIMITED | Geschäftsführer | Shire Park Kestrel Way AL7 1GA Welwyn Garden City Tesco House United Kingdom |
| 175259630001 | ||||||||||
| TESCO SERVICES LIMITED | Geschäftsführer | Shire Park Kestrel Way AL7 1GA Welwyn Garden City Tesco House United Kingdom |
| 175259630001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei MORGAM NEWS LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| One Stop Stores Limited | 20. Dez. 2017 | Brownhills WS8 7HU Walsall Apex Road West Midlands United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Morgam Holdings Limited | 06. Apr. 2016 | Brownhills WS8 7TS Walsall Apex Road West Midlands United Kingdom | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat MORGAM NEWS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Supplemental debenture | Erstellt am 13. Nov. 2009 Geliefert am 18. Nov. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All the company’s goodwill and uncalled capital for the time being. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 30. Jan. 2008 Geliefert am 07. Feb. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Chattels mortgage | Erstellt am 19. Aug. 2004 Geliefert am 20. Aug. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Description: 2 x scanners, serial no:hhts-2/hhts-3; epos system complete, EPO500; fascia sign complete, SIG500. For details of further chattels charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 16. Sept. 2003 Geliefert am 26. Sept. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 110, 112 & 114 blenheaim road moseley west midlandst/no: WM30554. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 16. Sept. 2003 Geliefert am 26. Sept. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H property k/a 20 beeches walk sutton coldfield west midlands t/no: WM724539. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 16. Sept. 2003 Geliefert am 19. Sept. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 16. Sept. 2003 Geliefert am 19. Sept. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 36 kenpas highway green lane coventry CV3 6BP. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 08. Jan. 2001 Geliefert am 13. Jan. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 36 richmond road olton B92 7RP 3 station road marston green B37 7AB 169 warwick road olton B92 7AR for further details of property charged please see form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 11. Feb. 1988 Geliefert am 18. Feb. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 2 shaftmoor lane acocks green birmingham west midlands t/n wm 116290 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 11. Feb. 1988 Geliefert am 18. Feb. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 38 kenpas highway coventry t/n wk 98544 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 11. Feb. 1988 Geliefert am 18. Feb. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 46 queen st, cubbington, leamington spa, warwick, warwicks t/no. Wk 270684 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 11. Feb. 1988 Geliefert am 18. Feb. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 5 hockley hill hockley city of birmingham t/n wk 64287 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 13. Jan. 1986 Geliefert am 24. Jan. 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H property k/a 272/274 cranmore boulevard, shirley, solihull, west midlands.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 17. Okt. 1984 Geliefert am 26. Okt. 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H 285 kitts green road, kitts green birmingham west midlands. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge | Erstellt am 07. Dez. 1983 Geliefert am 12. Dez. 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to a mortgage debenture dated 4 july 1972. | |
Kurze Angaben A specific charge over the benefit of all book debts and other debts now and from time to time due or owing to the company. (For full details see doc no m 38). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 20. Juni 1983 Geliefert am 24. Juni 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H property k/a 53 yew tree lane solihull west midlands. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 17. Juni 1983 Geliefert am 23. Juni 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H property k/a 53 yew tree lane, solihull, county of west midlands the goodwill of the business from time to time carried on in the said property.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 06. Mai 1983 Geliefert am 14. Mai 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Legal mortgage:- f/h 38 kenpas highway coventry t/n: wk 98544 floating charge movable plant machinery fixtures implements and utensils and goodwill. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 26. Apr. 1982 Geliefert am 29. Apr. 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H 46 queens street cubbington, warks. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 14. Apr. 1982 Geliefert am 24. Apr. 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 5 hockley hill, hockley, birmingham. T.n: WK64287. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 08. Apr. 1982 Geliefert am 22. Apr. 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed & floating charge on undertaking and all property and assets present and future including goodwill & book debts uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 03. Nov. 1980 Geliefert am 15. Nov. 1980 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H land and premises known as 11 newtown road bedworth in the county of warwickshire. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 03. Nov. 1980 Geliefert am 15. Nov. 1980 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H 276 vicarage road kings heath, birmingham. West midlands. Title no wm 24877. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 30. Apr. 1980 Geliefert am 09. Mai 1980 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Flat 6 broadline court, broadlands estates east-the-water bideford devon & garage. Together with all buildings and erections thereon and all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 17. Dez. 1976 Geliefert am 23. Dez. 1976 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 6 lea green lane, wythall, worcester.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat MORGAM NEWS LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0