TREND NETWORK SERVICES
Überblick
Unternehmensname | TREND NETWORK SERVICES |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung ohne Aktienkapital |
Unternehmensnummer | 01049704 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von TREND NETWORK SERVICES?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich TREND NETWORK SERVICES?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Lindred House 20 Lindred Road Brierfield BB9 5SR Nelson |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von TREND NETWORK SERVICES?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
TREND COMMUNICATIONS LIMITED | 12. Apr. 1972 | 12. Apr. 1972 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von TREND NETWORK SERVICES?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2020 |
Welche sind die letzten Einreichungen für TREND NETWORK SERVICES?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 16. Okt. 2022 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt. | 1 Seiten | SOAS(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Kapitalaufstellung am 29. Dez. 2021
| 5 Seiten | SH19 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 16. Okt. 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2020 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 16. Okt. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2019 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 16. Okt. 2019 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Stephen Alan Smith am 16. Okt. 2019 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Notification of Daisy Telecoms Limited as a person with significant control on 28. März 2019 | 2 Seiten | PSC02 | ||||||||||
Cessation of Daisy It Services Limited as a person with significant control on 28. März 2019 | 1 Seiten | PSC07 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Daisy House Lindred Road Business Park Nelson Lancashire BB9 5SR zum Lindred House 20 Lindred Road Brierfield Nelson BB9 5SR am 29. Apr. 2019 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Nathan Richard Marke als Geschäftsführer am 01. Feb. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Lewis Mcglennon als Sekretär am 01. Feb. 2019 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. März 2018 | 10 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 16. Okt. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Ernennung von Mr David Lewis Mcglennon als Direktor am 22. Juni 2018 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von TREND NETWORK SERVICES?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCGLENNON, David Lewis | Geschäftsführer | 20 Lindred Road Brierfield BB9 5SR Nelson Lindred House | United Kingdom | British | Company Director | 181536600001 | ||||
SMITH, Stephen Alan | Geschäftsführer | 20 Lindred Road Brierfield BB9 5SR Nelson Lindred House | United Kingdom | British | Company Director | 161471940001 | ||||
MARTIN, William Thomas | Sekretär | Weavers Wainhill OX39 4AB Chinnor Oxfordshire | British | 57302660001 | ||||||
MCGLENNON, David Lewis | Sekretär | Lindred Road Business Park Nelson BB9 5SR Lancashire Daisy House England England | 199438590001 | |||||||
MORTON, Julia Alison | Sekretär | 35 Cranesbill Drive OX26 3WQ Bicester Oxfordshire | British | 71324860003 | ||||||
SEFTON, Michael Edward | Sekretär | Oak Cottage Cuckoos Knob Wootton Rivers SN8 4NR Marlborough Wiltshire | British | 51018120001 | ||||||
SHARP, Lorraine | Sekretär | 168 Ember Lane KT10 8EJ Esher Surrey | British | Company Secretary | 26356800001 | |||||
SIMPSON, David Alan | Sekretär | Draycott Cottage Draycott Lane WR5 3NY Kempsey Worcestershire | British | Director | 80817560001 | |||||
SMITH, Stephen James | Sekretär | 16 Chiltern Ridge HP14 3SZ High Wycombe Buckinghamshire | British | Company Secretary | 10039470001 | |||||
STOKES, Reeta | Sekretär | Technology House Hunsbury Hill Avenue NN4 8QS Northampton Northamptonshire | 173996330001 | |||||||
TOULMIN-VAN SITTERT, Dirk Johannes | Sekretär | The Lakes Bedford Road NN4 7HD Northampton Lakeside House Northamptonshire England | 179706050001 | |||||||
AIKMAN, Elizabeth Jane | Geschäftsführer | Lindred Road Business Park Nelson BB9 5SR Lancashire Daisy House England England | England | British | Director | 294355310001 | ||||
BERTRAM, Peter Michael | Geschäftsführer | Torrells Pursers Lane Peaslake GU5 9RE Guildford Surrey | England | British | Director | 52852920002 | ||||
CLUTTON, Steven | Geschäftsführer | Technology House Hunsbury Hill Avenue NN4 8QS Northampton Northamptonshire | England | British | Director | 158222570001 | ||||
COURTLEY, David John | Geschäftsführer | Technology House Hunsbury Hill Avenue NN4 8QS Northampton Northamptonshire | England | British | Director | 141213480001 | ||||
CUNNINGHAM, Hugh Patrick, Sir | Geschäftsführer | Brickyard Farm East Knoyle SP3 6BP Salisbury Wiltshire | British | Company Director | 3707560001 | |||||
CURTIS, Timothy Malise | Geschäftsführer | Street Farmhouse Vernham Street SP11 0EL Andover Hampshire | British | Director | 10381640015 | |||||
DAVEY, Brian George | Geschäftsführer | The Hollies Handford Lane Yateley GU17 7BP Camberley Surrey | British | Director | 30963350001 | |||||
FISHER, Arthur | Geschäftsführer | The Old Sun Brook Stones OX39 4LY Sydenham Oxford | British | Director | 93317860001 | |||||
ILLA, Jordi | Geschäftsführer | Ramon Turro 93 3rd-2nd Barcelona 08005 Spain | Spanish | Director | 76766450001 | |||||
LALE, Jean-Pierre | Geschäftsführer | High Street HP23 5AH Tring 24c Herts United Kingdom | French | Director | 135442370001 | |||||
LANGLANDS, Alan Dickson | Geschäftsführer | 17 The Glebe Weston Turville HP22 5ST Aylesbury Buckinghamshire | British | Director | 36270170002 | |||||
MARKE, Nathan Richard | Geschäftsführer | Lindred Road Business Park Nelson BB9 5SR Lancashire Daisy House England England | United Kingdom | British | Company Director | 194292450001 | ||||
MARTIN, William Thomas | Geschäftsführer | Technology House Hunsbury Hill Avenue NN4 8QS Northampton Northamptonshire | United Kingdom | British | Director | 57302660001 | ||||
MULLER, Neil Keith | Geschäftsführer | Lindred Road Business Park Nelson BB9 5SR Lancashire Daisy House England England | England | British | Company Director | 252490400001 | ||||
NICHOLSON, Peter Frank | Geschäftsführer | 18 Wainwrights HP18 9DT Long Crendon Buckinghamshire | England | British | Director | 242772210001 | ||||
PATERSON, Ian | Geschäftsführer | 20 Rosslyn Hill Hampstead NW3 5UJ London | British | Sales Director | 46186950001 | |||||
RATTRAY, Bruce Davidson | Geschäftsführer | The Little House 34 Parkway GU15 2PE Camberley Surrey | United Kingdom | British | Accountant | 3071690001 | ||||
RILEY, Matthew Robinson | Geschäftsführer | Lindred Road Business Park Nelson BB9 5SR Lancashire Daisy House England England | United Kingdom | British | Company Director | 178585250001 | ||||
ROBINSON, Nicholas John | Geschäftsführer | Ferry Nab Lane SL7 2EZ Medmanham Ferry Nab England United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 54873290006 | ||||
ROBINSON, Nicholas | Geschäftsführer | 1 Wethered Road SL7 2BH Marlow Buckinghamshire | British | Director | 54873290005 | |||||
RUSSELL, Julian Philip | Geschäftsführer | 2 Shepherds Close OX25 3RF Weston On The Green Shepherds Barn Oxfordshire | United Kingdom | British | Marketing Director | 117227890002 | ||||
SANDER, Bernhard | Geschäftsführer | Avenstr. 10 Pfaffenhofen D- 852 76 Germany | German | Director | 39558960002 | |||||
SIMPSON, David Alan | Geschäftsführer | Draycott Cottage Draycott Lane WR5 3NY Kempsey Worcestershire | England | British | Director | 80817560001 | ||||
SMITH, Stephen James | Geschäftsführer | 16 Chiltern Ridge HP14 3SZ High Wycombe Buckinghamshire | British | Accountant | 10039470001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei TREND NETWORK SERVICES?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daisy Telecoms Limited | 28. März 2019 | 20 Lindred Road Brierfield BB9 5SR Nelson Lindred House England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Daisy It Services Limited | 06. Apr. 2016 | Lindred Road Business Park BB9 5SR Nelson Daisy House Lancashire England | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat TREND NETWORK SERVICES Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Composite debenture | Erstellt am 26. März 2004 Geliefert am 06. Apr. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any obligor (or any of them) to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever, under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Collateral debenture | Erstellt am 30. Sept. 1986 Geliefert am 03. Okt. 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys due or to become due from surdidit limited to the chargee pursuant to a facility letter d/d 13/8/86. | |
Kurze Angaben (Please see form 395 for details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage debenture | Erstellt am 30. Sept. 1986 Geliefert am 07. Okt. 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over the company's estate or interest in all f/h or l/h properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charge over undertaking and all property and assets present and future including goodwill & bookdebts. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0