ROWYELL ROASTERS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameROWYELL ROASTERS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01050154
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von ROWYELL ROASTERS LIMITED?

    • (1513) /

    Wo befindet sich ROWYELL ROASTERS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Malton Bacon Factory
    Hugden Way Norton Grove
    YO17 9HG Industrial Estate
    Malton North Yorkshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ROWYELL ROASTERS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2009

    Welche sind die letzten Einreichungen für ROWYELL ROASTERS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Aug. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital05. Sept. 2011

    Kapitalaufstellung am 05. Sept. 2011

    • Kapital: GBP 100,002
    SH01

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Ernennung von Mark Steven als Direktor

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Tmf Corporate Administration Services Limited als Sekretär

    2 SeitenAP04

    Beendigung der Bestellung von Mawlaw Secretaries Limited als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Die Adresse der Registerinspektion wurde vom 201 Bishopsgate London EC2M 3AF geändert

    1 SeitenAD02

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2009

    12 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Aug. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01

    Beendigung der Bestellung von Antonius Lammers als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Louis Antoine Maria Vernaus als Direktor

    2 SeitenAP01

    Änderung der Details des Direktors für Stephen Ronald William Francis am 01. Okt. 2009

    3 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Antonius Matheus Maria Lammers am 01. Okt. 2009

    3 SeitenCH01

    Die Adresse der Registerinspektion wurde geändert

    2 SeitenAD02

    legacy

    4 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten225

    Jahresabschluss erstellt bis zum 22. Nov. 2008

    15 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten353

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288c

    legacy

    1 Seiten288c

    legacy

    1 Seiten288c

    legacy

    1 Seiten288c

    legacy

    1 Seiten288c

    Wer sind die Geschäftsführer von ROWYELL ROASTERS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    TMF CORPORATE ADMINISTRATION SERVICES LIMITED
    1st Floor
    9 Cloak Lane
    EC4R 2RU London
    Pellipar House
    United Kingdom
    Sekretär
    1st Floor
    9 Cloak Lane
    EC4R 2RU London
    Pellipar House
    United Kingdom
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer06902863
    140723560001
    CHRISTIAANSE, Anthony Martin
    3065 Sc Rotterdam
    's-Gravenweg 551
    The Netherlands
    Geschäftsführer
    3065 Sc Rotterdam
    's-Gravenweg 551
    The Netherlands
    Dutch129239540002
    FRANCIS, Stephen Ronald William
    Bain Square
    Kirkton Campus
    EH54 7DQ Livingston
    7
    Geschäftsführer
    Bain Square
    Kirkton Campus
    EH54 7DQ Livingston
    7
    EnglandBritish105961550001
    STEVEN, Mark Alexander
    Bain Square
    Kirkton Campus
    EH54 7DQ Livingston
    7
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Bain Square
    Kirkton Campus
    EH54 7DQ Livingston
    7
    United Kingdom
    ScotlandBritish159788300001
    VERNAUS, Louis Antoine Maria
    Bain Square
    Kirkton Campus
    EH54 7DQ Livingston
    7
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Bain Square
    Kirkton Campus
    EH54 7DQ Livingston
    7
    United Kingdom
    NetherlandsDutch146206430001
    ROXBURGH, Roy
    515 North Deeside Road
    Cults
    AB15 9ES Aberdeen
    Aberdeenshire
    Sekretär
    515 North Deeside Road
    Cults
    AB15 9ES Aberdeen
    Aberdeenshire
    British194640001
    TROLLOPE, Barry Desmond
    Orchard House Furlong Road
    Stoke Ferry
    PE33 9SU Kings Lynn
    Norfolk
    Sekretär
    Orchard House Furlong Road
    Stoke Ferry
    PE33 9SU Kings Lynn
    Norfolk
    British45609870001
    TYM, Robert William, Mister
    Round House East Gores Road
    Coggeshall
    CO6 1RZ Colchester
    Essex
    Sekretär
    Round House East Gores Road
    Coggeshall
    CO6 1RZ Colchester
    Essex
    British15836130001
    IAIN SMITH AND COMPANY
    18-20 Queen's Road
    AB15 4ZT Aberdeen
    Grampian
    Sekretär
    18-20 Queen's Road
    AB15 4ZT Aberdeen
    Grampian
    93547510001
    MACLAY MURRAY & SPENS LLP
    66 Queen's Road
    AB15 4YE Aberdeen
    Sekretär
    66 Queen's Road
    AB15 4YE Aberdeen
    119967690001
    MAWLAW SECRETARIES LIMITED
    Bishopsgate
    EC2M 3AF London
    201
    Sekretär
    Bishopsgate
    EC2M 3AF London
    201
    39182980003
    COLES, Philip Charles John
    55 West End Crosshill Cottage
    Northwold
    IP26 5LE Thetford
    Norfolk
    Geschäftsführer
    55 West End Crosshill Cottage
    Northwold
    IP26 5LE Thetford
    Norfolk
    British47148220001
    DUNCAN, Alfred John
    Saetra House
    Inchmarlo Road
    AB31 3RR Banchory
    Aberdeenshire
    Geschäftsführer
    Saetra House
    Inchmarlo Road
    AB31 3RR Banchory
    Aberdeenshire
    United KingdomBritish402690001
    FOX, Garrick Thomas
    Kiln Cottage
    Syleham
    IP21 4LT Eye
    Suffolk
    Geschäftsführer
    Kiln Cottage
    Syleham
    IP21 4LT Eye
    Suffolk
    EnglandBritish15836150001
    IMRAY, Iain Murray
    41 Hammersmith Road
    AB10 6NA Aberdeen
    Aberdeenshire
    Geschäftsführer
    41 Hammersmith Road
    AB10 6NA Aberdeen
    Aberdeenshire
    United KingdomBritish63444910001
    LAMMERS, Antonius Matheus Maria
    7005-7023
    5692 Hb Son En Breugel
    Ekkersrijt
    The Netherlands
    Geschäftsführer
    7005-7023
    5692 Hb Son En Breugel
    Ekkersrijt
    The Netherlands
    Dutch126350570004
    PARIS, Walter Walker
    21 Hillview Road
    AB31 4EG Banchory
    Kincardineshire
    Scotland
    Geschäftsführer
    21 Hillview Road
    AB31 4EG Banchory
    Kincardineshire
    Scotland
    British338220001
    PARKER, Michael Joseph Bennett
    The Hall
    Stoke Ferry
    PE33 9SE Kings Lynn
    Norfolk
    Geschäftsführer
    The Hall
    Stoke Ferry
    PE33 9SE Kings Lynn
    Norfolk
    British12897020001
    ROCHE, Nicholas James
    Grove Cottage Mellis Road
    Yaxley
    IP23 8DB Eye
    Suffolk
    Geschäftsführer
    Grove Cottage Mellis Road
    Yaxley
    IP23 8DB Eye
    Suffolk
    EnglandBritish15836170001
    SALKELD, David John
    The Old Hall Back Lane
    Bramham
    LS23 6QR Wetherby
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    The Old Hall Back Lane
    Bramham
    LS23 6QR Wetherby
    West Yorkshire
    EnglandBritish111995510001
    STEPHEN, Andrew Michael Duthie
    Speymuir 3 Victoria Street
    AB53 4RE Turriff
    Aberdeenshire
    Scotland
    Geschäftsführer
    Speymuir 3 Victoria Street
    AB53 4RE Turriff
    Aberdeenshire
    Scotland
    ScotlandBritish338210001
    TROLLOPE, Barry Desmond
    Orchard House Furlong Road
    Stoke Ferry
    PE33 9SU Kings Lynn
    Norfolk
    Geschäftsführer
    Orchard House Furlong Road
    Stoke Ferry
    PE33 9SU Kings Lynn
    Norfolk
    British45609870001

    Hat ROWYELL ROASTERS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    An intercreditor and security agreement
    Erstellt am 30. Mai 2007
    Geliefert am 13. Juni 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any obligor to any restructuring creditor and to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All of its right to and title and interest (if any) from time to time to the deposits. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee
    Transaktionen
    • 13. Juni 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Sept. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 29. Mai 2007
    Geliefert am 08. Juni 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 08. Juni 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Sept. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 07. Dez. 1998
    Geliefert am 23. Dez. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee in terms of the guarantee including in particular all monies due by the trustees (as defined) under or in connection with any of the finance documents (as defined)
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 23. Dez. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Jan. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 28. Juli 1998
    Geliefert am 14. Aug. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the finance parties (as defined) on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland,as Trustee for the Finance Parties
    Transaktionen
    • 14. Aug. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Sept. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 23. Aug. 1996
    Geliefert am 09. Sept. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All sums of money or liabilities which now are or which may at any time or from time to time be or become due to the chargee and the banks (as therein defined) (or any of them) by the company or for which the company is or may be at any time or from time to time be or become liable or responsible to the chargee and the banks (or any of them) in any manner or way or in any respect whatsoever or in connection with or arising out of any financing document, or out of any other current or other account, order, cheque, note, draft, bill, promissory note, letter of credit or guarantee (whether granted by the chargee or a bank on the company's behalf or by the company to the chargee or a bank) or any one or more of any such or otherwise whatsoever.
    Kurze Angaben
    The f/h farm k/a braughing, ideal farms,. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and the Company of the Bank of Scotlandehalf of the Banksfor Itself and as Agent and Trustee for and on B
    Transaktionen
    • 09. Sept. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Jan. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 31. Juli 1987
    Geliefert am 18. Aug. 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or sovereign chicken limited to the chargee on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 18. Aug. 1987Registrierung einer Belastung
    • 29. Aug. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 02. Feb. 1987
    Geliefert am 12. Feb. 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or sovereign chicken limited to the chargee on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. Feb. 1987Registrierung einer Belastung
    • 29. Aug. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of guarantee & charge
    Erstellt am 27. Mai 1983
    Geliefert am 10. Juni 1983
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from favour parker limited to the chargee under the terms of an agreement dated 1/5/83
    Kurze Angaben
    & property named on doc M20. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Fitch Lovell Public Limited Company.
    Transaktionen
    • 10. Juni 1983Registrierung einer Belastung
    Further guarantee & debenture
    Erstellt am 09. Sept. 1982
    Geliefert am 16. Sept. 1982
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. Sept. 1982Registrierung einer Belastung
    Legal mortgage
    Erstellt am 05. Aug. 1981
    Geliefert am 21. Aug. 1981
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H the bungalow. Ideal farm braughing title no hd 26051 f/h land lying to the north of road from braughing to albury title no hd 83140 & all fixtures. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Banque Occidentale Pour L'industrie Et Le Commerce
    Transaktionen
    • 21. Aug. 1981Registrierung einer Belastung
    • 13. Feb. 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 05. Aug. 1981
    Geliefert am 21. Aug. 1981
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Enclosures numbered 254E,254F & 256 on the ordnance survey map of the parish of braughing herts with all fixtures. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Banque Occidentale Pour L'industrie Et Le Commerce
    Transaktionen
    • 21. Aug. 1981Registrierung einer Belastung
    • 13. Feb. 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0