ROWYELL ROASTERS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | ROWYELL ROASTERS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01050154 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von ROWYELL ROASTERS LIMITED?
- (1513) /
Wo befindet sich ROWYELL ROASTERS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Malton Bacon Factory Hugden Way Norton Grove YO17 9HG Industrial Estate Malton North Yorkshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ROWYELL ROASTERS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2009 |
Welche sind die letzten Einreichungen für ROWYELL ROASTERS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Aug. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Ernennung von Mark Steven als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Tmf Corporate Administration Services Limited als Sekretär | 2 Seiten | AP04 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Mawlaw Secretaries Limited als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde vom 201 Bishopsgate London EC2M 3AF geändert | 1 Seiten | AD02 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Aug. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Antonius Lammers als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Louis Antoine Maria Vernaus als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Stephen Ronald William Francis am 01. Okt. 2009 | 3 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Antonius Matheus Maria Lammers am 01. Okt. 2009 | 3 Seiten | CH01 | ||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde geändert | 2 Seiten | AD02 | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 225 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 22. Nov. 2008 | 15 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 353 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von ROWYELL ROASTERS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMF CORPORATE ADMINISTRATION SERVICES LIMITED | Sekretär | 1st Floor 9 Cloak Lane EC4R 2RU London Pellipar House United Kingdom |
| 140723560001 | ||||||||||
| CHRISTIAANSE, Anthony Martin | Geschäftsführer | 3065 Sc Rotterdam 's-Gravenweg 551 The Netherlands | Dutch | 129239540002 | ||||||||||
| FRANCIS, Stephen Ronald William | Geschäftsführer | Bain Square Kirkton Campus EH54 7DQ Livingston 7 | England | British | 105961550001 | |||||||||
| STEVEN, Mark Alexander | Geschäftsführer | Bain Square Kirkton Campus EH54 7DQ Livingston 7 United Kingdom | Scotland | British | 159788300001 | |||||||||
| VERNAUS, Louis Antoine Maria | Geschäftsführer | Bain Square Kirkton Campus EH54 7DQ Livingston 7 United Kingdom | Netherlands | Dutch | 146206430001 | |||||||||
| ROXBURGH, Roy | Sekretär | 515 North Deeside Road Cults AB15 9ES Aberdeen Aberdeenshire | British | 194640001 | ||||||||||
| TROLLOPE, Barry Desmond | Sekretär | Orchard House Furlong Road Stoke Ferry PE33 9SU Kings Lynn Norfolk | British | 45609870001 | ||||||||||
| TYM, Robert William, Mister | Sekretär | Round House East Gores Road Coggeshall CO6 1RZ Colchester Essex | British | 15836130001 | ||||||||||
| IAIN SMITH AND COMPANY | Sekretär | 18-20 Queen's Road AB15 4ZT Aberdeen Grampian | 93547510001 | |||||||||||
| MACLAY MURRAY & SPENS LLP | Sekretär | 66 Queen's Road AB15 4YE Aberdeen | 119967690001 | |||||||||||
| MAWLAW SECRETARIES LIMITED | Sekretär | Bishopsgate EC2M 3AF London 201 | 39182980003 | |||||||||||
| COLES, Philip Charles John | Geschäftsführer | 55 West End Crosshill Cottage Northwold IP26 5LE Thetford Norfolk | British | 47148220001 | ||||||||||
| DUNCAN, Alfred John | Geschäftsführer | Saetra House Inchmarlo Road AB31 3RR Banchory Aberdeenshire | United Kingdom | British | 402690001 | |||||||||
| FOX, Garrick Thomas | Geschäftsführer | Kiln Cottage Syleham IP21 4LT Eye Suffolk | England | British | 15836150001 | |||||||||
| IMRAY, Iain Murray | Geschäftsführer | 41 Hammersmith Road AB10 6NA Aberdeen Aberdeenshire | United Kingdom | British | 63444910001 | |||||||||
| LAMMERS, Antonius Matheus Maria | Geschäftsführer | 7005-7023 5692 Hb Son En Breugel Ekkersrijt The Netherlands | Dutch | 126350570004 | ||||||||||
| PARIS, Walter Walker | Geschäftsführer | 21 Hillview Road AB31 4EG Banchory Kincardineshire Scotland | British | 338220001 | ||||||||||
| PARKER, Michael Joseph Bennett | Geschäftsführer | The Hall Stoke Ferry PE33 9SE Kings Lynn Norfolk | British | 12897020001 | ||||||||||
| ROCHE, Nicholas James | Geschäftsführer | Grove Cottage Mellis Road Yaxley IP23 8DB Eye Suffolk | England | British | 15836170001 | |||||||||
| SALKELD, David John | Geschäftsführer | The Old Hall Back Lane Bramham LS23 6QR Wetherby West Yorkshire | England | British | 111995510001 | |||||||||
| STEPHEN, Andrew Michael Duthie | Geschäftsführer | Speymuir 3 Victoria Street AB53 4RE Turriff Aberdeenshire Scotland | Scotland | British | 338210001 | |||||||||
| TROLLOPE, Barry Desmond | Geschäftsführer | Orchard House Furlong Road Stoke Ferry PE33 9SU Kings Lynn Norfolk | British | 45609870001 |
Hat ROWYELL ROASTERS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| An intercreditor and security agreement | Erstellt am 30. Mai 2007 Geliefert am 13. Juni 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any obligor to any restructuring creditor and to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All of its right to and title and interest (if any) from time to time to the deposits. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 29. Mai 2007 Geliefert am 08. Juni 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 07. Dez. 1998 Geliefert am 23. Dez. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee in terms of the guarantee including in particular all monies due by the trustees (as defined) under or in connection with any of the finance documents (as defined) | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 28. Juli 1998 Geliefert am 14. Aug. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the finance parties (as defined) on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 23. Aug. 1996 Geliefert am 09. Sept. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All sums of money or liabilities which now are or which may at any time or from time to time be or become due to the chargee and the banks (as therein defined) (or any of them) by the company or for which the company is or may be at any time or from time to time be or become liable or responsible to the chargee and the banks (or any of them) in any manner or way or in any respect whatsoever or in connection with or arising out of any financing document, or out of any other current or other account, order, cheque, note, draft, bill, promissory note, letter of credit or guarantee (whether granted by the chargee or a bank on the company's behalf or by the company to the chargee or a bank) or any one or more of any such or otherwise whatsoever. | |
Kurze Angaben The f/h farm k/a braughing, ideal farms,. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 31. Juli 1987 Geliefert am 18. Aug. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or sovereign chicken limited to the chargee on any account whatsoever. | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 02. Feb. 1987 Geliefert am 12. Feb. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or sovereign chicken limited to the chargee on any account whatsoever. | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of guarantee & charge | Erstellt am 27. Mai 1983 Geliefert am 10. Juni 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from favour parker limited to the chargee under the terms of an agreement dated 1/5/83 | |
Kurze Angaben & property named on doc M20. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Further guarantee & debenture | Erstellt am 09. Sept. 1982 Geliefert am 16. Sept. 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 05. Aug. 1981 Geliefert am 21. Aug. 1981 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H the bungalow. Ideal farm braughing title no hd 26051 f/h land lying to the north of road from braughing to albury title no hd 83140 & all fixtures. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 05. Aug. 1981 Geliefert am 21. Aug. 1981 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Enclosures numbered 254E,254F & 256 on the ordnance survey map of the parish of braughing herts with all fixtures. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0