HSBC PH INVESTMENTS (UK) LIMITED

HSBC PH INVESTMENTS (UK) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameHSBC PH INVESTMENTS (UK) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01051510
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von HSBC PH INVESTMENTS (UK) LIMITED?

    • Finanzleasing (64910) / Finanz- und Versicherungsdienstleistungen

    Wo befindet sich HSBC PH INVESTMENTS (UK) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    8 Canada Square
    London
    E14 5HQ
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von HSBC PH INVESTMENTS (UK) LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    ASSETFINANCE DECEMBER (G) LIMITED27. Sept. 199927. Sept. 1999
    FF LIMITED27. Mai 199427. Mai 1994
    FIAT FINANCE LIMITED25. Apr. 197225. Apr. 1972

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von HSBC PH INVESTMENTS (UK) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2014

    Welche sind die letzten Einreichungen für HSBC PH INVESTMENTS (UK) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Kapitalaufstellung am 12. Okt. 2016

    • Kapital: GBP 2
    3 SeitenSH19

    legacy

    1 SeitenSH20

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Beendigung der Bestellung von Robin Louis Henning Bencard als Geschäftsführer am 01. Aug. 2016

    1 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 01. Mai 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    9 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital05. Mai 2016

    Kapitalaufstellung am 05. Mai 2016

    • Kapital: GBP 1,000,000
    SH01

    Ernennung von Mr Simon Einar Long als Direktor am 15. März 2016

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von David John Cavanna als Geschäftsführer am 31. Dez. 2015

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Michael Connelly Anderson als Direktor am 16. Dez. 2015

    2 SeitenAP01

    Erfüllung der Belastung 9 vollständig

    4 SeitenMR04

    Verschiedenes

    Section 519.
    1 SeitenMISC

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2014

    19 SeitenAA

    Rücktritt des Auditors

    1 SeitenAUD

    Ernennung von Ms Romana Lewis als Sekretär am 06. Juli 2015

    2 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Hannah Elizabeth Shepherd als Sekretär am 06. Juli 2015

    1 SeitenTM02

    Jahresrückblick erstellt bis 01. Mai 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    8 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital11. Mai 2015

    Kapitalaufstellung am 11. Mai 2015

    • Kapital: GBP 1,000,000
    SH01

    Ernennung von Hannah Elizabeth Shepherd als Sekretär am 05. Jan. 2015

    2 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Tony Bhambhra als Sekretär am 05. Jan. 2015

    1 SeitenTM02

    Beendigung der Bestellung von Naresh Manjanath als Geschäftsführer am 11. Sept. 2014

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2013

    19 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 01. Mai 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    9 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital08. Mai 2014

    Kapitalaufstellung am 08. Mai 2014

    • Kapital: GBP 1,000,000
    SH01

    Ernennung von Tony Bhambhra als Sekretär

    2 SeitenAP03

    Wer sind die Geschäftsführer von HSBC PH INVESTMENTS (UK) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    LEWIS, Romana
    Canada Square
    14th Floor Canary Wharf
    E145HQ London, Greater London
    8
    England
    England
    Sekretär
    Canada Square
    14th Floor Canary Wharf
    E145HQ London, Greater London
    8
    England
    England
    199208910001
    ANDERSON, Michael Connelly
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    EnglandBritish269666390001
    KENT, John Richard
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    United KingdomBritish174308200001
    LONG, Simon Einar
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    United KingdomBritish206202590001
    OWEN CONWAY, Gareth
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    United KingdomBritish82999960002
    SUBRAMANIYAN, Jaya
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    United KingdomMalaysian136924480002
    BAYER, George William
    Flat 1
    Old Bank House, 110 Bermondsey Street
    SE1 3TX London
    Sekretär
    Flat 1
    Old Bank House, 110 Bermondsey Street
    SE1 3TX London
    Other123920600002
    BHAMBHRA, Tony
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Sekretär
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    186837800001
    DEAN, Katherine
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Sekretär
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    180091350001
    GOTT, Sarah Caroline
    Whitworth Street
    SE10 9EN London
    13
    United Kingdom
    Sekretär
    Whitworth Street
    SE10 9EN London
    13
    United Kingdom
    British136485400005
    MCKENZIE, John Hume
    37 Lime Trees
    Staplehurst
    TN12 0SS Tonbridge
    Kent
    Sekretär
    37 Lime Trees
    Staplehurst
    TN12 0SS Tonbridge
    Kent
    British67406010001
    MCQUILLAN, Pauline Louise
    8 Canada Square
    E14 5HQ London
    Sekretär
    8 Canada Square
    E14 5HQ London
    British109247130002
    MUSGROVE, Robert Hugh
    6 Barn Meadow
    Staplehurst
    TN12 0SY Tonbridge
    Kent
    Sekretär
    6 Barn Meadow
    Staplehurst
    TN12 0SY Tonbridge
    Kent
    Other76913670001
    NIVEN, Frances Julie
    73 Celestial Gardens
    SE13 5RU London
    Sekretär
    73 Celestial Gardens
    SE13 5RU London
    British78670270001
    PEARCE, Mark Vivian
    55 Huntly Road
    Talbot Woods
    BH3 7HG Bournemouth
    Dorset
    Sekretär
    55 Huntly Road
    Talbot Woods
    BH3 7HG Bournemouth
    Dorset
    British26776940002
    READ, Alice
    188 Berglen Court
    7 Branch Road
    E14 7JZ London
    Sekretär
    188 Berglen Court
    7 Branch Road
    E14 7JZ London
    British106168980003
    SHEPHERD, Hannah Elizabeth
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Sekretär
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    194218040001
    SHEPHERD, Hannah Elizabeth
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Sekretär
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    154911830001
    WOOD, Hollie Rheanna
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Sekretär
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    165563750001
    ANDREONE, Gianfranco
    Corso Siracusa N 79
    FOREIGN Italy
    Geschäftsführer
    Corso Siracusa N 79
    FOREIGN Italy
    Italian32099940001
    ARMSTRONG, John Osborne William
    The Nook 372 Alcester Road
    Burcot
    B60 1PP Bromsgrove
    Worcestershire
    Geschäftsführer
    The Nook 372 Alcester Road
    Burcot
    B60 1PP Bromsgrove
    Worcestershire
    British31196620002
    BARKER, Fiona Ann
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    United KingdomBritish151858510001
    BARKER, Fiona Ann
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    United KingdomBritish151858510001
    BENCARD, Robin Louis Henning
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    United KingdomBritish46782110002
    BODEGA, Charles Anthony
    30 Moreland Drive
    SL9 8BD Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    30 Moreland Drive
    SL9 8BD Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    British33601160001
    BROOKES, Malcolm James
    3 School Close
    Pinvin
    WR10 2TZ Pershore
    Worcestershire
    Geschäftsführer
    3 School Close
    Pinvin
    WR10 2TZ Pershore
    Worcestershire
    British61727900003
    BROOKES, Malcolm James
    15 St Lukes Close
    Four Pools
    WR11 6ET Evesham
    Hereford And Worcester
    Geschäftsführer
    15 St Lukes Close
    Four Pools
    WR11 6ET Evesham
    Hereford And Worcester
    British61727900002
    BROWN, Robin James
    33 Wheatsheaf Road
    Edgbaston
    B16 0RZ Birmingham
    West Midlands
    Geschäftsführer
    33 Wheatsheaf Road
    Edgbaston
    B16 0RZ Birmingham
    West Midlands
    British9800820001
    CARELLO, Massimo, Dr
    20 Pelham Crescent
    SW7 2NR London
    Geschäftsführer
    20 Pelham Crescent
    SW7 2NR London
    Italian35566160001
    CARNEY, Brian
    Springwood Lodge
    Owler Park Road
    LS29 0BG Ilkley
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Springwood Lodge
    Owler Park Road
    LS29 0BG Ilkley
    West Yorkshire
    British100001170001
    CAVANNA, David John
    8 Canada Square
    London
    E14 5HQ
    Geschäftsführer
    8 Canada Square
    London
    E14 5HQ
    United KingdomBritish180384720001
    CENTONZE, Giuseppe
    5 Harrington Close
    SL4 4AD Windsor
    Berkshire
    Geschäftsführer
    5 Harrington Close
    SL4 4AD Windsor
    Berkshire
    Italian27832010001
    DI CAPUA, Vittorio Augusto
    Via Mazzini 51/53
    FOREIGN Torino 10124
    Italy
    Geschäftsführer
    Via Mazzini 51/53
    FOREIGN Torino 10124
    Italy
    Italian27832040001
    DORIA, Bruno
    Via Mazzini 51/53
    Torino
    Italy
    Geschäftsführer
    Via Mazzini 51/53
    Torino
    Italy
    Italian55825630003
    EVANS, Geoffrey William
    The Trumpet House Kington Lane
    Claverdon
    CV35 8PP Warwick
    Geschäftsführer
    The Trumpet House Kington Lane
    Claverdon
    CV35 8PP Warwick
    British42712190001

    Hat HSBC PH INVESTMENTS (UK) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Security agreement
    Erstellt am 21. Dez. 2010
    Geliefert am 05. Jan. 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from company or hsbc bank PLC to the secured parties or to the chargee (whether for its own account or as trustee for the secured parties) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All of its right title and interest in the deposit see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank of America N.A.,in Its Capacity as the Security Trustee
    Transaktionen
    • 05. Jan. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 24. Dez. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Specific legal mortgage no.6 In respect of the containers (as defined therein)
    Erstellt am 31. Jan. 2001
    Geliefert am 09. Feb. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the lease and the dpp (as defined)
    Kurze Angaben
    All the right title and interest in the containers (as defined) received pursuant to the relevant acquisition agreement (as defined) and the proceeds of sale thereof. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • P&O Nedlloyd Limited
    Transaktionen
    • 09. Feb. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Juni 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Specific legal mortgage no.5 In respect of the containers (as defined therein)
    Erstellt am 30. Nov. 2000
    Geliefert am 04. Dez. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the lease and the dpp (as defined)
    Kurze Angaben
    All right title and interest in the containers (as defined) received pursuant to the relevant acquisition agreement (as defined) and the proceeds of sale thereof. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • P&O Nedlloyd Limited
    Transaktionen
    • 04. Dez. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Juni 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Specific legal mortgage no.4 In respect of the containers (as defined therein)
    Erstellt am 31. Okt. 2000
    Geliefert am 02. Nov. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the lease and the dpp (as defined therein)
    Kurze Angaben
    All right title and interest in the containers (as defined) received pursuant to the relevant aqcuisition agreement (as defined) and the proceeds of sale thereof (for further details of the property charged please refer to the form 395). see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • P&O Nedlloyd Limited
    Transaktionen
    • 02. Nov. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Juni 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Specific legal mortgage no.3 In respect of the containers (as defined)
    Erstellt am 31. Aug. 2000
    Geliefert am 08. Sept. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the lease and the dpp (as defined)
    Kurze Angaben
    All right title and interest in the containers (as defined) received pursuant to the relevnt aqcuisition agreement (as defined) and the proceeds of sale thereof (please refer to form 395 for full details). See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • P&O Nedlloyd Limited
    Transaktionen
    • 08. Sept. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Juni 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Specific legal mortgage no.2 In respect of the containers (as defined)
    Erstellt am 30. Juni 2000
    Geliefert am 07. Juli 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the lease and the dpp (as defined)
    Kurze Angaben
    All right,title and interest in the containers (as defined) received pursuant to the relevant acquisition agreement (as defined) and the proceeds of sale thereof. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • P & O Nedlloyd Limited
    Transaktionen
    • 07. Juli 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Juni 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Specific legal mortgage no. 1 between the company and p&o nedlloyd limited in respect of the containers
    Erstellt am 31. Mai 2000
    Geliefert am 16. Juni 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The payment and discharge at any time of the company's express and specific obligations (actual or contingent) of the company under or pursuant to the lease (as defined) and the dpp (as defined)
    Kurze Angaben
    The company as beneficial owner assigns and agrees to assigns all present and future right and title to and interest in the containers such as the company received pursuant to the relevant acquisition agreement and to the proceeds of sale thereof and charges the containers and the proceeds of sale thereof. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • P&O Nedlloyd Limited
    Transaktionen
    • 16. Juni 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Juni 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Deed of mortgage in respect of the containers
    Erstellt am 18. Apr. 2000
    Geliefert am 08. Mai 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The payment and discharge at any time of the company's express and specific obligations (actual or contingent) of the company under or pursuant to the lease and the dpp: (a) to pay to the mortgagee any and all amounts in respect of rebates of rent and termination sums,total loss proceeds or net sales proceeds payable to the mortgagee in accordance with the provisions of clauses 20.6.4 and 24.4.4 of the lease; (b) to discharge any lessor's encumbrances in accordance with clause 6.3 of the lease; and (c) perform its obligations under clause 19.4 of the lease and clauses 14.4,14.5,14.6 and 14.8 of the dpp and paragraphs 2.5 and 2.8 of schedule 3 of the dpp
    Kurze Angaben
    All right,title and interest (if any) present and future of the company in and to each of the containers as the company shall have received pursuant to the acquisition agreement in respect thereof.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • P&O Nedlloyd Limited
    Transaktionen
    • 08. Mai 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Juni 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Lessor proceeds account charge
    Erstellt am 18. Apr. 2000
    Geliefert am 04. Mai 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The express and specific obligations of the company to the chargee under (a) clause 20.6 (application of net total loss proceeds, requisition compensation and other compensation) and (b) clause 24.4 (application of the net sale proceeds) of the lease agreement dated 8TH april 2000 as amended and restated pursuant to a deed of amendment and restatement dated 18TH april 2000, being the obligations to rebate to the chargee by way of rebate of rent or termination amount
    Kurze Angaben
    The company's rights title and interest present and future in and to the charged moneys being all moneys standing to the credit of the interest bearing dollar account of the company designated "lessor proceeds account" and with account no.242891. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • P&O Nedlloyd Limited
    Transaktionen
    • 04. Mai 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Juni 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0