HSBC PH INVESTMENTS (UK) LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | HSBC PH INVESTMENTS (UK) LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01051510 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von HSBC PH INVESTMENTS (UK) LIMITED?
- Finanzleasing (64910) / Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
Wo befindet sich HSBC PH INVESTMENTS (UK) LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 8 Canada Square London E14 5HQ |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von HSBC PH INVESTMENTS (UK) LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| ASSETFINANCE DECEMBER (G) LIMITED | 27. Sept. 1999 | 27. Sept. 1999 |
| FF LIMITED | 27. Mai 1994 | 27. Mai 1994 |
| FIAT FINANCE LIMITED | 25. Apr. 1972 | 25. Apr. 1972 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von HSBC PH INVESTMENTS (UK) LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2014 |
Welche sind die letzten Einreichungen für HSBC PH INVESTMENTS (UK) LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 12. Okt. 2016
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Robin Louis Henning Bencard als Geschäftsführer am 01. Aug. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Mai 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 9 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von Mr Simon Einar Long als Direktor am 15. März 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von David John Cavanna als Geschäftsführer am 31. Dez. 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Michael Connelly Anderson als Direktor am 16. Dez. 2015 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 9 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Verschiedenes Section 519. | 1 Seiten | MISC | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 19 Seiten | AA | ||||||||||
Rücktritt des Auditors | 1 Seiten | AUD | ||||||||||
Ernennung von Ms Romana Lewis als Sekretär am 06. Juli 2015 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Hannah Elizabeth Shepherd als Sekretär am 06. Juli 2015 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Mai 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 8 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von Hannah Elizabeth Shepherd als Sekretär am 05. Jan. 2015 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Tony Bhambhra als Sekretär am 05. Jan. 2015 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Naresh Manjanath als Geschäftsführer am 11. Sept. 2014 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 19 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Mai 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 9 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von Tony Bhambhra als Sekretär | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von HSBC PH INVESTMENTS (UK) LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEWIS, Romana | Sekretär | Canada Square 14th Floor Canary Wharf E145HQ London, Greater London 8 England England | 199208910001 | |||||||
| ANDERSON, Michael Connelly | Geschäftsführer | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | England | British | 269666390001 | |||||
| KENT, John Richard | Geschäftsführer | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | United Kingdom | British | 174308200001 | |||||
| LONG, Simon Einar | Geschäftsführer | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | United Kingdom | British | 206202590001 | |||||
| OWEN CONWAY, Gareth | Geschäftsführer | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | United Kingdom | British | 82999960002 | |||||
| SUBRAMANIYAN, Jaya | Geschäftsführer | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | United Kingdom | Malaysian | 136924480002 | |||||
| BAYER, George William | Sekretär | Flat 1 Old Bank House, 110 Bermondsey Street SE1 3TX London | Other | 123920600002 | ||||||
| BHAMBHRA, Tony | Sekretär | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | 186837800001 | |||||||
| DEAN, Katherine | Sekretär | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | 180091350001 | |||||||
| GOTT, Sarah Caroline | Sekretär | Whitworth Street SE10 9EN London 13 United Kingdom | British | 136485400005 | ||||||
| MCKENZIE, John Hume | Sekretär | 37 Lime Trees Staplehurst TN12 0SS Tonbridge Kent | British | 67406010001 | ||||||
| MCQUILLAN, Pauline Louise | Sekretär | 8 Canada Square E14 5HQ London | British | 109247130002 | ||||||
| MUSGROVE, Robert Hugh | Sekretär | 6 Barn Meadow Staplehurst TN12 0SY Tonbridge Kent | Other | 76913670001 | ||||||
| NIVEN, Frances Julie | Sekretär | 73 Celestial Gardens SE13 5RU London | British | 78670270001 | ||||||
| PEARCE, Mark Vivian | Sekretär | 55 Huntly Road Talbot Woods BH3 7HG Bournemouth Dorset | British | 26776940002 | ||||||
| READ, Alice | Sekretär | 188 Berglen Court 7 Branch Road E14 7JZ London | British | 106168980003 | ||||||
| SHEPHERD, Hannah Elizabeth | Sekretär | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | 194218040001 | |||||||
| SHEPHERD, Hannah Elizabeth | Sekretär | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | 154911830001 | |||||||
| WOOD, Hollie Rheanna | Sekretär | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | 165563750001 | |||||||
| ANDREONE, Gianfranco | Geschäftsführer | Corso Siracusa N 79 FOREIGN Italy | Italian | 32099940001 | ||||||
| ARMSTRONG, John Osborne William | Geschäftsführer | The Nook 372 Alcester Road Burcot B60 1PP Bromsgrove Worcestershire | British | 31196620002 | ||||||
| BARKER, Fiona Ann | Geschäftsführer | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | United Kingdom | British | 151858510001 | |||||
| BARKER, Fiona Ann | Geschäftsführer | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | United Kingdom | British | 151858510001 | |||||
| BENCARD, Robin Louis Henning | Geschäftsführer | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | United Kingdom | British | 46782110002 | |||||
| BODEGA, Charles Anthony | Geschäftsführer | 30 Moreland Drive SL9 8BD Gerrards Cross Buckinghamshire | British | 33601160001 | ||||||
| BROOKES, Malcolm James | Geschäftsführer | 3 School Close Pinvin WR10 2TZ Pershore Worcestershire | British | 61727900003 | ||||||
| BROOKES, Malcolm James | Geschäftsführer | 15 St Lukes Close Four Pools WR11 6ET Evesham Hereford And Worcester | British | 61727900002 | ||||||
| BROWN, Robin James | Geschäftsführer | 33 Wheatsheaf Road Edgbaston B16 0RZ Birmingham West Midlands | British | 9800820001 | ||||||
| CARELLO, Massimo, Dr | Geschäftsführer | 20 Pelham Crescent SW7 2NR London | Italian | 35566160001 | ||||||
| CARNEY, Brian | Geschäftsführer | Springwood Lodge Owler Park Road LS29 0BG Ilkley West Yorkshire | British | 100001170001 | ||||||
| CAVANNA, David John | Geschäftsführer | 8 Canada Square London E14 5HQ | United Kingdom | British | 180384720001 | |||||
| CENTONZE, Giuseppe | Geschäftsführer | 5 Harrington Close SL4 4AD Windsor Berkshire | Italian | 27832010001 | ||||||
| DI CAPUA, Vittorio Augusto | Geschäftsführer | Via Mazzini 51/53 FOREIGN Torino 10124 Italy | Italian | 27832040001 | ||||||
| DORIA, Bruno | Geschäftsführer | Via Mazzini 51/53 Torino Italy | Italian | 55825630003 | ||||||
| EVANS, Geoffrey William | Geschäftsführer | The Trumpet House Kington Lane Claverdon CV35 8PP Warwick | British | 42712190001 |
Hat HSBC PH INVESTMENTS (UK) LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Security agreement | Erstellt am 21. Dez. 2010 Geliefert am 05. Jan. 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from company or hsbc bank PLC to the secured parties or to the chargee (whether for its own account or as trustee for the secured parties) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All of its right title and interest in the deposit see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Specific legal mortgage no.6 In respect of the containers (as defined therein) | Erstellt am 31. Jan. 2001 Geliefert am 09. Feb. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the lease and the dpp (as defined) | |
Kurze Angaben All the right title and interest in the containers (as defined) received pursuant to the relevant acquisition agreement (as defined) and the proceeds of sale thereof. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Specific legal mortgage no.5 In respect of the containers (as defined therein) | Erstellt am 30. Nov. 2000 Geliefert am 04. Dez. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the lease and the dpp (as defined) | |
Kurze Angaben All right title and interest in the containers (as defined) received pursuant to the relevant acquisition agreement (as defined) and the proceeds of sale thereof. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Specific legal mortgage no.4 In respect of the containers (as defined therein) | Erstellt am 31. Okt. 2000 Geliefert am 02. Nov. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the lease and the dpp (as defined therein) | |
Kurze Angaben All right title and interest in the containers (as defined) received pursuant to the relevant aqcuisition agreement (as defined) and the proceeds of sale thereof (for further details of the property charged please refer to the form 395). see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Specific legal mortgage no.3 In respect of the containers (as defined) | Erstellt am 31. Aug. 2000 Geliefert am 08. Sept. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the lease and the dpp (as defined) | |
Kurze Angaben All right title and interest in the containers (as defined) received pursuant to the relevnt aqcuisition agreement (as defined) and the proceeds of sale thereof (please refer to form 395 for full details). See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Specific legal mortgage no.2 In respect of the containers (as defined) | Erstellt am 30. Juni 2000 Geliefert am 07. Juli 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the lease and the dpp (as defined) | |
Kurze Angaben All right,title and interest in the containers (as defined) received pursuant to the relevant acquisition agreement (as defined) and the proceeds of sale thereof. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Specific legal mortgage no. 1 between the company and p&o nedlloyd limited in respect of the containers | Erstellt am 31. Mai 2000 Geliefert am 16. Juni 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag The payment and discharge at any time of the company's express and specific obligations (actual or contingent) of the company under or pursuant to the lease (as defined) and the dpp (as defined) | |
Kurze Angaben The company as beneficial owner assigns and agrees to assigns all present and future right and title to and interest in the containers such as the company received pursuant to the relevant acquisition agreement and to the proceeds of sale thereof and charges the containers and the proceeds of sale thereof. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of mortgage in respect of the containers | Erstellt am 18. Apr. 2000 Geliefert am 08. Mai 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag The payment and discharge at any time of the company's express and specific obligations (actual or contingent) of the company under or pursuant to the lease and the dpp: (a) to pay to the mortgagee any and all amounts in respect of rebates of rent and termination sums,total loss proceeds or net sales proceeds payable to the mortgagee in accordance with the provisions of clauses 20.6.4 and 24.4.4 of the lease; (b) to discharge any lessor's encumbrances in accordance with clause 6.3 of the lease; and (c) perform its obligations under clause 19.4 of the lease and clauses 14.4,14.5,14.6 and 14.8 of the dpp and paragraphs 2.5 and 2.8 of schedule 3 of the dpp | |
Kurze Angaben All right,title and interest (if any) present and future of the company in and to each of the containers as the company shall have received pursuant to the acquisition agreement in respect thereof.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Lessor proceeds account charge | Erstellt am 18. Apr. 2000 Geliefert am 04. Mai 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag The express and specific obligations of the company to the chargee under (a) clause 20.6 (application of net total loss proceeds, requisition compensation and other compensation) and (b) clause 24.4 (application of the net sale proceeds) of the lease agreement dated 8TH april 2000 as amended and restated pursuant to a deed of amendment and restatement dated 18TH april 2000, being the obligations to rebate to the chargee by way of rebate of rent or termination amount | |
Kurze Angaben The company's rights title and interest present and future in and to the charged moneys being all moneys standing to the credit of the interest bearing dollar account of the company designated "lessor proceeds account" and with account no.242891. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0