DAVID HUGGETT MOTOR FACTORS LIMITED
Überblick
Unternehmensname | DAVID HUGGETT MOTOR FACTORS LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 01052555 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von DAVID HUGGETT MOTOR FACTORS LIMITED?
- Großhandel mit Kraftfahrzeugteilen und -zubehör (45310) / Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen
Wo befindet sich DAVID HUGGETT MOTOR FACTORS LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | C/O Teneo Restructuring Limited 156 Great Charles Street Queensway B3 3HN Birmingham West Midlands |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von DAVID HUGGETT MOTOR FACTORS LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2018 |
Welche sind die letzten Einreichungen für DAVID HUGGETT MOTOR FACTORS LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 14 Seiten | LIQ13 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 156 Great Charles Street Queensway Birmingham West Midlands B3 3HN zum C/O Teneo Restructuring Limited 156 Great Charles Street Queensway Birmingham West Midlands B3 3HN am 06. Sept. 2021 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Deloitte Llp 1 City Square Leeds West Yorkshire LS1 2AL zum 156 Great Charles Street Queensway Birmingham West Midlands B3 3HN am 28. Juni 2021 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Dez. 2020 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 1 Colmore Square Birmingham B4 6AA England zum 1 City Square Leeds West Yorkshire LS1 2AL am 14. Dez. 2020 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 6 Seiten | LIQ01 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 30. März 2020
| 5 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Dez. 2019 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verkürzt von 30. Juni 2019 bis 31. Dez. 2018 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Juni 2018 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Dez. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 31. März 2018 bis 30. Juni 2018 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 12 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessation of David Robert Huggett as a person with significant control on 02. Feb. 2018 | 1 Seiten | PSC07 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Deborah Karen Baker als Geschäftsführer am 02. Feb. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Robert Huggett als Geschäftsführer am 02. Feb. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Notification of Alliance Automotive Uk Limited as a person with significant control on 02. Feb. 2018 | 1 Seiten | PSC02 | ||||||||||
Cessation of Valerie Patricia Huggett as a person with significant control on 02. Feb. 2018 | 1 Seiten | PSC07 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von DAVID HUGGETT MOTOR FACTORS LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COOMBES, John Frederick | Geschäftsführer | 156 Great Charles Street Queensway B3 3HN Birmingham C/O Teneo Restructuring Limited West Midlands | England | British | Accountant | 74985930002 | ||||
HUGGETT, Valerie Patricia | Sekretär | Tamarind 1 Strawberry Fields SG12 0DB Ware Hertfordshire | British | 4784950001 | ||||||
BAKER, Deborah Karen | Geschäftsführer | 2 Beningfield Drive Napsbury Park AL2 1UJ St Albans Hertfordshire | United Kingdom | British | Sales Director | 60522120003 | ||||
DROY, Deborah Karen | Geschäftsführer | 7 Cresset Close Stanstead Abbotts SG12 8LL Hertfordshire | British | Motor Painter | 60522120001 | |||||
HUGGETT, David Robert | Geschäftsführer | Tamarind 1 Strawberry Fields SG12 0DB Ware Hertfordshire | United Kingdom | British | Motor Factor | 4784960001 | ||||
HUGGETT, Valerie Patricia | Geschäftsführer | Tamarind 1 Strawberry Fields SG12 0DB Ware Hertfordshire | United Kingdom | British | Motor Factor | 4784950001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei DAVID HUGGETT MOTOR FACTORS LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alliance Automotive Uk Limited | 02. Feb. 2018 | Colmore Square B4 6AA Birmingham 1 England | Nein | ||||
| |||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||
Mrs Valerie Patricia Huggett | 06. Apr. 2016 | 1 Strawberry Fields SG12 0DB Ware Tamarind Hertfordshire United Kingdom | Ja | ||||
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: United Kingdom | |||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||
Mrs Deborah Karen Baker | 06. Apr. 2016 | Napsbury Park AL2 1UJ St Albans 2 Beningfield Drive Hertfordshire United Kingdom | Ja | ||||
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: United Kingdom | |||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||
Mr David Robert Huggett | 06. Apr. 2016 | 1 Strawberry Fields SG12 0DB Ware Tamarind Hertfordshire United Kingdom | Ja | ||||
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: United Kingdom | |||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat DAVID HUGGETT MOTOR FACTORS LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Legal charge | Erstellt am 24. Juni 2005 Geliefert am 07. Juli 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben Land and buildings on the east side of britannia road waltham cross herts t/n HD191375. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Rent deposit deed | Erstellt am 07. März 2003 Geliefert am 14. März 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £2,125.00 due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben A deposit account. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 17. Aug. 2001 Geliefert am 23. Aug. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage debenture | Erstellt am 23. Mai 1994 Geliefert am 02. Juni 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 17. Aug. 1988 Geliefert am 30. Aug. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Single debenture | Erstellt am 25. Jan. 1988 Geliefert am 28. Jan. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Aircraft mortgage | Erstellt am 19. Juli 1983 Geliefert am 25. Juli 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £26,881 and all other monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben Type: beech craft baron 58 regst:g-bdwk serial no: th 755 engines: 2 x continental 10-520-c. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Further guarantee & debenture | Erstellt am 03. Feb. 1983 Geliefert am 18. Feb. 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All that property undertaking and assets charges by the principal deed and further deed. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Aircraft mortgage | Erstellt am 18. Okt. 1980 Geliefert am 04. Nov. 1980 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £44,000 | |
Kurze Angaben Aircraft serial no. Th 755 baron, type beech 58 registration mark 9-bwdk nationally: british registered in great britain. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Further guarantee & debenture | Erstellt am 30. März 1978 Geliefert am 06. Apr. 1978 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever. | |
Kurze Angaben All that property, undertaking & assets charged by the principal deed & further deeds. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 23. Juni 1977 Geliefert am 05. Juli 1977 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 171 hatfield road, st. Albans, hertfordshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Hat DAVID HUGGETT MOTOR FACTORS LIMITED Insolvenzverfahren?
Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0