MCKENNA FUNERALS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | MCKENNA FUNERALS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Umwandlung / Auflösung |
| Rechtsform | Umwandlung / Auflösung |
| Unternehmensnummer | 01055840 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von MCKENNA FUNERALS LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich MCKENNA FUNERALS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | New Century House Corporation Street M60 4ES Manchester |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MCKENNA FUNERALS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 11. Jan. 2012 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für MCKENNA FUNERALS LIMITED?
| Jahresabschluss |
|
|---|
Welche sind die letzten Einreichungen für MCKENNA FUNERALS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verschiedenes Forms b & z - convert to i&ps | 2 Seiten | MISC | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 11. Jan. 2012 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr Andrew Oldale als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Neil Walker als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Hendry als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 20. Okt. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 11. Jan. 2011 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 20. Okt. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 11. Jan. 2010 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mrs Caroline Jane Sellers als Sekretär | 1 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Katherine Eldridge als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 20. Okt. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 10. Jan. 2009 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 12. Jan. 2008 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 225 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von MCKENNA FUNERALS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SELLERS, Caroline Jane | Sekretär | New Century House Corporation Street M60 4ES Manchester | 150069940001 | |||||||
| OLDALE, Andrew | Geschäftsführer | New Century House Corporation Street M60 4ES Manchester | England | British | 167083200001 | |||||
| TINNING, George Murray | Geschäftsführer | 17 Briar Road Kirkintilloch G66 3SA Glasgow | United Kingdom | British | 126913730001 | |||||
| ELDRIDGE, Katherine Elizabeth | Sekretär | 5 Stanley Avenue Hazel Grove SK7 4ED Stockport | British | 110230860001 | ||||||
| JONES, Philip Robert | Sekretär | 10 Crowhurst Drive Whitley WN1 2QH Wigan Lancashire | English | 43686960001 | ||||||
| KEW, Philip Anthony | Sekretär | 31 Maypole Gardens Wistowgate YO8 3TG Cawood North Yorkshire | British | 84868550001 | ||||||
| SALMONS, Raymond | Sekretär | Fox Hollow Sovereign Lane Ashley TF9 4LS Market Drayton Shropshire | British | 33031700001 | ||||||
| UCL SECRETARY LIMITED | Sekretär | United Co Operatives Limited Sandbrook Park Sandbrook Way OL11 1RY Rochdale Lancashire | 111685670001 | |||||||
| BEAUMONT, Martin Dudley | Geschäftsführer | Hand Green House Hand Green CW6 9SN Tarporley Cheshire | United Kingdom | British | 10084840001 | |||||
| BROWN, Alan | Geschäftsführer | 81 Harewood Close Norden OL11 5TJ Rochdale Lancashire | England | British | 31749420001 | |||||
| DUGMORE, Peter Fawcett | Geschäftsführer | Woodview Boathouse Lane WF14 8HQ Mirfield Yorkshire | United Kingdom | British | 88084280001 | |||||
| HENDRY, David Buchan | Geschäftsführer | Cardney Estate Butterstone PH8 0EY By Dunkeld Over Cardney Farmhouse Perthshire | Scotland | British | 128555100001 | |||||
| JONES, Philip Robert | Geschäftsführer | 10 Crowhurst Drive Whitley WN1 2QH Wigan Lancashire | United Kingdom | English | 43686960001 | |||||
| KEW, Philip Anthony | Geschäftsführer | 31 Maypole Gardens Wistowgate YO8 3TG Cawood North Yorkshire | England | British | 84868550001 | |||||
| MARKS, Peter Vincent | Geschäftsführer | The Old Barn Low House Farm Otley Road Eldwick BD16 3AZ Bingley West Yorkshire | United Kingdom | British | 87486470001 | |||||
| PRESTON, James Heath | Geschäftsführer | 6 Newenden Road WN1 2PX Wigan Lancashire | British | 28469580001 | ||||||
| SALMONS, Raymond | Geschäftsführer | Fox Hollow Sovereign Lane Ashley TF9 4LS Market Drayton Shropshire | British | 33031700001 | ||||||
| SILVER, Steven Russell | Geschäftsführer | Farr Royd House 72 Sun Lane LS29 7LT Burley In Wharfedale West Yorkshire | England | British | 182256460001 | |||||
| THOMPSON, Christopher Howard Gould | Geschäftsführer | 1 Norfolk Road HG2 8DA Harrogate North Yorkshire | United Kingdom | British | 38632440001 | |||||
| THOMSON, John | Geschäftsführer | Five Oaks 56 Parkway Dairyfields Trentham ST4 8AG Stoke On Trent Staffordshire | British | 57103470001 | ||||||
| WALKER, Neil James | Geschäftsführer | 224a Bramhall Lane South Bramhall SK7 3AA Stockport Cheshire | England | British | 126913860001 | |||||
| WALKER, Neil James | Geschäftsführer | 87 Woodsmoor Lane Woodsmoor SK2 7BD Stockport Cheshire | British | 98761120001 | ||||||
| WATES, Martyn James | Geschäftsführer | 3 Aylesby Close WA16 8AE Knutsford Cheshire | United Kingdom | British | 60114700001 | |||||
| YORATH, Delma Rose | Geschäftsführer | 5 Holt Lane Mews Failsworth M35 9ND Greater Manchester | British | 41961000001 | ||||||
| UCL DIRECTOR 1 LIMITED | Geschäftsführer | United Co-Operatives Limited Sandbrook Park OL11 1RY Rochdale | 110868260001 |
Hat MCKENNA FUNERALS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Legal mortgage | Erstellt am 06. Juni 1987 Geliefert am 22. Juni 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H land in halliwell st, chorley, lancs and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 05. März 1987 Geliefert am 10. März 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land & buildings lying to the south east side of queen st, blackpool, lancs. La 534685 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 08. Dez. 1986 Geliefert am 15. Dez. 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land and buildings lying to the east of grimshaw park, blackburn, lancs. La 232914 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 08. Dez. 1986 Geliefert am 15. Dez. 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 103 eccles new rd, salford, greater manchester la 178594 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 08. Dez. 1986 Geliefert am 15. Dez. 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 339 garstang road, fulwood. Preston title no la 464958 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 08. Dez. 1986 Geliefert am 15. Dez. 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a 66 derby road longridge lancashire. And the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 08. Dez. 1986 Geliefert am 15. Dez. 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 105 eccles new road. Weaste salford title no la 8978 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 04. Nov. 1985 Geliefert am 11. Nov. 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 43 and 45 grimshaw park blackburn lancashire title no la 496906 and la 232915 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 04. Nov. 1985 Geliefert am 11. Nov. 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 39 and 41 grimshaw park blackburn lancashire title no LA386496 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 04. Nov. 1985 Geliefert am 11. Nov. 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 2,4,6 and 8 crossfield street blackburn lancashire la 274676, la 225134, la 15698 and title no la 239299 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 29. Aug. 1984 Geliefert am 08. Sept. 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £18,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargees. | |
Kurze Angaben F/H 103 market street chorley, lancs, tog-with the land. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 01. Nov. 1982 Geliefert am 15. Nov. 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H 10 newton drive blackpool lancs. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0