GBC (UNITED KINGDOM) LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | GBC (UNITED KINGDOM) LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01056410 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von GBC (UNITED KINGDOM) LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich GBC (UNITED KINGDOM) LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Oxford House Oxford Road HP21 8SZ Aylesbury Buckinghamshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von GBC (UNITED KINGDOM) LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| IBICO LIMITED | 31. Mai 1972 | 31. Mai 1972 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von GBC (UNITED KINGDOM) LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2020 |
Welche sind die letzten Einreichungen für GBC (UNITED KINGDOM) LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 11. Aug. 2021
| 5 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 20. Juli 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Ms Katherine Alexandra Spence am 10. Mai 2021 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Ms Katherine Alexandra Spence am 10. Mai 2021 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2020 | 4 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 20. Juli 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2019 | 4 Seiten | AA | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Christopher Neil Hopkinson als Direktor am 05. Juni 2020 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Ernennung von Ms Katherine Alexandra Spence als Direktor am 05. Juni 2020 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Walter Joe Thomas als Geschäftsführer am 22. Mai 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Ernennung von Ms Katherine Alexandra Spence als Sekretär am 05. Juni 2020 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Robert Michael Grimes als Sekretär am 01. Juni 2020 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 20. Juli 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 4 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 20. Juli 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Notification of a person with significant control statement | 2 Seiten | PSC08 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Robert Michael Grimes als Sekretär am 30. Apr. 2018 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Christopher Neil Hopkinson als Geschäftsführer am 30. Apr. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von GBC (UNITED KINGDOM) LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIOR, Katherine Alexandra | Sekretär | Oxford House Oxford Road HP21 8SZ Aylesbury Buckinghamshire | 270502710002 | |||||||
| HOPKINSON, Christopher Neil, Mr. | Geschäftsführer | Oxford House Oxford Road HP21 8SZ Aylesbury Buckinghamshire | England | British | 270498480001 | |||||
| PRIOR, Katherine Alexandra | Geschäftsführer | Oxford House Oxford Road HP21 8SZ Aylesbury Buckinghamshire | England | British | 248359400002 | |||||
| BARKER, Ruth | Sekretär | 77 The Crofts RG22 4RE Basingstoke Hampshire | British | 99632990001 | ||||||
| DOVER, Paul William | Sekretär | Silverdale Fox Lane Oakley RG23 7BB Basingstoke Hampshire | British | 48335550001 | ||||||
| EVANS, Paul William Hywel | Sekretär | 38 Inkpen Gardens RG24 8YQ Basingstoke Hampshire | British | 80520290001 | ||||||
| GEDDIE, Richard Mark | Sekretär | 15 Pine Grove Bricket Wood AL2 3ST St. Albans Hertfordshire | British | 80783870001 | ||||||
| GRIMES, Robert Michael | Sekretär | Oxford House Oxford Road HP21 8SZ Aylesbury Buckinghamshire | 245928620001 | |||||||
| MORRIS, Ruth Margaret | Sekretär | 61 Wordsworth Road TW12 1EW Hampton Middlesex | British | 39201870001 | ||||||
| VALE, Ronald Edward | Sekretär | 5 Ashwood Drive BH18 8LN Broadstone Dorset | British | 5033030001 | ||||||
| ATTRIDGE, David Roy | Geschäftsführer | 40 Meadowridge Hatch Warren RG22 4QH Basingstoke Hampshire | British | 56376820002 | ||||||
| BEERKENS, Michel Antoon Victor | Geschäftsführer | Geldropseweg 19 Heeze 5591ea Netherlands | Dutch | 80928430002 | ||||||
| DAVIES, Emma Susan | Geschäftsführer | Lawn Hill Cottage OX17 1ET Claydon Oxfordshire | United Kingdom | British | 126575640001 | |||||
| DOVER, Paul William | Geschäftsführer | Silverdale Fox Lane Oakley RG23 7BB Basingstoke Hampshire | England | British | 48335550001 | |||||
| EVANS, Paul William Hywel | Geschäftsführer | 38 Inkpen Gardens RG24 8YQ Basingstoke Hampshire | British | 80520290001 | ||||||
| FIRTH, Stephen | Geschäftsführer | 2 Lansdowne Road Frimley GU16 5UW Camberley Surrey | British | 56829340001 | ||||||
| GEDDIE, Richard Mark | Geschäftsführer | Bricket Wood AL2 3ST St Albans 15 Pine Grove Herts England | England | British | 80783870001 | |||||
| GREEN, Howard Benjamin | Geschäftsführer | 1325 North Sutton Place 60610 Chicago Illinois Usa | American | 57046060002 | ||||||
| GUEST, Richard Hamilton | Geschäftsführer | 7 Townshend Road TW9 1XH Richmond | England | British | 122869580001 | |||||
| HOPKINSON, Christopher Neil, Mr. | Geschäftsführer | Oxford House Oxford Road HP21 8SZ Aylesbury Buckinghamshire | England | British | 270498480001 | |||||
| MOSELEY, Elizabeth Violet | Geschäftsführer | Oxford Road HP21 8SZ Aylesbury Oxford House Buckinghamshire | England | British | 193913710001 | |||||
| MUGRIDGE, Ellis John | Geschäftsführer | 58 Wentworth Crescent RG22 4WX Basingstoke Hampshire | England | British | 115153160001 | |||||
| MUNK, Peter | Geschäftsführer | 58 Geffers Ride SL5 7JZ Ascot Berkshire | United Kingdom | Danish | 112581070001 | |||||
| PAGE, Andrew Stephen | Geschäftsführer | Russell Avenue MK40 3TD Bedford 29 Bedfordshire England | England | British | 86557080001 | |||||
| REDDY, Govi | Geschäftsführer | 14 Long Meadow Drive 60010 Barrington Hills Illinois Usa | American | 57046400001 | ||||||
| RUBIN, Steven | Geschäftsführer | 4 Norbert Drive Hawthorn Woods Illinois 60047 Usa | American | 56376640004 | ||||||
| STENEBRING, Thomas | Geschäftsführer | Av. Des Alouettes 50 Rhode-St-Genese B-1640 Belgium | Swedish | 71744640001 | ||||||
| THEIL FARTH, Rainer Erwin | Geschäftsführer | 9 Brampton Chase Lower Shiplake RG9 3BX Henley On Thames Oxfordshire | British | 39201670001 | ||||||
| THOMAS, Walter Joe, Dr | Geschäftsführer | Oxford House Oxford Road HP21 8SZ Aylesbury Buckinghamshire | United Kingdom | British | 217919870001 | |||||
| WOLFENSBERGER, Ulrich Andreas, Dr | Geschäftsführer | Seestrasse 79 FOREIGN Rushlikon Zh 8803 Switzerland | Swiss | 11149790001 |
Wie lauten die letzten Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss für GBC (UNITED KINGDOM) LIMITED?
| Benachrichtigt am | Aufgehört am | Erklärung |
|---|---|---|
| 01. Jan. 2017 | Das Unternehmen weiß oder hat Grund zu der Annahme, dass es keine registrierungspflichtige Person oder registrierungspflichtige relevante juristische Person in Bezug auf das Unternehmen gibt. |
Hat GBC (UNITED KINGDOM) LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 30. Sept. 2009 Geliefert am 08. Okt. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and the other foreign credit parties to the lender creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating charge | Erstellt am 30. Dez. 2003 Geliefert am 03. Jan. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 22. März 2001 Geliefert am 28. März 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 15. Dez. 1997 Geliefert am 22. Dez. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of charge over credit balances | Erstellt am 15. Apr. 1996 Geliefert am 18. Apr. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed charge over all the deposit(s) being all sums of money in any currency (a) deposited or paid by the company to the credit of the account(s) with the bank re: ibico LTD business premium account no. 80389226 and/or any additional and/or substitute account(s) opened with the bank (b) deposited or paid by the company with or to the bank or held by the bank on behalf of the company and (c) respresenting the renewal or replacement of or for any sums deposited or paid or held as aforesaid, together with all interest accruing thereon. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of transfer | Erstellt am 15. Feb. 1996 Geliefert am 06. März 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the debenture | |
Kurze Angaben All freehold and leasehold property of the company situate in england and wales. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of charge over credit balances | Erstellt am 12. Apr. 1995 Geliefert am 24. Apr. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed charge over all deposits as shown in the schedule and all interest thereon. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 05. Apr. 1994 Geliefert am 22. Apr. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 28. Okt. 1991 Geliefert am 07. Nov. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0