NORFOLK CAPITAL HOTELS (SOUTHERN) LIMITED

NORFOLK CAPITAL HOTELS (SOUTHERN) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameNORFOLK CAPITAL HOTELS (SOUTHERN) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01061613
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von NORFOLK CAPITAL HOTELS (SOUTHERN) LIMITED?

    • Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften

    Wo befindet sich NORFOLK CAPITAL HOTELS (SOUTHERN) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    St. James House 3rd Floor, South Wing
    27-43 Eastern Road
    RM1 3NH Romford
    Essex
    United Kingdom
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von NORFOLK CAPITAL HOTELS (SOUTHERN) LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    THE SLOANE CLUB GROUP LIMITED23. März 198823. März 1988
    BLAKENEY HOTELS LIMITED31. Dez. 198031. Dez. 1980
    SLOANE CLUB LIMITED31. Dez. 197631. Dez. 1976
    ANALGA LIMITED17. Juli 197217. Juli 1972

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von NORFOLK CAPITAL HOTELS (SOUTHERN) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2022

    Welche sind die letzten Einreichungen für NORFOLK CAPITAL HOTELS (SOUTHERN) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt.

    1 SeitenSOAS(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2022

    18 SeitenAA

    Kapitalaufstellung am 28. Sept. 2023

    • Kapital: GBP 1
    5 SeitenSH19

    legacy

    1 SeitenSH20

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Reduce share premium 27/09/2023
    RES13
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    Change of details for Norfolk Capital Group Limited as a person with significant control on 07. Aug. 2023

    2 SeitenPSC05

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Valor Hospitality Europe Ltd St. James House, 3rd Floor, South Wing 27-43 Eastern Road Romford Essex RM1 3NH United Kingdom zum St. James House 3rd Floor, South Wing 27-43 Eastern Road Romford Essex RM1 3NH am 07. Aug. 2023

    1 SeitenAD01

    Bestätigungserklärung erstellt am 09. Juni 2023 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Änderung der Details des Direktors für Ms Warunya Punawakul am 24. März 2023

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Ms Wanida Suksuwan am 24. März 2023

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Hansa Susayan am 24. März 2023

    2 SeitenCH01

    Change of details for Norfolk Capital Group Limited as a person with significant control on 24. März 2023

    2 SeitenPSC05

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Queens Court 9-17 Eastern Road Romford Essex RM1 3NG zum Valor Hospitality Europe Ltd St. James House, 3rd Floor, South Wing 27-43 Eastern Road Romford Essex RM1 3NH am 24. März 2023

    1 SeitenAD01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2021

    19 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 09. Juni 2022 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2020

    19 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 09. Juni 2021 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Erfüllung der Belastung 010616130028 vollständig

    1 SeitenMR04

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2019

    18 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 09. Juni 2020 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Beendigung der Bestellung von Christopher Andre Kula als Geschäftsführer am 10. Dez. 2019

    1 SeitenTM01

    Wer sind die Geschäftsführer von NORFOLK CAPITAL HOTELS (SOUTHERN) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    PUNAWAKUL, Warunya
    3rd Floor, South Wing
    27-43 Eastern Road
    RM1 3NH Romford
    St. James House
    Essex
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    3rd Floor, South Wing
    27-43 Eastern Road
    RM1 3NH Romford
    St. James House
    Essex
    United Kingdom
    ThailandThai265448120001
    SUKSUWAN, Wanida
    3rd Floor, South Wing
    27-43 Eastern Road
    RM1 3NH Romford
    St. James House
    Essex
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    3rd Floor, South Wing
    27-43 Eastern Road
    RM1 3NH Romford
    St. James House
    Essex
    United Kingdom
    ThailandThai265450970001
    SUSAYAN, Hansa
    3rd Floor, South Wing
    27-43 Eastern Road
    RM1 3NH Romford
    St. James House
    Essex
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    3rd Floor, South Wing
    27-43 Eastern Road
    RM1 3NH Romford
    St. James House
    Essex
    United Kingdom
    ThailandThai265450980001
    BURGESS, Keith John
    3 Queen Annes Gate
    White House Walk
    GU9 9AN Farnham
    Surrey
    Sekretär
    3 Queen Annes Gate
    White House Walk
    GU9 9AN Farnham
    Surrey
    British7009790002
    CHRISTIAN, Tracy Joanne
    19 Lovell Walk
    RM13 7ND Rainham
    Essex
    Sekretär
    19 Lovell Walk
    RM13 7ND Rainham
    Essex
    British102667300001
    COUGHLAN, Sally Ann
    Queens Court
    9-17 Eastern Road
    RM1 3NG Romford
    Queens Court
    Essex
    England
    Sekretär
    Queens Court
    9-17 Eastern Road
    RM1 3NG Romford
    Queens Court
    Essex
    England
    British107832420001
    JONES, Vanessa
    Stables House
    Castle Hill
    RH1 4LB Bletchingley
    Surrey
    Sekretär
    Stables House
    Castle Hill
    RH1 4LB Bletchingley
    Surrey
    British72146200001
    PURVIS, Martin Terence Alan
    Fenetters
    Melfort Road
    TN6 1QT Crowborough
    East Sussex
    Sekretär
    Fenetters
    Melfort Road
    TN6 1QT Crowborough
    East Sussex
    British7901050001
    WALLER, Ronald John
    Brindles 118 Hanging Hill Lane
    CM13 2HN Brentwood
    Essex
    Sekretär
    Brindles 118 Hanging Hill Lane
    CM13 2HN Brentwood
    Essex
    British1210620001
    WATERS, Jonathan Roy
    Maldon Road
    CO3 3BQ Colchester
    237
    Essex
    Sekretär
    Maldon Road
    CO3 3BQ Colchester
    237
    Essex
    British129848360001
    ALLSOP, Heather Louise
    62 Prebend Street
    N1 8PS London
    Geschäftsführer
    62 Prebend Street
    N1 8PS London
    British101912850001
    ARZI, David
    38th Floor
    NY 10036 New York
    One Bryant Park
    Usa
    Geschäftsführer
    38th Floor
    NY 10036 New York
    One Bryant Park
    Usa
    United StatesAmerican190079640001
    BAIRSTOW, John
    Frieze Cottage Coxtie Green Road
    South Weald
    CM14 5RE Brentwood
    Essex
    Geschäftsführer
    Frieze Cottage Coxtie Green Road
    South Weald
    CM14 5RE Brentwood
    Essex
    British537400001
    BELL, Gerald James
    Cavewood Rectory Lane
    Datchworth
    SG3 6RD Knebworth
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Cavewood Rectory Lane
    Datchworth
    SG3 6RD Knebworth
    Hertfordshire
    British47018930002
    BOULD, Andrew Robin Douglas
    508 Uxbridge Road
    HA5 4SG Pinner
    Middlesex
    Geschäftsführer
    508 Uxbridge Road
    HA5 4SG Pinner
    Middlesex
    British36875610001
    BRAIDLEY, Jonathan Patrick
    16 Palace Street
    SW1E 5JD London
    Mcap Global Finance (Uk) Llp
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    16 Palace Street
    SW1E 5JD London
    Mcap Global Finance (Uk) Llp
    United Kingdom
    United KingdomBritish190075510001
    CAIRNS, Michael Anthony
    Birchlands
    Old Avenue
    KT13 0PY Weybridge
    Surrey
    Geschäftsführer
    Birchlands
    Old Avenue
    KT13 0PY Weybridge
    Surrey
    United KingdomBritish36488470001
    COLES, Alan Clifford
    The Knoll
    Grendon
    NN7 1JG Northampton
    Beeches, 5
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    The Knoll
    Grendon
    NN7 1JG Northampton
    Beeches, 5
    Northamptonshire
    EnglandBritish101144900002
    COLLYER, Brian Charles
    49 Route De Croissy
    78110 Le Vesinet
    France
    Geschäftsführer
    49 Route De Croissy
    78110 Le Vesinet
    France
    Canadian101144260001
    COPPEL, Andrew Maxwell
    Orchard House
    8 Claremont Park Road
    KT10 9LT Esher
    Surrey
    Geschäftsführer
    Orchard House
    8 Claremont Park Road
    KT10 9LT Esher
    Surrey
    EnglandBritish14330100002
    FINKLEMAN, Michael David
    Charlewood
    Manor Crescent, Seer Green
    HP9 2QX Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Charlewood
    Manor Crescent, Seer Green
    HP9 2QX Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British66057660001
    GOIN, Russell Todd
    4 Rue Jadin
    75017
    FOREIGN Paris
    France
    Geschäftsführer
    4 Rue Jadin
    75017
    FOREIGN Paris
    France
    American108675490001
    HERSEY, David Michael
    Greenways
    Ridgeway Hutton Mount
    CM13 2LS Brentwood
    Essex
    Geschäftsführer
    Greenways
    Ridgeway Hutton Mount
    CM13 2LS Brentwood
    Essex
    British17567250001
    KABALAN, Fadi
    Keyes House
    Dolphin Square
    SW1V 3NA London
    Suite 311
    Geschäftsführer
    Keyes House
    Dolphin Square
    SW1V 3NA London
    Suite 311
    EnglandBritish133846470001
    KRAIS, Ashley Simon
    74 Marsh Lane
    NW7 4NT London
    Geschäftsführer
    74 Marsh Lane
    NW7 4NT London
    United KingdomBritish105921220001
    KULA, Christopher Andre
    16 Palace Street
    SW1E 5JD London
    Mcap Global Finance (Uk) Llp
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    16 Palace Street
    SW1E 5JD London
    Mcap Global Finance (Uk) Llp
    United Kingdom
    United KingdomBritish,Canadian,German219684180001
    LE POIDEVIN, Andrew Daryl
    Kinneil
    34 Bulstrode Way
    SL9 7QU Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Kinneil
    34 Bulstrode Way
    SL9 7QU Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    EnglandBritish4958800007
    MAIDE, George Barry
    Fourwinds
    Long Walk
    HP8 4AW Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Fourwinds
    Long Walk
    HP8 4AW Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    British36125260001
    MAIDEN, George Barry
    Fourwinds Long Walk
    HP8 4AW Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Fourwinds Long Walk
    HP8 4AW Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    British8832120001
    MARCUS, Martin Alan
    17 Monkhams Drive
    IG8 0LG Woodford Green
    Essex
    Geschäftsführer
    17 Monkhams Drive
    IG8 0LG Woodford Green
    Essex
    British35543430001
    MENARD, Veronique Pascale Dominique
    Goldman Sachs International
    Peterborough Court, 133 Fleet Street
    EC4A 2BB London
    Goldman Sachs International
    England
    Geschäftsführer
    Goldman Sachs International
    Peterborough Court, 133 Fleet Street
    EC4A 2BB London
    Goldman Sachs International
    England
    United KingdomFrench141156250001
    METCALFE, Michael Stuart
    Harwil 37 Howards Thicket
    SL9 7NT Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Harwil 37 Howards Thicket
    SL9 7NT Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    EnglandBritish40294180002
    MOORE, Richard John
    2 Maple Wood
    Bedhampton
    PO9 3JB Havant
    Hampshire
    Geschäftsführer
    2 Maple Wood
    Bedhampton
    PO9 3JB Havant
    Hampshire
    EnglandBritish101144680001
    MULAHASANI, Heather Louise
    Goldman Sachs International
    Peterborough Court, 133 Fleet Street
    EC4A 2BB London
    Goldman Sachs International
    Geschäftsführer
    Goldman Sachs International
    Peterborough Court, 133 Fleet Street
    EC4A 2BB London
    Goldman Sachs International
    EnglandBritish136994090001
    OGDEN, Kathryn
    14 Arundel Court
    43-47 Arundel Gardens
    W11 2LP London
    Geschäftsführer
    14 Arundel Court
    43-47 Arundel Gardens
    W11 2LP London
    American114248790002

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei NORFOLK CAPITAL HOTELS (SOUTHERN) LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    3rd Floor, South Wing
    27-43 Eastern Road
    RM1 3NH Romford
    St. James House
    Essex
    United Kingdom
    06. Apr. 2016
    3rd Floor, South Wing
    27-43 Eastern Road
    RM1 3NH Romford
    St. James House
    Essex
    United Kingdom
    Nein
    RechtsformLimited By Shares
    RegistrierungslandEngland
    RechtsgrundlageUnited Kingdom (England)
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer414351
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Wie lauten die letzten Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss für NORFOLK CAPITAL HOTELS (SOUTHERN) LIMITED?

    Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss
    Benachrichtigt amAufgehört amErklärung
    09. Juni 201725. Jan. 2018Das Unternehmen hat die erforderlichen Schritte zur Ermittlung, ob eine Person eine registrierungspflichtige Person oder eine registrierungspflichtige relevante juristische Person in Bezug auf das Unternehmen ist, noch nicht abgeschlossen.

    Hat NORFOLK CAPITAL HOTELS (SOUTHERN) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 28. Nov. 2017
    Geliefert am 28. Nov. 2017
    Vollständig erfüllt
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag, London Branch
    Transaktionen
    • 28. Nov. 2017Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 27. Nov. 2020Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 23. Juli 2015
    Geliefert am 05. Aug. 2015
    Vollständig erfüllt
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag, London Branch as Security Agent
    Transaktionen
    • 05. Aug. 2015Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 09. Aug. 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Security agreement
    Erstellt am 22. Feb. 2011
    Geliefert am 02. März 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each chargor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    (For details of properties charged please refer to form MG01) fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C.
    Transaktionen
    • 02. März 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 19. Aug. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 23. Feb. 2005
    Geliefert am 11. März 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due by an obligor or by some other person of each obligor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Gs Mortgage Funding No.1 Limited (As Security Trustee for the Finance Parties)
    Transaktionen
    • 11. März 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. März 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    A composite guarantee and debenture
    Erstellt am 23. Feb. 2005
    Geliefert am 04. März 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to the secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Goldman Sachs Credit Partners, L.P.
    Transaktionen
    • 04. März 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Aug. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 24. Nov. 2004
    Geliefert am 14. Dez. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to the secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of legal mortgage all estates or interests in the f/h, l/h and other immovable property. By way of fixed charge all estates or interests in any f/h, l/h and other immovable property, all stocks shares debentures bonds notes and loan capital, the goodwill, all copyrights and patents. By way of floating charge the undertaking and all its property assets and rights. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Goldman Sachs Credit Partners, L.P.
    Transaktionen
    • 14. Dez. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. März 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 18. Juni 2004
    Geliefert am 25. Juni 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Law Debenture Trust Coproration PLC
    Transaktionen
    • 25. Juni 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Feb. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental deed to the composite guarantee and debenture
    Erstellt am 08. Juni 2004
    Geliefert am 11. Juni 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor including the company to the security trustee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of legal mortgage the legally mortgaged property and sale thereof, by way of fixed charge all stocks, shares, the goodwill and uncalled capital, all copyrights, patents, by way of floating charge the undertaking, all property, assets and rights. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC (As Agent and Security Trustee for the Junior Term Lenders Defined in Theterm Facility Agreement)
    Transaktionen
    • 11. Juni 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Nov. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 25. März 2004
    Geliefert am 26. März 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor including the company to the security trustee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of legal mortgage the legally mortgaged property and sale thereof, by way of fixed charge all stocks, shares, the goodwill and uncalled capital, all copyrights, patents, by way of floating charge the undertaking, all property, assets and rights. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC (As Agent and Security Trustee for the Junior Term Lenders)
    Transaktionen
    • 26. März 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Nov. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Third supplemental trust deed
    Erstellt am 10. Dez. 1991
    Geliefert am 10. Dez. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The principal of and interest on the £95,000,000 10 1/4 per cent.first mortgage debenture stock 2020 of queens moat houses P.L.C. (the "new stock") and all other monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the trust deeds as defined therein
    Kurze Angaben
    Properties detailed on doc ref M748C see doc for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Guardian Royal Exchange Assurance PLC
    Transaktionen
    • 10. Dez. 1991Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Juni 2004Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 14. Juli 2004Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 07. März 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 15. Jan. 1988
    Geliefert am 29. Jan. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or passplanet limited to the chargee on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    Being the whole of nos 52 to 66 (even numbers) lower sloane street and the under leased property comprising part of the head leasehold property k/a or being the ground and basement floors of nos 54 to 66 (even numbers) lower sloane street aforesaid. Title no's ngl 519204 (head leasehold ) and ngl 469324 ( under leasehold) royal borough of kensington & chelsea.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 29. Jan. 1988Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 17. Okt. 1986
    Geliefert am 23. Okt. 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to a loan agreement dated 17/10/86
    Kurze Angaben
    L/H property k/a 52 to 66 (even nos) lower sloane street SW1 title no NGL519204 under l/h property k/a part 54 to 66 lower sloane street SW1 title no NGL469324, all buildings erections fixtures and fittings and fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Caisec National Decredit Agricole
    Transaktionen
    • 23. Okt. 1986Registrierung einer Belastung
    • 27. Nov. 1991Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 21. März 1986
    Geliefert am 27. März 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H 57 sloane gardens london SW1.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 27. März 1986Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 03. Sept. 1985
    Geliefert am 09. Sept. 1985
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    17 crescent lane bath, avon.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 09. Sept. 1985Registrierung einer Belastung
    • 27. Nov. 1991Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 22. Aug. 1985
    Geliefert am 29. Aug. 1985
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    52/66, lower sloane street kensington and chelsea.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 29. Aug. 1985Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 09. Juli 1984
    Geliefert am 19. Juli 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H nos 13 & 14 royal cres bath tn av 77322 together with all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878.. together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Berechtigte Personen
    • Williams & Glyn's Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Juli 1984Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 26. Apr. 1984
    Geliefert am 02. Mai 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H 15 crescent lane, bath, avon title no AV85288.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 02. Mai 1984Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 06. Jan. 1984
    Geliefert am 13. Aug. 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H ground floor & basement 54-66 lower sloane street kensington & chelsea london SW1 title no ngl 469324.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Aug. 1984Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 14. Jan. 1983
    Geliefert am 20. Juni 1983
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H 14, crescent lane, bath, avon title no av 15358.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 20. Juni 1983Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 14. Jan. 1983
    Geliefert am 24. Jan. 1983
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H 52/66, power sloane street, london SW1 borough of kensington and chelsea title no ngl 336651.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 24. Jan. 1983Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 14. Jan. 1983
    Geliefert am 24. Jan. 1983
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H 10 sloane gardens, london SW1 borough of kensington and chelsea. Title no 336070.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 24. Jan. 1983Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 14. Jan. 1983
    Geliefert am 24. Jan. 1983
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H 57 sloane gardens london SW1 borough of kensington and chelsea. Title no ln 240905.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 24. Jan. 1983Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 14. Jan. 1983
    Geliefert am 24. Jan. 1983
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H 15, crescent lane, bath, avon title no av 46630.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 24. Jan. 1983Registrierung einer Belastung
    • 27. Nov. 1991Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 14. Jan. 1983
    Geliefert am 24. Jan. 1983
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H 15/16 royal crescent, bath, avon title no av 3332.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 24. Jan. 1983Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 23. Dez. 1982
    Geliefert am 06. Jan. 1983
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land & premises known as 13/14 royal crescent, bath avon.
    Berechtigte Personen
    • R.A. Jones
    • A.B.Jones
    • R.D.C. Jones,
    Transaktionen
    • 06. Jan. 1983Registrierung einer Belastung

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0