SIMONS ESTATES LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameSIMONS ESTATES LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01063126
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von SIMONS ESTATES LIMITED?

    • Bau von Geschäftsgebäuden (41201) / Bauwesen

    Wo befindet sich SIMONS ESTATES LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    C/O Frp Advisory Llp Ashcroft House Ervington Court
    Meridian Business Park
    LE19 1WL Leicester
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von SIMONS ESTATES LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    SIMONS DEVELOPMENTS LIMITED05. Juni 200005. Juni 2000
    SIMONS ESTATES LIMITED25. Juni 199025. Juni 1990
    SIMONS OF LINCOLN (ESTATES) LIMITED31. Dez. 197631. Dez. 1976
    SIMONS OF LINCOLN (DEVELOPMENTS) LIMITED27. Juli 197227. Juli 1972

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SIMONS ESTATES LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2018

    Welche sind die letzten Einreichungen für SIMONS ESTATES LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    20 SeitenLIQ14

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 28. Okt. 2021

    23 SeitenLIQ03

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 28. Okt. 2020

    24 SeitenLIQ03

    Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung

    4 SeitenNDISC

    Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O Simons Developments 991 Doddington Road Lincoln East Midlands LN6 3AA zum C/O Frp Advisory Llp Ashcroft House Ervington Court Meridian Business Park Leicester LE19 1WL am 12. Nov. 2019

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    3 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Außerordentlicher Beschluss zur Vergleichsverfahren am 29. Okt. 2019

    LRESEX

    Vermögensübersicht

    8 SeitenLIQ02

    Erfüllung der Belastung 28 vollständig

    1 SeitenMR04

    Bestätigungserklärung erstellt am 19. Okt. 2019 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Notification of a person with significant control statement

    2 SeitenPSC08

    Cessation of Paul Richard Hodgkinson as a person with significant control on 18. Okt. 2019

    1 SeitenPSC07

    Notification of Paul Richard Hodgkinson as a person with significant control on 03. Okt. 2019

    2 SeitenPSC01

    Beendigung der Bestellung von Michael Harrison Kasher als Geschäftsführer am 15. Aug. 2019

    1 SeitenTM01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Philip David Hodgkinson am 01. Okt. 2019

    2 SeitenCH01

    Cessation of Michael Harrison Kasher as a person with significant control on 15. Aug. 2019

    1 SeitenPSC07

    Bestätigungserklärung erstellt am 19. Okt. 2018 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2018

    3 SeitenAA

    Erfüllung der Belastung 010631260029 vollständig

    1 SeitenMR04

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2017

    3 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 20. Okt. 2017 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Das gesamte Eigentum oder Unternehmen wurde aus der Belastung entlassen 010631260029

    1 SeitenMR05

    Eintragung der Belastung 010631260029, erstellt am 13. Apr. 2017

    53 SeitenMR01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2016

    3 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von SIMONS ESTATES LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    PADGHAM, Michelle
    Ervington Court
    Meridian Business Park
    LE19 1WL Leicester
    C/O Frp Advisory Llp Ashcroft House
    Sekretär
    Ervington Court
    Meridian Business Park
    LE19 1WL Leicester
    C/O Frp Advisory Llp Ashcroft House
    152681100001
    HODGKINSON, Philip David
    Ervington Court
    Meridian Business Park
    LE19 1WL Leicester
    C/O Frp Advisory Llp Ashcroft House
    Geschäftsführer
    Ervington Court
    Meridian Business Park
    LE19 1WL Leicester
    C/O Frp Advisory Llp Ashcroft House
    EnglandBritish2850580001
    DIVER, Stephen Paul
    8 Riseholme Lane
    Riseholme
    LN2 2LD Lincoln
    Lincolnshire
    Sekretär
    8 Riseholme Lane
    Riseholme
    LN2 2LD Lincoln
    Lincolnshire
    British2850570001
    CONROY, Graham Leslie
    2 Ridge View
    Harmston
    LN1 3QW Lincoln
    Lincolnshire
    Geschäftsführer
    2 Ridge View
    Harmston
    LN1 3QW Lincoln
    Lincolnshire
    British74935030007
    CROSS, Paul Samuel
    Becketts Cottage
    36 Deenthorpe
    NN17 3EP Corby
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    Becketts Cottage
    36 Deenthorpe
    NN17 3EP Corby
    Northamptonshire
    British122403650001
    DIVER, Stephen Paul
    8 Riseholme Lane
    Riseholme
    LN2 2LD Lincoln
    Lincolnshire
    Geschäftsführer
    8 Riseholme Lane
    Riseholme
    LN2 2LD Lincoln
    Lincolnshire
    EnglandBritish2850570001
    HODGKINSON, Paul Richard
    Woodsford Square
    W14 8DT London
    119
    Geschäftsführer
    Woodsford Square
    W14 8DT London
    119
    EnglandBritish35550580004
    KASHER, Michael Harrison
    C/O Simons Developments
    991 Doddington Road
    LN6 3AA Lincoln
    East Midlands
    Geschäftsführer
    C/O Simons Developments
    991 Doddington Road
    LN6 3AA Lincoln
    East Midlands
    EnglandBritish140185150001
    KENDALL, Philip James
    Overbury 1 Kenderdine Close
    Bednall
    ST17 0YS Stafford
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    Overbury 1 Kenderdine Close
    Bednall
    ST17 0YS Stafford
    Staffordshire
    EnglandBritish58364160002
    O'CONNELL, Christian John
    C/O Simons Developments
    991 Doddington Road
    LN6 3AA Lincoln
    East Midlands
    Geschäftsführer
    C/O Simons Developments
    991 Doddington Road
    LN6 3AA Lincoln
    East Midlands
    EnglandBritish165195970001
    PICKERING, Anthony Luke
    Yew Trees Chapel Lane
    Hackthorne
    LN2 3PF Lincoln
    Geschäftsführer
    Yew Trees Chapel Lane
    Hackthorne
    LN2 3PF Lincoln
    EnglandBritish2850590001
    WALTER, Giles Mark
    Walk House Blackthorn Lane
    Cammeringham
    LN1 2SH Lincoln
    Lincolnshire
    Geschäftsführer
    Walk House Blackthorn Lane
    Cammeringham
    LN1 2SH Lincoln
    Lincolnshire
    EnglandBritish42034510001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei SIMONS ESTATES LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Mr Paul Richard Hodgkinson
    C/O Simons Developments
    991 Doddington Road
    LN6 3AA Lincoln
    East Midlands
    03. Okt. 2019
    C/O Simons Developments
    991 Doddington Road
    LN6 3AA Lincoln
    East Midlands
    Ja
    Nationalität: British
    Staatsangehörigkeit: England
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 25%, aber nicht mehr als 50% der Anteile an der Gesellschaft.
    Mr Michael Harrison Kasher
    C/O Simons Developments
    991 Doddington Road
    LN6 3AA Lincoln
    East Midlands
    04. Juli 2016
    C/O Simons Developments
    991 Doddington Road
    LN6 3AA Lincoln
    East Midlands
    Ja
    Nationalität: British
    Staatsangehörigkeit: England
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hat das Recht, wesentlichen Einfluss oder Kontrolle über das Unternehmen auszuüben oder übt diese tatsächlich aus.
    • Die Person hat das Recht, wesentlichen Einfluss oder Kontrolle über die Aktivitäten eines Trusts auszuüben oder übt diese tatsächlich aus, und die Treuhänder dieses Trusts (in ihrer Eigenschaft als solche) haben das Recht, wesentlichen Einfluss oder Kontrolle über das Unternehmen auszuüben oder üben diese tatsächlich aus.
    • Die Person hat das Recht, wesentlichen Einfluss oder Kontrolle über die Aktivitäten einer Firma auszuüben oder übt diese tatsächlich aus, die nach dem Recht, das sie regelt, keine juristische Person ist; und die Mitglieder dieser Firma (in ihrer Eigenschaft als solche) haben das Recht, wesentlichen Einfluss oder Kontrolle über das Unternehmen auszuüben oder üben diese tatsächlich aus.

    Wie lauten die letzten Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss für SIMONS ESTATES LIMITED?

    Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss
    Benachrichtigt amAufgehört amErklärung
    18. Okt. 2019Das Unternehmen weiß oder hat Grund zu der Annahme, dass es keine registrierungspflichtige Person oder registrierungspflichtige relevante juristische Person in Bezug auf das Unternehmen gibt.

    Hat SIMONS ESTATES LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 13. Apr. 2017
    Geliefert am 13. Apr. 2017
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    By way of first legal mortgage, all land (ad defined below) belonging to the company at the date of the debenture including without limitation that described in part 1 of schedule 2 to the debenture (a copy of which schedule is attached to this form MR01).. In the debenture "land" means all estates and other interests in freehold, leasehold or other immovable property (wherever situated) or in which the company has an interest and:-. (I) all buildings and fixtures (including trade fixtures but not including tenant's fixtures) and fixed plant and machinery at any time thereon;. (Ii) all easements, rights and agreements in respect of such property;. (Iii) all proceeds of sale of such property; and. (Iv) the benefit of all covenants given in respect of such property.
    Belastungsgrundlage als Bare Trust: Ja
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Bibby Financial Services (As Security Trustee)
    Transaktionen
    • 13. Apr. 2017Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 25. Aug. 2017Das gesamte Grundstück oder Unternehmen wurde von der Belastung freigegeben (MR05)
    • 27. März 2018Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Mortgage
    Erstellt am 28. Jan. 1999
    Geliefert am 11. Feb. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from aardvark developments limited to the chargee
    Kurze Angaben
    By way of first equitable charge all estates and other interests of the company in the property at ely central area cambridgeshire and the proceeds of sale. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. Feb. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Okt. 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Charge over shares
    Erstellt am 05. Apr. 1993
    Geliefert am 23. Apr. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a repayment agreement of even date the finance documents (as defined) and/or this charge
    Kurze Angaben
    All the ordinary shares of £1 each in louth estates limited which shares are registered in the name of the company free from all encumbrances all dividends or interest thereon paid or payable after the date hereof on the shares and all stocks shares (and the dividends or interest thereon). See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Uberior Nominees (Gulliver D.P.U.T.) Limited
    Transaktionen
    • 23. Apr. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Apr. 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 05. Apr. 1993
    Geliefert am 23. Apr. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a repayment agreement of even date the finance documents (as defined) and/or this charge
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 41-42 sadler street durham t/no du 146471.
    Berechtigte Personen
    • Uberior Nominees (Gulliver D.P.U.T.) Limited
    Transaktionen
    • 23. Apr. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Apr. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge over credit balances
    Erstellt am 26. Mai 1992
    Geliefert am 05. Juni 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever in relation to a guarantee dated 7TH august 1991 for £573,791.00 in favour of david cobham payne
    Kurze Angaben
    The sum of £573,791 together with interest accrued now or to be held by national westminster bank PLC on an account numbered 00943746 and earmarked or designated by reference to the company.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 05. Juni 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Apr. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge over credit balance
    Erstellt am 09. Apr. 1992
    Geliefert am 21. Apr. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever in relation to a guarantee dated 7 august 1991 for £1,520,000 in favour of david cobham payne
    Kurze Angaben
    The sum of £1,520,000 together with interest accrued now or to be held by the national westminster bank PLC on an account numbered 00943746 and earmarked or designated by reference to the company.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 21. Apr. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Apr. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge over credit balance
    Erstellt am 07. Aug. 1991
    Geliefert am 12. Aug. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever in relation to a guarantee for £1,385,144 dated 7/8/91 in favour of david cobham payne
    Kurze Angaben
    The sum of £1,385,144 together with interest accrued now or to be held by the bank on an account numbered 00943746 and earmarked or designated by reference to the company.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. Aug. 1991Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Apr. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 10. Juni 1988
    Geliefert am 16. Juni 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land fronting high street, firth road and ropewalk, lincoln. Title no. Ll 39687 and/or proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. Juni 1988Registrierung einer Belastung
    • 25. Apr. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Trust deed
    Erstellt am 02. Okt. 1987
    Geliefert am 20. Okt. 1987
    Vollständig erfüllt
    Berechtigte Personen
    • Raymond Ingram
    • Victor William Semmens
    Transaktionen
    • 20. Okt. 1987Registrierung einer Belastung
    Legal mortgage
    Erstellt am 02. Okt. 1987
    Geliefert am 20. Okt. 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/Hold parcel of land at the west lincoln trading estate doddington road,lincoln. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 20. Okt. 1987Registrierung einer Belastung
    Legal mortgage
    Erstellt am 10. Jan. 1985
    Geliefert am 16. Jan. 1985
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Part of site g park farm, wellingborough northamptonshire and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. Jan. 1985Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 30. Nov. 1984
    Geliefert am 19. Dez. 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an agreement dated 11-9-84
    Kurze Angaben
    F/H lands buildings k/a the golden lion public house, high street, worcester.
    Berechtigte Personen
    • Verdon Development Limited
    Transaktionen
    • 19. Dez. 1984Registrierung einer Belastung
    • 25. Apr. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 24. Nov. 1984
    Geliefert am 13. Dez. 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee not exceeding £100,000
    Kurze Angaben
    F/H premises k/a the golden lion public house, worcester and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Dez. 1984Registrierung einer Belastung
    • 25. Apr. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 30. Juli 1982
    Geliefert am 11. Aug. 1982
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/Hold land at aldwark bedern and st andrewgate york and the proceeds of sale thereof together with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. Aug. 1982Registrierung einer Belastung
    • 25. Apr. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 30. Juli 1982
    Geliefert am 11. Aug. 1982
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/Hold property known as land adjoining aldwark york & the proceeds of sale thereof together with a floating charge over all movable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. Aug. 1982Registrierung einer Belastung
    • 25. Apr. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 22. Juli 1982
    Geliefert am 03. Aug. 1982
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/Hold land and buildings at and adjoining auckland house, bishops auckland county durham, and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 03. Aug. 1982Registrierung einer Belastung
    Legal mortgage
    Erstellt am 14. Juli 1982
    Geliefert am 29. Juli 1982
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/Hold land on east side of station road skellingthorpe. Lincoln lincolnshire, and the proceeds of sale thereof title no:- ll 9558. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 29. Juli 1982Registrierung einer Belastung
    • 25. Apr. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 14. Juli 1982
    Geliefert am 29. Juli 1982
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/Hold land on south side of doddington road, skellingthorpe lincoln lincolnshire and the proceeds of sale thereof title no:- ll 7487. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 29. Juli 1982Registrierung einer Belastung
    • 25. Apr. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 14. Mai 1982
    Geliefert am 04. Juni 1982
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/Hold land and buildings adjoining auckland house, bishop auckland, durham. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 04. Juni 1982Registrierung einer Belastung
    Legal mortgage
    Erstellt am 10. Aug. 1981
    Geliefert am 20. Aug. 1981
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/Hold land buildings adjoining auckland house, bishop aukland. County durham.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 20. Aug. 1981Registrierung einer Belastung
    Legal mortgage
    Erstellt am 10. Aug. 1981
    Geliefert am 20. Aug. 1981
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/Hold auckland house, bishop auckland, county durham. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 20. Aug. 1981Registrierung einer Belastung
    Legal mortgage
    Erstellt am 03. März 1981
    Geliefert am 19. März 1981
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H 2,3,7,8 jubilee terrace ingham lincoln.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. März 1981Registrierung einer Belastung
    • 25. Apr. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 31. Mai 1978
    Geliefert am 07. Juni 1978
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property known as 37/39 market place, pontefract in the county of west yorks. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. Juni 1978Registrierung einer Belastung
    • 25. Apr. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 15. Nov. 1977
    Geliefert am 30. Nov. 1977
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property known as 203, monks road, lincoln.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 30. Nov. 1977Registrierung einer Belastung
    • 20. Juni 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 15. Nov. 1977
    Geliefert am 30. Nov. 1977
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property known as 2/10 jubilee terrace, high street, ingham.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 30. Nov. 1977Registrierung einer Belastung
    • 20. Juni 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat SIMONS ESTATES LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    29. Okt. 2019Beginn der Liquidation
    29. Juni 2022Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    John Anthony Lowe
    Ashcroft House Ervington Court
    Meridian Business Park
    LE19 1WL Leicester
    Leicestershire
    Praktiker
    Ashcroft House Ervington Court
    Meridian Business Park
    LE19 1WL Leicester
    Leicestershire
    Nathan Jones
    Ashcroft House Ervington Court
    Meridian Business Park
    LE19 1WL Leicester
    Leicestershire
    Praktiker
    Ashcroft House Ervington Court
    Meridian Business Park
    LE19 1WL Leicester
    Leicestershire

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0