SIMONS ESTATES LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | SIMONS ESTATES LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01063126 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von SIMONS ESTATES LIMITED?
- Bau von Geschäftsgebäuden (41201) / Bauwesen
Wo befindet sich SIMONS ESTATES LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | C/O Frp Advisory Llp Ashcroft House Ervington Court Meridian Business Park LE19 1WL Leicester |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von SIMONS ESTATES LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| SIMONS DEVELOPMENTS LIMITED | 05. Juni 2000 | 05. Juni 2000 |
| SIMONS ESTATES LIMITED | 25. Juni 1990 | 25. Juni 1990 |
| SIMONS OF LINCOLN (ESTATES) LIMITED | 31. Dez. 1976 | 31. Dez. 1976 |
| SIMONS OF LINCOLN (DEVELOPMENTS) LIMITED | 27. Juli 1972 | 27. Juli 1972 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SIMONS ESTATES LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2018 |
Welche sind die letzten Einreichungen für SIMONS ESTATES LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation | 20 Seiten | LIQ14 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 28. Okt. 2021 | 23 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 28. Okt. 2020 | 24 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung | 4 Seiten | NDISC | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O Simons Developments 991 Doddington Road Lincoln East Midlands LN6 3AA zum C/O Frp Advisory Llp Ashcroft House Ervington Court Meridian Business Park Leicester LE19 1WL am 12. Nov. 2019 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Vermögensübersicht | 8 Seiten | LIQ02 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 28 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 19. Okt. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Notification of a person with significant control statement | 2 Seiten | PSC08 | ||||||||||
Cessation of Paul Richard Hodgkinson as a person with significant control on 18. Okt. 2019 | 1 Seiten | PSC07 | ||||||||||
Notification of Paul Richard Hodgkinson as a person with significant control on 03. Okt. 2019 | 2 Seiten | PSC01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Michael Harrison Kasher als Geschäftsführer am 15. Aug. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Philip David Hodgkinson am 01. Okt. 2019 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Cessation of Michael Harrison Kasher as a person with significant control on 15. Aug. 2019 | 1 Seiten | PSC07 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 19. Okt. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2018 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 010631260029 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2017 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 20. Okt. 2017 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Das gesamte Eigentum oder Unternehmen wurde aus der Belastung entlassen 010631260029 | 1 Seiten | MR05 | ||||||||||
Eintragung der Belastung 010631260029, erstellt am 13. Apr. 2017 | 53 Seiten | MR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2016 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von SIMONS ESTATES LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PADGHAM, Michelle | Sekretär | Ervington Court Meridian Business Park LE19 1WL Leicester C/O Frp Advisory Llp Ashcroft House | 152681100001 | |||||||
| HODGKINSON, Philip David | Geschäftsführer | Ervington Court Meridian Business Park LE19 1WL Leicester C/O Frp Advisory Llp Ashcroft House | England | British | 2850580001 | |||||
| DIVER, Stephen Paul | Sekretär | 8 Riseholme Lane Riseholme LN2 2LD Lincoln Lincolnshire | British | 2850570001 | ||||||
| CONROY, Graham Leslie | Geschäftsführer | 2 Ridge View Harmston LN1 3QW Lincoln Lincolnshire | British | 74935030007 | ||||||
| CROSS, Paul Samuel | Geschäftsführer | Becketts Cottage 36 Deenthorpe NN17 3EP Corby Northamptonshire | British | 122403650001 | ||||||
| DIVER, Stephen Paul | Geschäftsführer | 8 Riseholme Lane Riseholme LN2 2LD Lincoln Lincolnshire | England | British | 2850570001 | |||||
| HODGKINSON, Paul Richard | Geschäftsführer | Woodsford Square W14 8DT London 119 | England | British | 35550580004 | |||||
| KASHER, Michael Harrison | Geschäftsführer | C/O Simons Developments 991 Doddington Road LN6 3AA Lincoln East Midlands | England | British | 140185150001 | |||||
| KENDALL, Philip James | Geschäftsführer | Overbury 1 Kenderdine Close Bednall ST17 0YS Stafford Staffordshire | England | British | 58364160002 | |||||
| O'CONNELL, Christian John | Geschäftsführer | C/O Simons Developments 991 Doddington Road LN6 3AA Lincoln East Midlands | England | British | 165195970001 | |||||
| PICKERING, Anthony Luke | Geschäftsführer | Yew Trees Chapel Lane Hackthorne LN2 3PF Lincoln | England | British | 2850590001 | |||||
| WALTER, Giles Mark | Geschäftsführer | Walk House Blackthorn Lane Cammeringham LN1 2SH Lincoln Lincolnshire | England | British | 42034510001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei SIMONS ESTATES LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört |
|---|---|---|---|
| Mr Paul Richard Hodgkinson | 03. Okt. 2019 | C/O Simons Developments 991 Doddington Road LN6 3AA Lincoln East Midlands | Ja |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: England | |||
Arten der Kontrolle
| |||
| Mr Michael Harrison Kasher | 04. Juli 2016 | C/O Simons Developments 991 Doddington Road LN6 3AA Lincoln East Midlands | Ja |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: England | |||
Arten der Kontrolle
| |||
Wie lauten die letzten Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss für SIMONS ESTATES LIMITED?
| Benachrichtigt am | Aufgehört am | Erklärung |
|---|---|---|
| 18. Okt. 2019 | Das Unternehmen weiß oder hat Grund zu der Annahme, dass es keine registrierungspflichtige Person oder registrierungspflichtige relevante juristische Person in Bezug auf das Unternehmen gibt. |
Hat SIMONS ESTATES LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 13. Apr. 2017 Geliefert am 13. Apr. 2017 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung By way of first legal mortgage, all land (ad defined below) belonging to the company at the date of the debenture including without limitation that described in part 1 of schedule 2 to the debenture (a copy of which schedule is attached to this form MR01).. In the debenture "land" means all estates and other interests in freehold, leasehold or other immovable property (wherever situated) or in which the company has an interest and:-. (I) all buildings and fixtures (including trade fixtures but not including tenant's fixtures) and fixed plant and machinery at any time thereon;. (Ii) all easements, rights and agreements in respect of such property;. (Iii) all proceeds of sale of such property; and. (Iv) the benefit of all covenants given in respect of such property. Belastungsgrundlage als Bare Trust: Ja Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 28. Jan. 1999 Geliefert am 11. Feb. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from aardvark developments limited to the chargee | |
Kurze Angaben By way of first equitable charge all estates and other interests of the company in the property at ely central area cambridgeshire and the proceeds of sale. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge over shares | Erstellt am 05. Apr. 1993 Geliefert am 23. Apr. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a repayment agreement of even date the finance documents (as defined) and/or this charge | |
Kurze Angaben All the ordinary shares of £1 each in louth estates limited which shares are registered in the name of the company free from all encumbrances all dividends or interest thereon paid or payable after the date hereof on the shares and all stocks shares (and the dividends or interest thereon). See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 05. Apr. 1993 Geliefert am 23. Apr. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a repayment agreement of even date the finance documents (as defined) and/or this charge | |
Kurze Angaben F/H property k/a 41-42 sadler street durham t/no du 146471. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge over credit balances | Erstellt am 26. Mai 1992 Geliefert am 05. Juni 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever in relation to a guarantee dated 7TH august 1991 for £573,791.00 in favour of david cobham payne | |
Kurze Angaben The sum of £573,791 together with interest accrued now or to be held by national westminster bank PLC on an account numbered 00943746 and earmarked or designated by reference to the company. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge over credit balance | Erstellt am 09. Apr. 1992 Geliefert am 21. Apr. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever in relation to a guarantee dated 7 august 1991 for £1,520,000 in favour of david cobham payne | |
Kurze Angaben The sum of £1,520,000 together with interest accrued now or to be held by the national westminster bank PLC on an account numbered 00943746 and earmarked or designated by reference to the company. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge over credit balance | Erstellt am 07. Aug. 1991 Geliefert am 12. Aug. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever in relation to a guarantee for £1,385,144 dated 7/8/91 in favour of david cobham payne | |
Kurze Angaben The sum of £1,385,144 together with interest accrued now or to be held by the bank on an account numbered 00943746 and earmarked or designated by reference to the company. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 10. Juni 1988 Geliefert am 16. Juni 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land fronting high street, firth road and ropewalk, lincoln. Title no. Ll 39687 and/or proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Trust deed | Erstellt am 02. Okt. 1987 Geliefert am 20. Okt. 1987 | Vollständig erfüllt | ||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 02. Okt. 1987 Geliefert am 20. Okt. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/Hold parcel of land at the west lincoln trading estate doddington road,lincoln. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 10. Jan. 1985 Geliefert am 16. Jan. 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Part of site g park farm, wellingborough northamptonshire and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 30. Nov. 1984 Geliefert am 19. Dez. 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an agreement dated 11-9-84 | |
Kurze Angaben F/H lands buildings k/a the golden lion public house, high street, worcester. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 24. Nov. 1984 Geliefert am 13. Dez. 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee not exceeding £100,000 | |
Kurze Angaben F/H premises k/a the golden lion public house, worcester and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 30. Juli 1982 Geliefert am 11. Aug. 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/Hold land at aldwark bedern and st andrewgate york and the proceeds of sale thereof together with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 30. Juli 1982 Geliefert am 11. Aug. 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/Hold property known as land adjoining aldwark york & the proceeds of sale thereof together with a floating charge over all movable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 22. Juli 1982 Geliefert am 03. Aug. 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/Hold land and buildings at and adjoining auckland house, bishops auckland county durham, and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 14. Juli 1982 Geliefert am 29. Juli 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/Hold land on east side of station road skellingthorpe. Lincoln lincolnshire, and the proceeds of sale thereof title no:- ll 9558. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 14. Juli 1982 Geliefert am 29. Juli 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/Hold land on south side of doddington road, skellingthorpe lincoln lincolnshire and the proceeds of sale thereof title no:- ll 7487. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 14. Mai 1982 Geliefert am 04. Juni 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/Hold land and buildings adjoining auckland house, bishop auckland, durham. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 10. Aug. 1981 Geliefert am 20. Aug. 1981 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/Hold land buildings adjoining auckland house, bishop aukland. County durham.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 10. Aug. 1981 Geliefert am 20. Aug. 1981 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/Hold auckland house, bishop auckland, county durham. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 03. März 1981 Geliefert am 19. März 1981 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H 2,3,7,8 jubilee terrace ingham lincoln. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 31. Mai 1978 Geliefert am 07. Juni 1978 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property known as 37/39 market place, pontefract in the county of west yorks. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 15. Nov. 1977 Geliefert am 30. Nov. 1977 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property known as 203, monks road, lincoln.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 15. Nov. 1977 Geliefert am 30. Nov. 1977 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property known as 2/10 jubilee terrace, high street, ingham.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat SIMONS ESTATES LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gläubiger-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0