DMI (UK) LIMITED
Überblick
Unternehmensname | DMI (UK) LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 01068349 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von DMI (UK) LIMITED?
- Behandlung und Beschichtung von Metallen (25610) / Verarbeitendes Gewerbe
Wo befindet sich DMI (UK) LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 1 St James Gate NE1 4AD Newcastle Upon Tyne |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von DMI (UK) LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
DIESEL MARINE INTERNATIONAL LIMITED | 08. März 1982 | 08. März 1982 |
GODFREY STREET INVESTMENTS LIMITED | 29. Aug. 1972 | 29. Aug. 1972 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von DMI (UK) LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2012 |
Welche sind die letzten Einreichungen für DMI (UK) LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation | 16 Seiten | LIQ14 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 30. Juni 2018 | 16 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 30. Juni 2017 | 18 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 30. Juni 2016 | 14 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Insolvenzgerichtsbeschluss Court order insolvency:c/o replacement of liquidator | 17 Seiten | LIQ MISC OC | ||||||||||
Hinweis auf die Einstellung der Tätigkeit als freiwilliger Liquidator | 1 Seiten | 4.40 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 07. Mai 2015 | 18 Seiten | 2.24B | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 01. Juli 2015 | 17 Seiten | 2.24B | ||||||||||
Mitteilung über den Übergang vom Verwaltungsfall zur freiwilligen Liquidation der Gläubiger | 1 Seiten | 2.34B | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Tenon House Ferryboat Lane Sunderland SR5 3JN zum 1 St James Gate Newcastle upon Tyne NE1 4AD am 11. Feb. 2015 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 07. Nov. 2014 | 20 Seiten | 2.24B | ||||||||||
Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung | 1 Seiten | 2.31B | ||||||||||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 07. Juli 2014 | 15 Seiten | 2.24B | ||||||||||
Vorschlag des Verwalters | 28 Seiten | 2.17B | ||||||||||
Vermögensübersicht mit Formular 2.14B | 9 Seiten | 2.16B | ||||||||||
Ernennung eines Verwalters | 1 Seiten | 2.12B | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * Gloucester Road West Chirton Industrial Estate North Shields Tyne & Wear NE29 8RQ* am 22. Jan. 2014 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Eintragung der Belastung 010683490014 | 27 Seiten | MR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 16. Sept. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 16. Sept. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von DMI (UK) LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAY, Alan Leslie | Sekretär | 19 Highfield Court NE10 9LH Gateshead Tyne & Wear | British | Accountant | 82507700001 | |||||
JACKSON, Peter Lindsey | Geschäftsführer | Darlaston Lodge Jervis Lane Meaford ST15 0PZ Stone Staffordshire | United Kingdom | British | Director | 21945440001 | ||||
WOODMANSEY, Richard Kevin | Geschäftsführer | Chanterlands Avenue (North) HU5 4BL Kingston Upon Hull 456 England | England | British | None | 160957070001 | ||||
JACKSON, Peter Lindsey | Sekretär | Darlaston Lodge Jervis Lane Meaford ST15 0PZ Stone Staffordshire | British | Director | 21945440001 | |||||
KIRKHAM, John Richard | Sekretär | 13 Raynham Close NE23 7XD Cramlington Northumberland | British | 10658750001 | ||||||
LINFOOT, Richard John | Sekretär | 11 Wolsingham Road Gosforth NE3 4RP Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | British | Accountant | 87970720001 | |||||
SCOTT, Stephen Michael | Sekretär | 21 Woolsington Gardens Woolsington NE13 8AP Newcastle Upon Tyne | British | Accountant | 38587580002 | |||||
BATIE, David Alwyn | Geschäftsführer | 25 Apperley Road Midway NE23 7XD Stocksfield Northumberland | British | Sales And Marketing Director | 39463180001 | |||||
BRIGHTMORE, Eric Arthur | Geschäftsführer | 6 Kilburn Road Dronfield Woodhouse S18 5QA Sheffield South Yorkshire | England | British | Managing Director | 1435570001 | ||||
DAVIDSON, Kevin Smythe | Geschäftsführer | 51 Percy Gardens Tynemouth NE30 4HH North Shields Tyne & Wear | British | Engineer | 17572390001 | |||||
DE VRIES, Menno Eelco Gerrit | Geschäftsführer | Burgemmeester Malcoplaslaan 81 8061AJ Hasselt Holland | Dutch | Engineer | 40354650001 | |||||
HENNON, Michael | Geschäftsführer | 136 Elmway DH2 2LQ Chester Le Street County Durham | England | British | Director | 14254450001 | ||||
KIRKHAM, John Richard | Geschäftsführer | 13 Raynham Close NE23 7XD Cramlington Northumberland | British | Accountant | 10658750001 | |||||
LINFOOT, Richard John | Geschäftsführer | 11 Wolsingham Road Gosforth NE3 4RP Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | England | British | Accountant | 87970720001 | ||||
ODD, Humphrey Richard | Geschäftsführer | Anick Farm Anick NE46 4LN Hexham Northumberland | British | Accountant | 1656860001 | |||||
SCOTT, Stephen Michael | Geschäftsführer | 21 Woolsington Gardens Woolsington NE13 8AP Newcastle Upon Tyne | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 38587580002 | ||||
TORDAY, Paul Lazslo | Geschäftsführer | Chipchase Castle Wark NE48 3NT Hexham Northumberland | United Kingdom | British | Director | 86896540001 | ||||
VAN DER HULST, Menno | Geschäftsführer | Heggerweg 8 Vaassen 8171 Pl Holland | Dutch | Engineer | 50749420001 |
Hat DMI (UK) LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Erstellt am 02. Dez. 2013 Geliefert am 13. Dez. 2013 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung Notification of addition to or amendment of charge. Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 23. März 2005 Geliefert am 12. Apr. 2005 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 23. März 2005 Geliefert am 08. Apr. 2005 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H land and buildings at gloucester road west chirton industrial estate north shields t/no TY229286. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge which was registered pursuant to an order of court dated 15TH january 2002 | Erstellt am 29. Okt. 2001 Geliefert am 24. Jan. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben By way of legal mortgage the f/h property k/a land and buildings at gloucester road west clirton industrial estate north shields t/n TY229286 in the county of durham. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Guarantee and debenture which was registered pursuant to an order of court dated 15TH january 2002 | Erstellt am 29. Okt. 2001 Geliefert am 24. Jan. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or any of the other companies to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 29. Aug. 2001 Geliefert am 05. Sept. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Guarantee & debenture | Erstellt am 08. Aug. 2001 Geliefert am 17. Aug. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Chattel mortgage | Erstellt am 02. Feb. 1996 Geliefert am 07. Feb. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £123,000.00 and all other monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben Mostana model 1516 cnc vertical borer with num 1060-t series 2 control with 14" colour screen and 128K memory capacity serial no. 2672. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage | Erstellt am 11. Juli 1995 Geliefert am 24. Juli 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 3001 shares of 1000 dutch guilders each in the share capital of dmi (europe) bv registered in the name of the company. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 27. Mai 1994 Geliefert am 02. Juni 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a land at gloucester road, north sheilds, tyne and wear together with all buildings thereon t/no. TY229286. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 08. März 1993 Geliefert am 24. März 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben South works, whapload road, lowestoft, suffolk t/no. SK83867. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 02. Okt. 1989 Geliefert am 10. Okt. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land at west chirton industrial estate north shields tyne and wear. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 30. Jan. 1986 Geliefert am 06. Feb. 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage debenture | Erstellt am 28. Jan. 1980 Geliefert am 01. Feb. 1980 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed & floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including, goodwill, book-debts uncalled capital, all stocks shares & other securities. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Hat DMI (UK) LIMITED Insolvenzverfahren?
Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| In Verwaltung |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
| Gläubiger-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0