F J JONES HOLDINGS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | F J JONES HOLDINGS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01071339 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von F J JONES HOLDINGS LIMITED?
- Installation von Sanitär-, Heizungs- und Klimaanlagen (43220) / Bauwesen
Wo befindet sich F J JONES HOLDINGS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Unit 1 Yardley Business Park Luckyn Lane SS14 3BZ Basildon Essex England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von F J JONES HOLDINGS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| F.J. JONES HEATING ENGINEERS LIMITED | 12. Sept. 1972 | 12. Sept. 1972 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von F J JONES HOLDINGS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Sept. 2019 |
Welche sind die letzten Einreichungen für F J JONES HOLDINGS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. März 2021 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Peter David Mawby Smith am 13. Okt. 2020 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 28. Sept. 2020
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Change of details for Sure Maintenance Group Limited as a person with significant control on 13. Apr. 2020 | 2 Seiten | PSC05 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. März 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Patrick Joseph Coleman als Direktor am 10. März 2020 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2019 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Paul Stephen Cornes als Geschäftsführer am 30. Sept. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr John William Charles Charlton als Direktor am 01. Okt. 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Michael Mcmahon als Geschäftsführer am 30. Sept. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Peter David Mawby Smith als Direktor am 01. Okt. 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2018 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom St James House C/O Bpe Solicitors Llp, First Floor St James Square Cheltenham Gloucestershire GL50 3PR United Kingdom zum Unit 1 Yardley Business Park Luckyn Lane Basildon Essex SS14 3BZ am 18. Mai 2019 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. März 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 8 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 9 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 12 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 13 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Jeremy John Cobbett Simpson als Geschäftsführer am 15. Okt. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von F J JONES HOLDINGS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHARLTON, John William Charles | Sekretär | Yardley Business Park Luckyn Lane SS14 3BZ Basildon Unit 1 Essex England | 230723900001 | |||||||
| CHARLTON, John William Charles | Geschäftsführer | Yardley Business Park Luckyn Lane SS14 3BZ Basildon Unit 1 Essex England | England | British | 119598150002 | |||||
| COLEMAN, Patrick Joseph | Geschäftsführer | Yardley Business Park Luckyn Lane SS14 3BZ Basildon Unit 1 Essex England | England | British | 259978320001 | |||||
| SMITH, Peter David Mawby | Geschäftsführer | Yardley Business Park Luckyn Lane SS14 3BZ Basildon Unit 1 Essex England | England | British | 159286600004 | |||||
| HAYES, Chris | Sekretär | Windsor Road PR9 9DB Southport 49 Merseyside Uk | British | 135198810001 | ||||||
| HOWELL, Simon John | Sekretär | King George Close RM7 7LS Romford 1 Essex United Kingdom | 202440420001 | |||||||
| JONES, Brenda Joyce | Sekretär | 46 George Road Oldbury B68 9LH Warley West Midlands | British | 11021500001 | ||||||
| JONES, Mark Andrew | Sekretär | 13 Rutters Lane Hazel Grove SK7 5AY Stockport Cheshire | British | 122429790001 | ||||||
| JONES, Pamela | Sekretär | 5 St Ambrose Close Gortsey Hill B65 OLB Halesowen West Midlands | British | 85590550001 | ||||||
| JONES, Richard Stephen | Sekretär | 5 Saint Ambrose Close B65 0LB Halesowen West Midlands | British | 62414980004 | ||||||
| KERRY, Simon | Sekretär | Steel Park Road B62 8HD Halesowen 4 St Kenelm Court West Midlands | British | 148019090001 | ||||||
| LLEWELYN, Mark Stephen | Sekretär | 21 High Street Tutbury DE13 9LS Burton-On-Trent Robinia House Staffordshire | British | 138069500001 | ||||||
| SILK, Frances | Sekretär | Hatherton House The Old Rectory WS15 3NL Admaston Staffordshire | British | 94515450002 | ||||||
| BIRRANE, Sean Thomas | Geschäftsführer | King George Close RM7 7LS Romford 1 Essex United Kingdom | England | British | 101296120004 | |||||
| BLACK, Stuart John | Geschäftsführer | King George Close RM7 7LS Romford 1 Essex United Kingdom | United Kingdom | British | 49053310001 | |||||
| CHIVERS, Steven | Geschäftsführer | 16 Oakleigh Road Oldswinford DY8 2JX Stourbridge West Midlands | England | British | 11021510001 | |||||
| CORNES, Paul Stephen | Geschäftsführer | Mayfield Avenue WA8 8PW Widnes 70 Cheshire England | England | British | 155586570002 | |||||
| CUNNINGHAM, Darren | Geschäftsführer | King George Close RM7 7LS Romford 1 Essex United Kingdom | United Kingdom | British | 66265530004 | |||||
| JONES, Mark Andrew | Geschäftsführer | 13 Rutters Lane Hazel Grove SK7 5AY Stockport Cheshire | United Kingdom | British | 122429790001 | |||||
| JONES, Richard Stephen | Geschäftsführer | 5 Saint Ambrose Close B65 0LB Halesowen West Midlands | United Kingdom | British | 62414980004 | |||||
| KERRY, Simon | Geschäftsführer | Steel Park Road B62 8HD Halesowen 4 St Kenelm Court West Midlands | England | British | 147820500001 | |||||
| LLEWELYN, Mark Stephen | Geschäftsführer | 21 High Street Tutbury DE13 9LS Burton-On-Trent Robinia House Staffordshire | British | 138069500001 | ||||||
| MCMAHON, Michael | Geschäftsführer | Yardley Business Park Luckyn Lane SS14 3BZ Basildon Unit 1 Essex England | United Kingdom | British | 173928090001 | |||||
| SHAH, Bharat Chimanlal | Geschäftsführer | 45 Dene Road HA6 2DD Northwood Middlesex | United Kingdom | British | 92761250002 | |||||
| SILK, Frances | Geschäftsführer | Hatherton House The Old Rectory WS15 3NL Admaston Staffordshire | England | British | 94515450002 | |||||
| SIMPSON, Jeremy John Cobbett | Geschäftsführer | King George Close RM7 7LS Romford 1 Essex United Kingdom | United Kingdom | British | 187009310001 | |||||
| VIITIKKO, Heikki Kalevi | Geschäftsführer | 4 Aynsley Court WA9 5GE St. Helens | Finnish | 72705340002 | ||||||
| WINKS, Nicholas Paul David | Geschäftsführer | Speke Road Garston L19 2RF Liverpool The West Wing The Matchworks | United Kingdom | British | 151282040001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei F J JONES HOLDINGS LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sure Maintenance Group Limited | 30. Juni 2016 | Yardley Business Park Luckyn Lane SS14 3BZ Basildon Unit 1 Essex England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat F J JONES HOLDINGS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 29. Feb. 2012 Geliefert am 14. März 2012 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental debenture | Erstellt am 18. März 2010 Geliefert am 25. März 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the noteholders or any of them or the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Under the terms of the supplemental debenture, the new loan notes are deemed to form part of the A1 loan notes. The debenture shall remain in full force and effect. See image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 21. Mai 2009 Geliefert am 03. Juni 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the noteholders (or any of them) or the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Omnibus guarantee and set-off agreement | Erstellt am 21. Mai 2009 Geliefert am 02. Juni 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sums or sums standing to the credit of any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 07. Dez. 2005 Geliefert am 21. Dez. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| An omnibus guarantee and set-off agreement | Erstellt am 07. Dez. 2005 Geliefert am 21. Dez. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sums or sums standing to the credit if any one or more of any present of future accounts of the companies or any of them with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 15. Mai 1992 Geliefert am 16. Mai 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £80,000 due from the company to the chargee together with further advances | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage deed | Erstellt am 15. Mai 1992 Geliefert am 16. Mai 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H 9/10 yates lane, halesowen, west midlands. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 30. März 1990 Geliefert am 05. Apr. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H premises k/a 9/10 yates lane halesowen west midlands. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 25. Feb. 1983 Geliefert am 02. März 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including goodwill, book debts. Uncalled capital, all buildings, fixtures, fixed plant & machinery all stocks, shares & other securities. Premises at 30 & 32 gorsty hill road, rowley regis, warley W. midlands. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 14. Juni 1974 Geliefert am 18. Juni 1974 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 32, gorsty hill rd halesowen worcestershire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 14. Juni 1974 Geliefert am 18. Juni 1974 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 30 gorsty hill rd halesowen worcestershire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 19. Dez. 1973 Geliefert am 27. Dez. 1973 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 30 gorsty hill road halesowen worcs. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0