WINERITE LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | WINERITE LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01072003 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von WINERITE LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich WINERITE LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | P & H House Davigdor Road BN3 1RE Hove East Sussex |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von WINERITE LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 08. Apr. 2017 |
Welche sind die letzten Einreichungen für WINERITE LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 08. Apr. 2017 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Nov. 2017 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Jonathan David Moxon als Geschäftsführer am 31. Mai 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Martyn Ronald Ward als Direktor am 31. Mai 2017 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Christopher Etherington als Geschäftsführer am 13. Apr. 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Anthony William Reed als Direktor am 07. Apr. 2017 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Nov. 2016 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 02. Apr. 2016 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Nov. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 04. Apr. 2015 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Nov. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 05. Apr. 2014 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Nov. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Jonathan David Moxon am 12. Nov. 2013 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 06. Apr. 2013 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 12 vollständig | 3 Seiten | MR04 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Nov. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 07. Apr. 2012 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr David Scudder als Sekretär | 1 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Andrew Mckelvie als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Nov. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 02. Apr. 2011 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von WINERITE LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCUDDER, David | Sekretär | P & H House Davigdor Road BN3 1RE Hove East Sussex | 165202150001 | |||||||
| REED, Anthony William | Geschäftsführer | P & H House Davigdor Road BN3 1RE Hove East Sussex | England | British | 228995600001 | |||||
| WARD, Martyn Ronald | Geschäftsführer | P & H House Davigdor Road BN3 1RE Hove East Sussex | England | British | 232918140001 | |||||
| COOPER, Colin Thompson | Sekretär | 7 Glendale Road RH15 0EJ Burgess Hill West Sussex | British | 127536180001 | ||||||
| MAHONEY, Anthony Denis | Sekretär | 65 Stainburn Drive LS17 6LZ Leeds West Yorkshire | British | 4042880001 | ||||||
| MCKELVIE, Andrew Laurence | Sekretär | 110 Osborne Road BN1 6LU Brighton East Sussex | British | 60126680002 | ||||||
| MURPHY, Luke | Sekretär | Pine Tree Cottage Field Lane, Wistow YO8 3XD Selby | British | 117303130001 | ||||||
| TOMLINSON, Paula Jane | Sekretär | 3 Springfield Close Bolney RH17 5PQ Haywards Heath West Sussex | British | 5904620004 | ||||||
| ADAMS, Christopher Borlase | Geschäftsführer | Belmont House East Hoathly BN8 6QJ Lewes East Sussex | United Kingdom | British | 32132270001 | |||||
| ATKINSON, Angela Mary | Geschäftsführer | 61 Main Street Thorner LS14 3BU Leeds West Yorkshire | British | 4226490001 | ||||||
| ATKINSON, Gerald | Geschäftsführer | 61 Main Street Thorner LS14 3BU Leeds West Yorkshire | British | 4042890001 | ||||||
| BELL, Graham | Geschäftsführer | 52 Westgate LS22 6NJ Wetherby West Yorkshire | British | 63749090001 | ||||||
| BELL, Maurice | Geschäftsführer | Barbondale Mill Lane Bardsey LS17 9AN Leeds | British | 63114430001 | ||||||
| CLARKE, Peter Lovat | Geschäftsführer | Brook House Cann Lane South Appleton WA4 5NJ Warrington Cheshire | United Kingdom | British | 4770530001 | |||||
| ETHERINGTON, Christopher | Geschäftsführer | P & H House Davigdor Road BN3 1RE Hove East Sussex | United Kingdom | British | 113997090003 | |||||
| GREEN, Jack | Geschäftsführer | Alston 9 Farnham Lane Ferrensby HG5 9JG Knaresborough North Yorkshire | United Kingdom | British | 71549080001 | |||||
| GREENWAY, Jason | Geschäftsführer | 73 Imperial Road Marsh HD1 4PG Huddersfield West Yorkshire | British | 116954560001 | ||||||
| HASTINGS, John Arthur | Geschäftsführer | 1a Hill End Road LS12 3PT Leeds Yorkshire | British | 49513880001 | ||||||
| LITTLE, Christopher William | Geschäftsführer | 7 Hoewood Mill Glade Small Dole BN5 9YR Henfield West Sussex | British | 52244990001 | ||||||
| MCPHERSON, Graham Scott | Geschäftsführer | Kingston Barn Kingston Lane BN16 1RP East Preston West Sussex | British | 48929130002 | ||||||
| MOXON, Jonathan David | Geschäftsführer | P & H House Davigdor Road BN3 1RE Hove East Sussex | England | British | 68503410002 | |||||
| MURPHY, Luke | Geschäftsführer | Pine Tree Cottage Field Lane, Wistow YO8 3XD Selby | British | 117303130001 | ||||||
| RIALL, Katharine Elizabeth | Geschäftsführer | Orchard Barn Main Street East Keswick LS17 9EU Leeds West Yorkshire | British | 61070770002 | ||||||
| SIMONS, John Trevor | Geschäftsführer | 5 Cedar Drive LS24 9TJ Tadcaster North Yorkshire | British | 63749250001 | ||||||
| STEVENS, Rodney Hugh Webster | Geschäftsführer | Woodley House 78 Alwoodley Lane LS17 7PT Leeds West Yorkshire | British | 51294160002 | ||||||
| WADE, Derek James | Geschäftsführer | Mottram Moor Farm Mottram Moor Hollingworth SK14 8LZ Hyde Cheshire | British | 46623620001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei WINERITE LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palmer & Harvey Mclane Limited | 06. Apr. 2016 | Davigdor Road BN3 1RE Hove P&H House England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat WINERITE LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Receivables accession deed | Erstellt am 04. Apr. 2008 Geliefert am 10. Apr. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each present or future obligor to the chargee and/or any the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Floating charge | Erstellt am 07. Feb. 2002 Geliefert am 21. Feb. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All money or liabilities due or to become due from any charging company to the chargee as security trustee for itself and the other secured parties (as defined) (the "security agent") on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of floating charge all its present and future assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 07. Feb. 2002 Geliefert am 13. Feb. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company (the "chargor") or any member of the group to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 16. Sept. 1999 Geliefert am 01. Okt. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land and buildings on the north side of stanningley road, bramley, west yorkshire t/no: ywe 53360. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 16. Sept. 1999 Geliefert am 30. Sept. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/Hold property being land lying to the north west of gelderd rd,new wortley,leeds,west yorkshire; f/hold property known as land/blds lying on north west side of gelderd rd,leeds,west yorkshire and few other properties listed; t/nos WYK205980,WYK462157,WYK263142,WYK283052,WYK385278,WYK200329. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 16. Sept. 1999 Geliefert am 29. Sept. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 12. Jan. 1990 Geliefert am 22. Jan. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from winerite limited and or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever. | |
Kurze Angaben 3.316 acres of f/h land & buildings at gelderd road, leeds LS12 floating charge over all movable plant fixtures & fittings machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 05. Sept. 1986 Geliefert am 08. Sept. 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All momies due or to become due from the company and/or all of the other companies named therein to craven supply limited on any account whatsoever. | |
Kurze Angaben L/Hold land at gelderd road. Leeds west yorkshire and all buildings erected thereon, including all fixtures and fittings (other than trade fixtures and fittings) plant and machinery.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed | Erstellt am 08. Okt. 1984 Geliefert am 17. Okt. 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or travrose limited and/or liquor leaders limited to the chargee supplemental to a debenture dated 3RD dec 1973 | |
Kurze Angaben 1) f/hold & l/hold property and the fixed plant, machinery trade & other fixtures. 2) all book debts & other debts present & future. 3) goodwill & uncalled capital present & future. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 18. Apr. 1980 Geliefert am 24. Apr. 1980 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to be come due from the company to the chargee and/or liquor leaders limited and/or travose limited on any account whatsoever. | |
Kurze Angaben Freehold and leasehold property geldard road and whiteley road new wortley leeds west yorkshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 06. Juni 1974 Geliefert am 14. Juni 1974 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land at bramley in the city of leeds title ywe 53360. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 03. Dez. 1973 Geliefert am 10. Dez. 1973 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Undertaking and all property and assets present and future inculding goodwill uncalled capital. By way of a floating charge (see doc 19). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0