REDSKY IT (593) LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | REDSKY IT (593) LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01082593 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von REDSKY IT (593) LIMITED?
- (7499) /
Wo befindet sich REDSKY IT (593) LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 55 Colmore Row Birmingham B3 2AS West Midlands |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von REDSKY IT (593) LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| RAMESYS (AEC) LIMITED | 06. Juni 2000 | 06. Juni 2000 |
| SYNTECH (UK) LIMITED | 06. Feb. 1997 | 06. Feb. 1997 |
| SYNTECH COMPUTER SYSTEMS LIMITED | 02. Juni 1987 | 02. Juni 1987 |
| SOKENWICK LIMITED | 20. Nov. 1972 | 20. Nov. 1972 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von REDSKY IT (593) LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Juli 2007 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für REDSKY IT (593) LIMITED?
| Jahresabschluss |
|
|---|
Welche sind die letzten Einreichungen für REDSKY IT (593) LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | GAZ2 | |||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 3 Seiten | 4.71 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 20. Feb. 2014 | 5 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 20. Aug. 2013 | 5 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 20. Feb. 2013 | 5 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 20. Aug. 2012 | 5 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 20. Feb. 2012 | 5 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 20. Aug. 2011 | 5 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 20. Feb. 2011 | 5 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 20. Aug. 2010 | 5 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 20. Feb. 2010 | 5 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 20. Aug. 2009 | 5 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 20. Feb. 2009 | 5 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Juli 2007 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 2 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 6 Seiten | 363s | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von REDSKY IT (593) LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HENWOOD, Julian Richard | Sekretär | 8 Brickyard Close CV7 7EN Balsall Common Warwickshire | British | 65188860002 | ||||||
| MCFARLANE, James Douglas | Geschäftsführer | 730 Eyremount Drive West Vancouver Bc V76 2a4 Canada | Canada | Canadian | 118810110001 | |||||
| COAKLEY, Calvin Lloyd | Sekretär | 44 Pentwyn Radyr CF15 8RE Cardiff | British | 19312940002 | ||||||
| COSTER, Malcolm David | Sekretär | Rivendell 46 Golfside South Cheam SM2 7EZ Sutton Surrey | British | 39034110001 | ||||||
| COTTRELL, Paul Alan | Sekretär | 16 Goldcrest Drive TN22 5QG Uckfield East Sussex | British | 13754300002 | ||||||
| DURRANT, Zoe Vivienne | Sekretär | Beehive Cottage Radford Road, Rous Lench WR11 4UL Evesham Worcestershire | British | 68141090001 | ||||||
| ELMS, Leighton William | Sekretär | 42 Porset Drive CF8 1PP Caerphilly Mid Glamorgan | British | 13309540001 | ||||||
| BARNHOUSE, Terence | Geschäftsführer | 2 St Medard Road BS28 4AY Wedmore Somerset | British | 48228710001 | ||||||
| BASHFORD, Howard | Geschäftsführer | Grovelands 22 Station Road Cholsey OX10 9PT Wallingford Oxfordshire | British | 68140690003 | ||||||
| BRADLEY, Michael John | Geschäftsführer | Vantage Point 208 Henwick Road WR2 5PF Worcester | British | 40818740003 | ||||||
| BRIDDON, Kenneth Carl | Geschäftsführer | Rose Farmhouse Village Road Waverton CH3 7QN Chester Cheshire | British | 76868400001 | ||||||
| CHAMBERS, Mark | Geschäftsführer | 428 Goldington Road MK41 9NU Bedford Bedfordshire | British | 78433770004 | ||||||
| COSTER, Malcolm David | Geschäftsführer | Rivendell 46 Golfside South Cheam SM2 7EZ Sutton Surrey | England | British | 39034110001 | |||||
| EARLEY, Martin John Raymond | Geschäftsführer | 36 Briarmeadow Drive Thornhill CF4 9FB Cardiff South Glamorgan | British | 19312960001 | ||||||
| FULLER, Andrew Jonathan | Geschäftsführer | Woodland Park Whalley BB7 9UG Lancashire 28 | British | 132077340001 | ||||||
| GRAHAM, Ross King | Geschäftsführer | Stourton Farm House Stourton CV36 5HG Shipston On Stour Warwickshire | United Kingdom | British | 61733920001 | |||||
| HOTSON, Crispian John | Geschäftsführer | 1b King Street SW1Y 6QG London | British | 97996100001 | ||||||
| JONES, Warren | Geschäftsführer | 8 Bishops Close Whitchurch CF4 1NH Cardiff | British | 59711890002 | ||||||
| LOCKYER, Stephen Charles | Geschäftsführer | 13 Summerwood Close CF5 3QS Cardiff South Glamorgan | British | 67414890001 | ||||||
| LOMAX, John Kevin | Geschäftsführer | Hawling Manor Hawling GL54 5TA Cheltenham Gloucestershire | British | 22190280002 | ||||||
| MATTHEW, Gordon John | Geschäftsführer | Rogers Lane Ettrington CV37 3TA Stratford Upon Avon Saracens Yard Warwickshire | England | British | 151547160001 | |||||
| MCPHERSON, Ian | Geschäftsführer | Whitebrook NP6 3BA Llanvaches Chepstow | British | 47733900001 | ||||||
| MORGAN, Patrick Francis | Geschäftsführer | 4 Church Bank Whaley Lane Whaley Bridge High Peak SK23 7RZ Stockport Cheshire | British | 37486070003 | ||||||
| NORFORD, Craig | Geschäftsführer | 167 Paddick Drive Earley RG6 4HG Reading Berkshire | British | 78433720002 | ||||||
| O'LEARY, Michael Kevin | Geschäftsführer | Greenwood Wichenford WR6 6YB Worcester Worcestershire | England | British | 129193560001 | |||||
| PEEK, David Richard | Geschäftsführer | Nant Y Deri Began Road Michaelston Y Fedw CF3 6XL Cardiff | British | 32453010001 | ||||||
| ROGERS, Christine Margaret | Geschäftsführer | Ty Cudyll Pen Y Waun, Pentyrch CF15 9SJ Cardiff South Glamorgan | British | 66374680001 | ||||||
| SMITH, David Anthony Bradford | Geschäftsführer | 7 Langland Villas Mumbles SA3 4NA Swansea West Glamorgan | British | 13309590001 | ||||||
| SMITH, Dennis George, Dr | Geschäftsführer | 10 St Quentins Close Llanblethian CF7 7EZ Cowbridge South Glamorgan | British | 37732060001 | ||||||
| SPRING, Simon Christopher | Geschäftsführer | 1 Chestnut Close Middle Assendon RG9 6AY Henley On Thames Oxfordshire | British | 2039620001 | ||||||
| SUSSENS, John Gilbert | Geschäftsführer | Blythe House 10 Grange Road Bidford On Avon B50 4BY Alcester Warwickshire | England | British | 1442450002 | |||||
| TAYLOR, David | Geschäftsführer | Honeywood Atch Lench Road Church Lench WR11 4UG Evesham Worcestershire | British | 1439590001 | ||||||
| THOMAS, Clive Jeremy | Geschäftsführer | 1 Hawkridge Cottage Hawkridge Hill RG18 9XA Frilsham Thatcham Berkshire | United Kingdom | British | 157829380001 | |||||
| TOSH, Stephen Leonard | Geschäftsführer | 3 Doddington Place Trallwn CF37 4LN Pontypridd Mid Glamorgan | British | 74102060001 | ||||||
| WEIR, Robert James | Geschäftsführer | 35 Blackhorse Lane SG4 9EG Hitchin Hertfordshire | British | 59711990001 |
Hat REDSKY IT (593) LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Guarantee & debenture | Erstellt am 21. Dez. 2000 Geliefert am 09. Jan. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 27. Jan. 1999 Geliefert am 04. Feb. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee acting as security trustee for the beneficiaries (as therein defined) under or pursuant to the senior finance documents (as therein defined) and all monies due or owing to each beneficiary by each other company (except as a guarantor for the chargor giving this covenant) under or pursuant to the senior finance documents and on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Collateral debenture | Erstellt am 17. Jan. 1994 Geliefert am 26. Jan. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from palm technology PLC to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 20. Dez. 1991 Geliefert am 24. Dez. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a facility letter of even date not exceeding £150,000 | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 20. Dez. 1991 Geliefert am 24. Dez. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 20. Dez. 1989 Geliefert am 05. Jan. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Further guarantee & debenture | Erstellt am 24. Juni 1980 Geliefert am 01. Juli 1980 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever. | |
Kurze Angaben All that property, undertaking & assets charged by the principal deed. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat REDSKY IT (593) LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0