LEINSTER SQUARE PROPCO LIMITED

LEINSTER SQUARE PROPCO LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameLEINSTER SQUARE PROPCO LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01082787
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von LEINSTER SQUARE PROPCO LIMITED?

    • Hotels und ähnliche Unterkünfte (55100) / Gastgewerbe

    Wo befindet sich LEINSTER SQUARE PROPCO LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von LEINSTER SQUARE PROPCO LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    HOTEL VIENNA LIMITED26. Feb. 201326. Feb. 2013

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von LEINSTER SQUARE PROPCO LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2013

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für LEINSTER SQUARE PROPCO LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für LEINSTER SQUARE PROPCO LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 20. Apr. 2015

    5 Seiten4.68

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    5 Seiten4.71

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 23 Savile Row London W1S 2ET zum 55 Baker Street London W1U 7EU am 24. Okt. 2014

    2 SeitenAD01

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    3 Seiten4.70

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 14. Okt. 2014

    LRESSP

    Jahresrückblick erstellt bis 01. Juni 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital11. Juni 2014

    Kapitalaufstellung am 11. Juni 2014

    • Kapital: GBP 100
    SH01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * 25 Hanover Square London W1S 1JF England* am 12. Feb. 2014

    1 SeitenAD01

    Erfüllung der Belastung 22 vollständig

    2 SeitenMR04

    Ernennung von Mr Joseph Robert Wekselblatt als Direktor

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr Daniel Robert Dudley Pound als Direktor

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr Anuj Kumar Mittal als Direktor

    2 SeitenAP01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * 25 Hanover Square London W1S 1JF England* am 29. Jan. 2014

    1 SeitenAD01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * 16 Leinster Square Bayswater London W2 4PR* am 29. Jan. 2014

    1 SeitenAD01

    Beendigung der Bestellung von Simon Perkins als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Peter Lowy als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Brian Levy als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Brian Levy als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Vorheriger Abrechnungszeitraum verkürzt von 31. März 2014 bis 31. Dez. 2013

    3 SeitenAA01

    Bescheinigung über die Änderung der Firma

    Company name changed hotel vienna LIMITED\certificate issued on 16/01/14
    5 SeitenCERTNM
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    change-of-name16. Jan. 2014

    Beschluss zur Änderung der Firma am 24. Dez. 2013

    RES15

    Hinweis auf Namensänderung

    2 SeitenCONNOT

    Erfüllung der Belastung 19 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 10 vollständig

    4 SeitenMR04

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2013

    17 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von LEINSTER SQUARE PROPCO LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    MITTAL, Anuj Kumar
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    Geschäftsführer
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    NetherlandsAmerican168603850001
    POUND, Daniel Robert Dudley
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    Geschäftsführer
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    United KingdomBritish88722950003
    WEKSELBLATT, Joseph R
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    Geschäftsführer
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    United StatesAmerican150233850001
    LEVY, Brian Francis
    The Blue House
    Pauletts Lane
    SO40 2RS Calmore
    Hampshire
    Sekretär
    The Blue House
    Pauletts Lane
    SO40 2RS Calmore
    Hampshire
    British36594200002
    ALSAGOFF, Declan
    Ranulf Road
    NW2 2BS London
    35
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Ranulf Road
    NW2 2BS London
    35
    United Kingdom
    EnglandBritish56520590004
    BHALLA, Rakesh
    92 Canfield Gardens
    West Hampstead
    NW8 3EE London
    Geschäftsführer
    92 Canfield Gardens
    West Hampstead
    NW8 3EE London
    United KingdomBritish6129150002
    COLLIS, Stephen James
    56 Stapleton Road
    WD6 5BW Borehamwood
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    56 Stapleton Road
    WD6 5BW Borehamwood
    Hertfordshire
    British29223310001
    EDEN, Robin Clive
    2 Linfield Close
    Hendon
    NW4 1BZ London
    Geschäftsführer
    2 Linfield Close
    Hendon
    NW4 1BZ London
    EnglandBritish29223280002
    LEVY, Brian Francis
    The Blue House
    Pauletts Lane
    SO40 2RS Calmore
    Hampshire
    Geschäftsführer
    The Blue House
    Pauletts Lane
    SO40 2RS Calmore
    Hampshire
    EnglandBritish36594200002
    LOVELOCK, Barry Edward
    3 Stockdale
    Toddington
    LU5 6EB Dunstable
    Bedfordshire
    Geschäftsführer
    3 Stockdale
    Toddington
    LU5 6EB Dunstable
    Bedfordshire
    United KingdomBritish39375440001
    LOWY, Elizabeth
    35 Ranulf Road
    NW2 2BS London
    Geschäftsführer
    35 Ranulf Road
    NW2 2BS London
    United KingdomBritish5828980001
    LOWY, Hertha
    12 Southbury
    NW8 0RY London
    Geschäftsführer
    12 Southbury
    NW8 0RY London
    British29223300001
    LOWY, Peter Michael
    1 Rudgwick Terrace
    Avenue Road
    NW8 6BR London
    Geschäftsführer
    1 Rudgwick Terrace
    Avenue Road
    NW8 6BR London
    United KingdomBritish5828990005
    LOWY, Stephen Julius
    35 Ranulf Road
    NW2 2BS London
    Geschäftsführer
    35 Ranulf Road
    NW2 2BS London
    United KingdomBritish104311640001
    LOWY, Tracy
    45 Brondesbury Park
    NW6 7AY London
    High Flower
    Geschäftsführer
    45 Brondesbury Park
    NW6 7AY London
    High Flower
    United KingdomBritish138051760001
    MANNING, Justin Michael
    41-43 St James's Street
    BN2 1RG Brighton
    Apartment 8
    E Sussex
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    41-43 St James's Street
    BN2 1RG Brighton
    Apartment 8
    E Sussex
    United Kingdom
    EnglandBritish137786130001
    PERKINS, Simon Donald
    23 Daphne Close
    CM77 7YZ Great Notley
    Essex
    Geschäftsführer
    23 Daphne Close
    CM77 7YZ Great Notley
    Essex
    United KingdomBritish94760110001
    SOESAN, Carmel
    First Floor Flat
    29 Compton Avenue
    BN1 3PT Brighton
    East Sussex
    Geschäftsführer
    First Floor Flat
    29 Compton Avenue
    BN1 3PT Brighton
    East Sussex
    British10555240002
    TAYLER, Jackie
    Fron Fawr
    SA37 0HS Boncath
    Dyfed
    Geschäftsführer
    Fron Fawr
    SA37 0HS Boncath
    Dyfed
    British6129140004
    WOODWARD, John
    1 Stile Hall Gardens
    Chiswick
    W4 3BS London
    Geschäftsführer
    1 Stile Hall Gardens
    Chiswick
    W4 3BS London
    British49157970001

    Hat LEINSTER SQUARE PROPCO LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Deed of legal charge
    Erstellt am 05. Jan. 2012
    Geliefert am 12. Jan. 2012
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from lowy holdings limited to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property k/a umi london 13,14,15,16,17,18 and 19 leinster square london and l/h property k/a kings hotel kings road brighton together with all buildings and erections and fixtures (but excluding tenants fixtures) and fixed plant and machinery thereon, all improvements and additions thereto and all easements rights licences appurtenant thereto, subject to and with the benefit of all existing leases underleases tenancies agreements to lease rights covenants under conditions affecting the same.
    Berechtigte Personen
    • Aviva Commercial Finance Limited
    Transaktionen
    • 12. Jan. 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 05. Feb. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Deed
    Erstellt am 07. Apr. 2006
    Geliefert am 12. Apr. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The sum of £41,125 and any other sums. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Woburn Estate Company Limited and Bedford Estate Nominees Limited
    Transaktionen
    • 12. Apr. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Nov. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 27. Juni 2005
    Geliefert am 05. Juli 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The security deposit of £3,563.00 and all sums from time to time constituting the same and any additional sums. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Harold Mackover
    Transaktionen
    • 05. Juli 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Nov. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal mortgage
    Erstellt am 09. März 1999
    Geliefert am 12. März 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H the burns hotel 18/26 barkston gardens london SW5. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. März 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Dez. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    First fixed charge over credit balances
    Erstellt am 15. Apr. 1998
    Geliefert am 22. Apr. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All amounts from time to time standing to the credit of an account in the name of national westminster bank PLC held at st james's street branch (sort code 60-18-18 account number 25038958).
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 22. Apr. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Dez. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Assignment
    Erstellt am 16. Nov. 1995
    Geliefert am 24. Nov. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All amounts outstanding under a facility letter dated 25TH may 1995 between the assignor and the borrower (the pavilion hotel limited) together with any subsequent amendments thereto replacements thereof and supplemental agreements thereto between the assignor and the borrower
    Kurze Angaben
    All the company's right title and interest in and under the agreement (the facility letter) and the "security documents" (as defined). See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 24. Nov. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Juni 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge over credit balances
    Erstellt am 21. Juni 1995
    Geliefert am 28. Juni 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The sum £200,000 together with interest accrued now or to be held by the national westminster bank PLC on an account numbered 25038958 and earmarked or designated by reference to the company.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 28. Juni 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Dez. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal mortgage
    Erstellt am 22. Dez. 1994
    Geliefert am 04. Jan. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The l/h property k/as darwin lodge 16 westbourne street london borough city of westminster.t/no.ngl 575186 and the proceeds of sale thereof together with. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 04. Jan. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Dez. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 16. Mai 1994
    Geliefert am 20. Mai 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All that f/h land and buildings situate at and k/a 13,14,15,16,17,18 and 19 leinster square london W2T/n NGL194196 with all buildings and fixtures and all plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Fennoscandia Bank Limited
    Transaktionen
    • 20. Mai 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    • 20. Mai 1994Registrierung einer Belastung (395)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 26. Jan. 1994
    Geliefert am 08. Feb. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The whole or any part of the rents payable by the company to the chargee pusrsuant to the lease and this deed
    Kurze Angaben
    The deposit of £21,666.00.
    Berechtigte Personen
    • Banounah Investment Company Limited
    Transaktionen
    • 08. Feb. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Nov. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal mortgage
    Erstellt am 08. Dez. 1992
    Geliefert am 21. Dez. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    78 and 79 kensington gardens square city of westminster t/NLN153254 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 21. Dez. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Jan. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 06. Nov. 1992
    Geliefert am 25. Nov. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The whole or any part of the rent reserved by a lease dated 7TH july 1992 or any monies payable by the company to the chargee pursuant to the lease
    Kurze Angaben
    All the interest of the mortgagor in the rent deposit of £21,666.00.
    Berechtigte Personen
    • Metropolitan Associated Investment Corporation PLC
    Transaktionen
    • 25. Nov. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Jan. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge over book debts
    Erstellt am 18. Feb. 1992
    Geliefert am 25. Feb. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific charge over the benefit of all book debts and other debts as are now or may from time to time be due or owing to the company (see form 395 for full details).
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Feb. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Dez. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Rent deposit agreement
    Erstellt am 06. Dez. 1991
    Geliefert am 21. Dez. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of the lease
    Kurze Angaben
    £4,584 together with any additional principal monies deposited from time to time and all interest earned.
    Berechtigte Personen
    • Palliser Holdings Limited
    Transaktionen
    • 21. Dez. 1991Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Jan. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage registered pursuant to an order of court d/d 30/11/89
    Erstellt am 14. Juli 1989
    Geliefert am 18. Dez. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Property situate & k/as 13/19 (inclusive) leinster square. London W5 t/ n ngl 194196. undertaking and all property and assets present and future including goodwill, uncalled capital.
    Berechtigte Personen
    • Fennoscandia Bank Limited
    Transaktionen
    • 18. Dez. 1989Registrierung einer Belastung
    • 22. Nov. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal mortgage
    Erstellt am 14. Juli 1989
    Geliefert am 31. Juli 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Darwin lodge hotel 16 westbourne street london W2. And the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 31. Juli 1989Registrierung einer Belastung
    • 01. Juni 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 04. Feb. 1988
    Geliefert am 17. Feb. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    37 craven hill gardens westminster. Title no. Ngl 514908 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 17. Feb. 1988Registrierung einer Belastung
    • 01. Dez. 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 12. Nov. 1986
    Geliefert am 25. Nov. 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    80, 81 and 82 kensington gardens square, bayswater. T.N. ln 48867 416050 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Nov. 1986Registrierung einer Belastung
    • 23. Jan. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 25. Mai 1984
    Geliefert am 29. Mai 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    13, 14, 15, 16, 17, 18 and 19 leinster square, london W2 tn: ngl 194196 and/or the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 29. Mai 1984Registrierung einer Belastung
    • 20. Apr. 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 24. Juni 1982
    Geliefert am 29. Juni 1982
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H interest in 156, 158, 160 and 162 sutherland avenue, maida vale london. W.9. t/n ngl 399835 (part). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 29. Juni 1982Registrierung einer Belastung
    Second mortgage
    Erstellt am 29. Okt. 1981
    Geliefert am 03. Nov. 1981
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the licence of even date herewith
    Kurze Angaben
    F/H 78/79 kensington garden square, paddington, london W2 T.N. ln 153254. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Commonwealth Holiday Inns of Canada Limited
    Transaktionen
    • 03. Nov. 1981Registrierung einer Belastung
    Legal mortgage
    Erstellt am 30. Juni 1981
    Geliefert am 09. Juli 1981
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H & l/h 2 randolph avenue, maida vale, london W.9. T.n's ln 198027 & part ln 133348. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 09. Juli 1981Registrierung einer Belastung

    Hat LEINSTER SQUARE PROPCO LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    30. Juli 2015Aufgelöst am
    14. Okt. 2014Beginn der Liquidation
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Malcolm Cohen
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Praktiker
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0