LEINSTER SQUARE PROPCO LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | LEINSTER SQUARE PROPCO LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01082787 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von LEINSTER SQUARE PROPCO LIMITED?
- Hotels und ähnliche Unterkünfte (55100) / Gastgewerbe
Wo befindet sich LEINSTER SQUARE PROPCO LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 55 Baker Street W1U 7EU London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von LEINSTER SQUARE PROPCO LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| HOTEL VIENNA LIMITED | 26. Feb. 2013 | 26. Feb. 2013 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von LEINSTER SQUARE PROPCO LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2013 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für LEINSTER SQUARE PROPCO LIMITED?
| Jahresabschluss |
|
|---|
Welche sind die letzten Einreichungen für LEINSTER SQUARE PROPCO LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 20. Apr. 2015 | 5 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 5 Seiten | 4.71 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 23 Savile Row London W1S 2ET zum 55 Baker Street London W1U 7EU am 24. Okt. 2014 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Juni 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * 25 Hanover Square London W1S 1JF England* am 12. Feb. 2014 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 22 vollständig | 2 Seiten | MR04 | ||||||||||
Ernennung von Mr Joseph Robert Wekselblatt als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Daniel Robert Dudley Pound als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Anuj Kumar Mittal als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * 25 Hanover Square London W1S 1JF England* am 29. Jan. 2014 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * 16 Leinster Square Bayswater London W2 4PR* am 29. Jan. 2014 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Simon Perkins als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Peter Lowy als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Brian Levy als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Brian Levy als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verkürzt von 31. März 2014 bis 31. Dez. 2013 | 3 Seiten | AA01 | ||||||||||
Bescheinigung über die Änderung der Firma Company name changed hotel vienna LIMITED\certificate issued on 16/01/14 | 5 Seiten | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
Hinweis auf Namensänderung | 2 Seiten | CONNOT | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 19 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 10 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2013 | 17 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von LEINSTER SQUARE PROPCO LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MITTAL, Anuj Kumar | Geschäftsführer | Baker Street W1U 7EU London 55 | Netherlands | American | 168603850001 | |||||
| POUND, Daniel Robert Dudley | Geschäftsführer | Baker Street W1U 7EU London 55 | United Kingdom | British | 88722950003 | |||||
| WEKSELBLATT, Joseph R | Geschäftsführer | Baker Street W1U 7EU London 55 | United States | American | 150233850001 | |||||
| LEVY, Brian Francis | Sekretär | The Blue House Pauletts Lane SO40 2RS Calmore Hampshire | British | 36594200002 | ||||||
| ALSAGOFF, Declan | Geschäftsführer | Ranulf Road NW2 2BS London 35 United Kingdom | England | British | 56520590004 | |||||
| BHALLA, Rakesh | Geschäftsführer | 92 Canfield Gardens West Hampstead NW8 3EE London | United Kingdom | British | 6129150002 | |||||
| COLLIS, Stephen James | Geschäftsführer | 56 Stapleton Road WD6 5BW Borehamwood Hertfordshire | British | 29223310001 | ||||||
| EDEN, Robin Clive | Geschäftsführer | 2 Linfield Close Hendon NW4 1BZ London | England | British | 29223280002 | |||||
| LEVY, Brian Francis | Geschäftsführer | The Blue House Pauletts Lane SO40 2RS Calmore Hampshire | England | British | 36594200002 | |||||
| LOVELOCK, Barry Edward | Geschäftsführer | 3 Stockdale Toddington LU5 6EB Dunstable Bedfordshire | United Kingdom | British | 39375440001 | |||||
| LOWY, Elizabeth | Geschäftsführer | 35 Ranulf Road NW2 2BS London | United Kingdom | British | 5828980001 | |||||
| LOWY, Hertha | Geschäftsführer | 12 Southbury NW8 0RY London | British | 29223300001 | ||||||
| LOWY, Peter Michael | Geschäftsführer | 1 Rudgwick Terrace Avenue Road NW8 6BR London | United Kingdom | British | 5828990005 | |||||
| LOWY, Stephen Julius | Geschäftsführer | 35 Ranulf Road NW2 2BS London | United Kingdom | British | 104311640001 | |||||
| LOWY, Tracy | Geschäftsführer | 45 Brondesbury Park NW6 7AY London High Flower | United Kingdom | British | 138051760001 | |||||
| MANNING, Justin Michael | Geschäftsführer | 41-43 St James's Street BN2 1RG Brighton Apartment 8 E Sussex United Kingdom | England | British | 137786130001 | |||||
| PERKINS, Simon Donald | Geschäftsführer | 23 Daphne Close CM77 7YZ Great Notley Essex | United Kingdom | British | 94760110001 | |||||
| SOESAN, Carmel | Geschäftsführer | First Floor Flat 29 Compton Avenue BN1 3PT Brighton East Sussex | British | 10555240002 | ||||||
| TAYLER, Jackie | Geschäftsführer | Fron Fawr SA37 0HS Boncath Dyfed | British | 6129140004 | ||||||
| WOODWARD, John | Geschäftsführer | 1 Stile Hall Gardens Chiswick W4 3BS London | British | 49157970001 |
Hat LEINSTER SQUARE PROPCO LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Deed of legal charge | Erstellt am 05. Jan. 2012 Geliefert am 12. Jan. 2012 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from lowy holdings limited to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H property k/a umi london 13,14,15,16,17,18 and 19 leinster square london and l/h property k/a kings hotel kings road brighton together with all buildings and erections and fixtures (but excluding tenants fixtures) and fixed plant and machinery thereon, all improvements and additions thereto and all easements rights licences appurtenant thereto, subject to and with the benefit of all existing leases underleases tenancies agreements to lease rights covenants under conditions affecting the same. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed | Erstellt am 07. Apr. 2006 Geliefert am 12. Apr. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The sum of £41,125 and any other sums. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Rent deposit deed | Erstellt am 27. Juni 2005 Geliefert am 05. Juli 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The security deposit of £3,563.00 and all sums from time to time constituting the same and any additional sums. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 09. März 1999 Geliefert am 12. März 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H the burns hotel 18/26 barkston gardens london SW5. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| First fixed charge over credit balances | Erstellt am 15. Apr. 1998 Geliefert am 22. Apr. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All amounts from time to time standing to the credit of an account in the name of national westminster bank PLC held at st james's street branch (sort code 60-18-18 account number 25038958). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Assignment | Erstellt am 16. Nov. 1995 Geliefert am 24. Nov. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All amounts outstanding under a facility letter dated 25TH may 1995 between the assignor and the borrower (the pavilion hotel limited) together with any subsequent amendments thereto replacements thereof and supplemental agreements thereto between the assignor and the borrower | |
Kurze Angaben All the company's right title and interest in and under the agreement (the facility letter) and the "security documents" (as defined). See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge over credit balances | Erstellt am 21. Juni 1995 Geliefert am 28. Juni 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The sum £200,000 together with interest accrued now or to be held by the national westminster bank PLC on an account numbered 25038958 and earmarked or designated by reference to the company. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 22. Dez. 1994 Geliefert am 04. Jan. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The l/h property k/as darwin lodge 16 westbourne street london borough city of westminster.t/no.ngl 575186 and the proceeds of sale thereof together with. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 16. Mai 1994 Geliefert am 20. Mai 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All that f/h land and buildings situate at and k/a 13,14,15,16,17,18 and 19 leinster square london W2T/n NGL194196 with all buildings and fixtures and all plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Rent deposit deed | Erstellt am 26. Jan. 1994 Geliefert am 08. Feb. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag The whole or any part of the rents payable by the company to the chargee pusrsuant to the lease and this deed | |
Kurze Angaben The deposit of £21,666.00. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 08. Dez. 1992 Geliefert am 21. Dez. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 78 and 79 kensington gardens square city of westminster t/NLN153254 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Rent deposit deed | Erstellt am 06. Nov. 1992 Geliefert am 25. Nov. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag The whole or any part of the rent reserved by a lease dated 7TH july 1992 or any monies payable by the company to the chargee pursuant to the lease | |
Kurze Angaben All the interest of the mortgagor in the rent deposit of £21,666.00. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge over book debts | Erstellt am 18. Feb. 1992 Geliefert am 25. Feb. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific charge over the benefit of all book debts and other debts as are now or may from time to time be due or owing to the company (see form 395 for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Rent deposit agreement | Erstellt am 06. Dez. 1991 Geliefert am 21. Dez. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of the lease | |
Kurze Angaben £4,584 together with any additional principal monies deposited from time to time and all interest earned. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage registered pursuant to an order of court d/d 30/11/89 | Erstellt am 14. Juli 1989 Geliefert am 18. Dez. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Property situate & k/as 13/19 (inclusive) leinster square. London W5 t/ n ngl 194196. undertaking and all property and assets present and future including goodwill, uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 14. Juli 1989 Geliefert am 31. Juli 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Darwin lodge hotel 16 westbourne street london W2. And the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 04. Feb. 1988 Geliefert am 17. Feb. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 37 craven hill gardens westminster. Title no. Ngl 514908 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 12. Nov. 1986 Geliefert am 25. Nov. 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 80, 81 and 82 kensington gardens square, bayswater. T.N. ln 48867 416050 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 25. Mai 1984 Geliefert am 29. Mai 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben 13, 14, 15, 16, 17, 18 and 19 leinster square, london W2 tn: ngl 194196 and/or the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 24. Juni 1982 Geliefert am 29. Juni 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H interest in 156, 158, 160 and 162 sutherland avenue, maida vale london. W.9. t/n ngl 399835 (part). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Second mortgage | Erstellt am 29. Okt. 1981 Geliefert am 03. Nov. 1981 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the licence of even date herewith | |
Kurze Angaben F/H 78/79 kensington garden square, paddington, london W2 T.N. ln 153254. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 30. Juni 1981 Geliefert am 09. Juli 1981 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H & l/h 2 randolph avenue, maida vale, london W.9. T.n's ln 198027 & part ln 133348. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat LEINSTER SQUARE PROPCO LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0