BPI 2026 LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | BPI 2026 LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01094156 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von BPI 2026 LIMITED?
- (2416) /
Wo befindet sich BPI 2026 LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | One London Wall EC2Y 5AB London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von BPI 2026 LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| POLYCON PACKAGING LIMITED | 28. Apr. 1995 | 28. Apr. 1995 |
| POLYCON PACKAGING (EAST ANGLIA) LIMITED | 02. Feb. 1973 | 02. Feb. 1973 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BPI 2026 LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2009 |
Welche sind die letzten Einreichungen für BPI 2026 LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 11. Feb. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Hinweis auf Namensänderung | 2 Seiten | CONNOT | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 11. Feb. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für David George Duthie am 15. Feb. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Raymond Bernard Brooksbank am 15. Feb. 2010 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für British Polythene Limited am 05. Feb. 2010 | 2 Seiten | CH02 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2006 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2005 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2004 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 6 Seiten | 363s | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von BPI 2026 LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BROOKSBANK, Raymond Bernard | Sekretär | One London Wall EC2Y 5AB London | British | 2160590014 | ||||||||||
| DUTHIE, David George | Geschäftsführer | One London Wall EC2Y 5AB London | Scotland | British | 131295330001 | |||||||||
| BRITISH POLYTHENE LIMITED | Geschäftsführer | London Wall EC2Y 5AB London One United Kingdom |
| 41401970003 | ||||||||||
| MITCHELL, Stephen Mark | Sekretär | Virginai House Hindolveston Road NR20 5RX Foulsham Norfolk | British | 85710570001 | ||||||||||
| ALDERTON, Ian John | Geschäftsführer | Lanteglos Farrow Close Swanton Morley NR20 4RN Dereham Norfolk | Gb-Eng | British | 105681460001 | |||||||||
| EDWARDS, Robert Charles | Geschäftsführer | Old Hall Farm Smallburgh NR12 9NW Norwich Norfolk | United Kingdom | British | 25110020001 | |||||||||
| KEIZER, Alan | Geschäftsführer | Old Hall Trowse NR14 8SR Norwich Norfolk | British | 78324870001 | ||||||||||
| LANGLANDS, John Thomson | Geschäftsführer | 112 Braid Road EH10 6AS Edinburgh | Scotland | British | 722090001 | |||||||||
| MITCHELL, Stephen Mark | Geschäftsführer | Virginai House Hindolveston Road NR20 5RX Foulsham Norfolk | British | 85710570001 | ||||||||||
| PATON, John Ferguson | Geschäftsführer | Tudor House 9 The Crescent PA17 5DX Skelmorlie Ayrshire | British | 654690001 | ||||||||||
| WELLS, Kevin Paul | Geschäftsführer | Claeg 70 Station Road Ormesby St Margaret NR29 3NH Great Yarmouth Norfolk | British | 2267020002 |
Hat BPI 2026 LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Credit agreement | Erstellt am 15. Juli 1992 Geliefert am 22. Juli 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £18397.00 due or to become due from the company to the chargee under the terms of the agreement | |
Kurze Angaben All sums payable under the insurance see 395 223 c 27/7 for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 17. Juni 1992 Geliefert am 22. Juni 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The f/h property k/a land factory and other buildings being part 0.S5 at fakenham road weston longville norfolk and PART0.S.5 At fakenham road morton norfolk and/or the proceeds of sale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 06. Aug. 1991 Geliefert am 14. Aug. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. (See form 395 relevant to this charge). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Credit application | Erstellt am 25. Juli 1991 Geliefert am 15. Aug. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £18,603-40 under the terms of the credit application | |
Kurze Angaben All right title and interest in and to all sums payable under the insurance. (See form 395 relevant to this charge). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 02. Mai 1991 Geliefert am 08. Mai 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 30. März 1984 Geliefert am 12. Apr. 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/Hold orchard house, 2, orchard bank, drayton, norwich, norfolk. And/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 14. Feb. 1984 Geliefert am 20. Feb. 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H industrial land at denwade, norwich and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 01. Feb. 1984 Geliefert am 10. Feb. 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/Hold plot 13 with factory on carlton park industrial estate, saxmundham, suffolk. &/Or the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 01. Feb. 1984 Geliefert am 10. Feb. 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/Hold plot 12 with factory on carlton park industrial estate, saxmundham, suffolk. &/Or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0