SANDTOFT TRADING LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | SANDTOFT TRADING LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01094518 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von SANDTOFT TRADING LIMITED?
- Herstellung von Ziegeln, Fliesen und anderen Baukeramikerzeugnissen aus gebranntem Ton (23320) / Verarbeitendes Gewerbe
Wo befindet sich SANDTOFT TRADING LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Wienerberger House Brooks Drive Cheadle Royal Business Park SK8 3SA Cheadle Cheshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von SANDTOFT TRADING LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| SANDTOFT ROOF TILES LIMITED | 10. Juli 1991 | 10. Juli 1991 |
| GOXHILL TILERIES LIMITED | 06. Feb. 1973 | 06. Feb. 1973 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SANDTOFT TRADING LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2014 |
Welche sind die letzten Einreichungen für SANDTOFT TRADING LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 6 Seiten | 4.71 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 11 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr Harald Anton Schwarzmayr als Direktor am 26. Aug. 2014 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Nicholas James Oldridge als Geschäftsführer am 09. Jan. 2015 | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Martin Henry Oldridge als Geschäftsführer am 08. Jan. 2015 | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Simon Dominic Sinclair Oldridge als Geschäftsführer am 09. Jan. 2015 | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 17. Dez. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Erfüllung der Belastung 7 vollständig | 2 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 2 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 3 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 6 vollständig | 2 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 5 vollständig | 2 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 8 vollständig | 2 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 9 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 4 vollständig | 2 Seiten | MR04 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Bert Jan Koekoek als Geschäftsführer am 26. Aug. 2014 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Michael Grace als Sekretär | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Kaye Few als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 11 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 17. Dez. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 8 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 11 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von SANDTOFT TRADING LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRACE, Michael | Sekretär | Brooks Drive Cheadle Royal Business Park SK8 3SA Cheadle Wienerberger House Cheshire | 188991590001 | |||||||
| SCHWARZMAYR, Harald Anton | Geschäftsführer | Brooks Drive Cheadle Royal Business Park SK8 3SA Cheadle Wienerberger House Cheshire | United Kingdom | Austrian | 103815020002 | |||||
| STEVENSON, Paul | Geschäftsführer | 10 Hill Top Grove West Ardsley WF3 1HP Wakefield West Yorkshire | England | British | 113293590001 | |||||
| CUSK, Katherine Abigail | Sekretär | 279a High Street Boston Spa LS23 6AL Leeds West Yorkshire | British | 100123400002 | ||||||
| FEW, Kaye Suzanne | Sekretär | Bean Leach Avenue Offerton SK2 5JA Stockport 14 Cheshire United Kingdom | 152224780001 | |||||||
| OLDRIDGE, Simon Dominic Sinclair | Sekretär | Highfield Old Park Road Roundhay LS8 1JX Leeds West Yorkshire | British | 69510150002 | ||||||
| PINCHBECK, Christopher | Sekretär | 76 Laceby Road DN34 5BJ Grimsby South Humberside | British | 69510050001 | ||||||
| WAITE, Eric | Sekretär | 8 Roundwood Road Baildon BD17 7JZ Shipley West Yorkshire | British | 7980100003 | ||||||
| BARTLE, John | Geschäftsführer | Mill Road Crowle DN17 4LW Scunthorpe 63 North Lincolnshire England | British | 129311500001 | ||||||
| BARTLE, John | Geschäftsführer | Mill Road Crowle DN17 4LW Scunthorpe 63 North Lincolnshire England | British | 129311500001 | ||||||
| CUSK, Katherine Abigail | Geschäftsführer | 279a High Street Boston Spa LS23 6AL Leeds West Yorkshire | British | 100123400002 | ||||||
| DUDDING, John William | Geschäftsführer | Wayside Carr Lane Broomfleet HU15 1RH Brough North Humberside | British | 43260310001 | ||||||
| DUDDING, John William | Geschäftsführer | Wayside Carr Lane Broomfleet HU15 1RH Brough North Humberside | British | 43260310001 | ||||||
| EADLINGTON, Victoria Michelle Sinclair | Geschäftsführer | Horsewells Farm Horsewell Street Gringley On The Hill DN22 9AQ Doncaster South Yorkshire | British | 90047640001 | ||||||
| GOODWIN, Carole Lesley | Geschäftsführer | 22 Main Road S21 3UT Renishaw North East Derbyshire | United Kingdom | British | 116031480001 | |||||
| KOEKOEK, Bert Jan | Geschäftsführer | Bernhardstraat 11 4175 Ed Haaften The Netherlands | Netherlands | Dutch | 119912460001 | |||||
| OLDRIDGE, Christopher Frederick | Geschäftsführer | Chestnuts Elm Road Waltham DN37 0HR Grimsby South Humberside | British | 7979570001 | ||||||
| OLDRIDGE, Janet | Geschäftsführer | Orchard Croft St Peters Lane Clayworth DN22 9AA Retford Nottinghamshire | British | 58065280002 | ||||||
| OLDRIDGE, Julia Abigail | Geschäftsführer | Bardney Hall DN18 5DF Barton On Humber South Humberside | British | 7979580001 | ||||||
| OLDRIDGE, Martin Henry | Geschäftsführer | Old Vicarage Church Causeway Thorp Arch LS23 7AE Wetherby West Yorkshire | United Kingdom | British | 7979590001 | |||||
| OLDRIDGE, Neville William Sinclair | Geschäftsführer | Orchard Croft Saint Peters Lane, Clayworth DN22 9AA Retford Nottinghamshire | British | 7979600003 | ||||||
| OLDRIDGE, Nicholas James | Geschäftsführer | 11 Gledhow Lane Roundhay LS8 1RT Leeds West Yorkshire | United Kingdom | British | 63463570004 | |||||
| OLDRIDGE, Richard Alexander | Geschäftsführer | 10 New Street Elsham DN20 0RW Brigg North Lincolnshire | British | 7979610004 | ||||||
| OLDRIDGE, Simon Dominic Sinclair | Geschäftsführer | Highfield Old Park Road Roundhay LS8 1JX Leeds West Yorkshire | United Kingdom | British | 69510150002 | |||||
| PINCHBECK, Christopher | Geschäftsführer | 76 Laceby Road DN34 5BJ Grimsby South Humberside | British | 69510050001 | ||||||
| WAITE, Eric | Geschäftsführer | 8 Roundwood Road Baildon BD17 7JZ Shipley West Yorkshire | British | 7980100003 | ||||||
| WATSON, Richard Baillie | Geschäftsführer | Clovelly Wold Road DN19 7BT Barrow Upon Humber South Humberside | British | 43260300001 |
Hat SANDTOFT TRADING LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Chattels mortgage | Erstellt am 21. Sept. 2007 Geliefert am 27. Sept. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All and singular the chattels plant machinery and things described in the schedule hereto or any part thereof being 4 x linde H25D engine counterbalanced trucks,s/no's H2X351NO2497,H2X351NO2499,H2X392UO1636,H2X392UO1630 portasilo ggbs raw materials silo s/no G8346. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Chattels mortgage | Erstellt am 25. Juni 2007 Geliefert am 26. Juni 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Extensions and developments to the existing tile production plant and machinery in factories 1 and 2 at broomfleet summarised as: old english moulds project reference DR64 at a capital cost of £105,107.00 and including rieter werke moulds referee 35 50099 and base plates reference 42 50 009/50 028 for details of further equipment charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Chattels mortgage | Erstellt am 08. Feb. 2007 Geliefert am 09. Feb. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Cep 23/2006 project at a capital cost of £12,071.05: robatech UK hot melt application equipment, concept b 5/4 KPC12 c/w CLSIK48 s/no 20060703/0720, cep 08/2006 project at a capital cost of £12,640.70: nordson premium ridge adhesive equipment s/nos SAO5J22414, TAO6A1822/1827, SAO6A98749/98, AN06A00689, AN05M00508, cep 40/2006 project at a capital cost of £239,255.68: hand made production area equipment including reiter screen feeder type sr 1500 s/no 400-06-M05060 for details of further equipment charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed charge on purchased debts which fail to vest | Erstellt am 12. Jan. 2007 Geliefert am 16. Jan. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of fixed equitable charge all debts purchased or purported to be purchased by the security holder pursuant to an agreement for the purchase of debts between the security holder and the company (including associated rights relating thereto) which fail to vest effectively or absolutely in the security holder for any reason. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Chattels mortgage | Erstellt am 21. Okt. 2005 Geliefert am 22. Okt. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Drying tray circuit main line, tunnel dryer main line, including prefabricated structure, ventilation, ducts, burners, dryer cars (34), trays (19 584), power cabinets, PLC, wiring for further details of the items of plant charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Chattels mortgage | Erstellt am 11. Okt. 2004 Geliefert am 12. Okt. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All and singular the chattels plant machinery and things described in the schedule to the form 395 or any part thereof comprising clay preparation plant broomfleet no 1 dr-6/1 line broomfleet no 1 specials fittings broomfleet no 1 dr-6/iv line. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 10. Sept. 2004 Geliefert am 15. Sept. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 10. Sept. 2004 Geliefert am 15. Sept. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 12. Mai 2003 Geliefert am 14. Mai 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat SANDTOFT TRADING LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0