TWINAPLATE LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | TWINAPLATE LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01098067 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von TWINAPLATE LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich TWINAPLATE LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 5 Aldermanbury Square 13th Floor EC2V 7HR London England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von TWINAPLATE LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2013 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für TWINAPLATE LIMITED?
| Jahresabschluss |
|
|---|
Welche sind die letzten Einreichungen für TWINAPLATE LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 99 Gresham Street London EC2V 7NG zum 5 Aldermanbury Square 13Th Floor London EC2V 7HR am 04. Mai 2015 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 25. Nov. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 20. Nov. 2014
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | RESOLUTIONS | |||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 25. Nov. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Ola Barreto-Morley als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 25. Nov. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Giles Matthew Hudson am 21. Mai 2012 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 30. Nov. 2011 bis 31. Dez. 2011 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 25. Nov. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Nov. 2010 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 25. Nov. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Ola Tricia Aramita Barreto-Morley am 01. Okt. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Nov. 2009 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 25. Nov. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Philip Matthew Deakin am 01. Okt. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von TWINAPLATE LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S & J REGISTRARS LIMITED | Sekretär | Gresham Street EC2V 7NG London 99 United Kingdom |
| 43122090005 | ||||||||||
| DEAKIN, Philip Matthew | Geschäftsführer | Aldermanbury Square 13th Floor EC2V 7HR London 5 England | United Kingdom | British | 146225080002 | |||||||||
| HUDSON, Giles Matthew | Geschäftsführer | Aldermanbury Square 13th Floor EC2V 7HR London 5 England | United Kingdom | British | 161583790003 | |||||||||
| UFLAND, Edward | Geschäftsführer | Aldermanbury Square 13th Floor EC2V 7HR London 5 England | United Kingdom | British | 87558180001 | |||||||||
| MARTIN, Patrick Gerald | Sekretär | Tywarn Lodge Silverwell Blackwater TR4 8JJ Truro Cornwall | British | 18087310001 | ||||||||||
| TEARLE, Michael John | Sekretär | 5 Penhale Road Golden Bank TR11 5UZ Falmouth Cornwall | British | 33606620001 | ||||||||||
| WATSON, Thomas | Sekretär | 6201 Coconut Terrace 33317 Plantation Broward County Florida Usa | American | 42132880001 | ||||||||||
| ASHWORTH, Frederick William | Geschäftsführer | 3 Priory Gardens Porters Lane Oakwood Breadsall DE21 4TG Derby | British | 58804870001 | ||||||||||
| BARRETO-MORLEY, Ola Tricia Aramita | Geschäftsführer | 99 Gresham Street London EC2V 7NG | England | British,Portuguese | 140644240001 | |||||||||
| BOTT, James Derek | Geschäftsführer | Kennall Vale House Ponsanooth TR3 7HL Truro Cornwall | British | 18087320001 | ||||||||||
| CORRY, Thornton Roger | Geschäftsführer | Ardvara 20 Circular Road West BT18 0AX Holywood County Down Northern Ireland | Northern Ireland | British | 143027250001 | |||||||||
| CRONJE, Christiaan Andreas | Geschäftsführer | 439 Maraisstreet Brooklyn FOREIGN Pretoria Gauteng 0181 South Africa | South African | 73598660001 | ||||||||||
| DONNINI, Ronnie Ray | Geschäftsführer | 6701 Nantucket Lane 76001 Arlington Texas Usa | American | 52475510001 | ||||||||||
| HARNDEN, Charles William | Geschäftsführer | 4316 North East 22nd Avenue 33308 Fort Lauderdale Florida Usa | American | 42132790002 | ||||||||||
| MARTIN, Patrick Gerald | Geschäftsführer | Tywarn Lodge Silverwell Blackwater TR4 8JJ Truro Cornwall | British | 18087310001 | ||||||||||
| NASH, Ernest Geoffrey | Geschäftsführer | 10 Salcey Rise Piddington NN7 2DP Northampton Northamptonshire | British | 11862410001 | ||||||||||
| SCHOPP, David Richard | Geschäftsführer | 1390 North Lake Road FOREIGN Lake Forest 60045 Illinois Usa | American | 25600940001 | ||||||||||
| TEARLE, Michael John | Geschäftsführer | 5 Penhale Road Golden Bank TR11 5UZ Falmouth Cornwall | British | 33606620001 | ||||||||||
| TITTERINGTON, Basil James | Geschäftsführer | 29 Windsor Avenue BT9 6EJ Belfast County Antrim Northern Ireland | British | 12736850001 | ||||||||||
| UDALL, Gavin | Geschäftsführer | Summer Lodge Romsey Road, Whiteparish SP5 2SD Salisbury Wiltshire | United Kingdom | British | 83889580001 | |||||||||
| WATSON, Thomas | Geschäftsführer | 6201 Coconut Terrace 33317 Plantation Broward County Florida Usa | American | 42132880001 |
Hat TWINAPLATE LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Guarantee and debenture | Erstellt am 20. März 1995 Geliefert am 25. März 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor (as defined) to the chargee under the terms of the financing documents (as defined) or otherwise | |
Kurze Angaben F/H-threemilestone industrial estate truro. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Single debenture | Erstellt am 18. Mai 1992 Geliefert am 27. Mai 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 25. Apr. 1983 Geliefert am 26. Apr. 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed & floating charges over:- undertaking and all property and assets present and future including goodwill book debts & uncalled capital. And all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 06. Apr. 1981 Geliefert am 21. Apr. 1981 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/Hold land on cornwall county council industrial estate, threemilestone, truro. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Single debenture | Erstellt am 23. Mai 1979 Geliefert am 31. Mai 1979 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed & floating charge undertaking and all property and assets prsent and future including goodwill & uncalled capital. With all fixtures (including trade fixtures) fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0