RIDLEY QUINEY LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameRIDLEY QUINEY LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01100207
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von RIDLEY QUINEY LIMITED?

    • (5156) /
    • (5190) /

    Wo befindet sich RIDLEY QUINEY LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    118 Amington Road
    Yardley
    B25 8JZ Birmingham
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von RIDLEY QUINEY LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    RIDLEY, QUINEY & CO. LIMITED06. März 197306. März 1973

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von RIDLEY QUINEY LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2007

    Welche sind die letzten Einreichungen für RIDLEY QUINEY LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ2

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde ausgesetzt

    1 SeitenDISS16(SOAS)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    4 Seiten363a

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007

    24 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    3 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2006

    22 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288c

    legacy

    1 Seiten288c

    legacy

    1 Seiten288c

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    19 Seiten155(6)a

    legacy

    19 Seiten155(6)a

    legacy

    18 Seiten155(6)a

    legacy

    18 Seiten155(6)a

    Wer sind die Geschäftsführer von RIDLEY QUINEY LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    GILL, Harjainder
    Oaken Lodge
    Oaken Lanes
    WV8 2AH Codsall
    West Midlands
    Sekretär
    Oaken Lodge
    Oaken Lanes
    WV8 2AH Codsall
    West Midlands
    British151578950001
    AUDAS, Robert Graham
    Cherry Blossom
    29 Upton Lane
    CH2 1EB Chester
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Cherry Blossom
    29 Upton Lane
    CH2 1EB Chester
    Cheshire
    EnglandBritishCeo103678030001
    KORAL, Gregory David
    39 St Bernards Road
    B92 7AX Solihull
    West Midlands
    Geschäftsführer
    39 St Bernards Road
    B92 7AX Solihull
    West Midlands
    EnglandBritishFinance Director108145070001
    ALIMAHOMED, Afzal Majid
    51a Church Road
    Edgbaston
    B15 3SJ Birmingham
    West Midlands
    Sekretär
    51a Church Road
    Edgbaston
    B15 3SJ Birmingham
    West Midlands
    BritishDirector1188400002
    CARSWELL, Geoffrey Paul, Dr
    2 Chequers Close
    Ranby
    DN22 8JX Retford
    Nottinghamshire
    Sekretär
    2 Chequers Close
    Ranby
    DN22 8JX Retford
    Nottinghamshire
    British7880930001
    COTES, Peter Charles
    Finchams Farm
    Lower Stow Bedon
    NR17 1EL Attleborough
    Norfolk
    Sekretär
    Finchams Farm
    Lower Stow Bedon
    NR17 1EL Attleborough
    Norfolk
    British8530290002
    MAJID ALIMAHOMED, Shabir
    51a Church Road
    Edgbaston
    B15 3SJ Birmingham
    West Midlands
    Sekretär
    51a Church Road
    Edgbaston
    B15 3SJ Birmingham
    West Midlands
    BritishDirector67515050001
    WALSH, Stephen
    26 Cardinal Way
    RM13 9RB Rainham
    Essex
    Sekretär
    26 Cardinal Way
    RM13 9RB Rainham
    Essex
    BritishAccountant64906050001
    ALIMAHOMED, Abdul Majid
    The Paddocks 51 Church Road
    Edgbaston
    B15 3SJ Birmingham
    West Midlands
    Geschäftsführer
    The Paddocks 51 Church Road
    Edgbaston
    B15 3SJ Birmingham
    West Midlands
    BritishDirector7213370001
    ALIMAHOMED, Afzal Majid
    51a Church Road
    Edgbaston
    B15 3SJ Birmingham
    West Midlands
    Geschäftsführer
    51a Church Road
    Edgbaston
    B15 3SJ Birmingham
    West Midlands
    United Arab EmiratesBritishDirector1188400002
    ALIMAHOMED, Afzal Majid
    51a Church Road
    Edgbaston
    B15 3SJ Birmingham
    West Midlands
    Geschäftsführer
    51a Church Road
    Edgbaston
    B15 3SJ Birmingham
    West Midlands
    United Arab EmiratesBritishDirector1188400002
    BALDREY, Philip Nigel
    34 Saint Bernards Road
    B92 7BB Solihull
    West Midlands
    Geschäftsführer
    34 Saint Bernards Road
    B92 7BB Solihull
    West Midlands
    EnglandBritishCfo44039650003
    BALOGH, Attila
    3 Cypress Gardens
    Four Oaks Park
    B74 2HD Sutton Coldfield
    West Midlands
    Geschäftsführer
    3 Cypress Gardens
    Four Oaks Park
    B74 2HD Sutton Coldfield
    West Midlands
    United KingdomAmericanDirector117533860002
    BERRY, Roger Michael Harvey
    14 Archers Court
    RM15 5BD South Ockendon
    Essex
    Geschäftsführer
    14 Archers Court
    RM15 5BD South Ockendon
    Essex
    BritishManaging Director93667080001
    CARSWELL, Geoffrey Paul, Dr
    2 Chequers Close
    Ranby
    DN22 8JX Retford
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    2 Chequers Close
    Ranby
    DN22 8JX Retford
    Nottinghamshire
    BritishDirector7880930001
    COTES, Peter Charles
    Finchams Farm
    Lower Stow Bedon
    NR17 1EL Attleborough
    Norfolk
    Geschäftsführer
    Finchams Farm
    Lower Stow Bedon
    NR17 1EL Attleborough
    Norfolk
    United KingdomBritishAccountant8530290002
    EVANS, William David
    Well Cottage Stangate Road
    ME19 5JR Birling
    Kent
    Geschäftsführer
    Well Cottage Stangate Road
    ME19 5JR Birling
    Kent
    BritishSales Manager46625750002
    FECHER, Paul
    Instow 17 Woodside Road
    HA6 3QE Northwood
    Middlesex
    Geschäftsführer
    Instow 17 Woodside Road
    HA6 3QE Northwood
    Middlesex
    EnglandBritishDirector8530300001
    GILL, Harjainder
    Oaken Lodge
    Oaken Lanes
    WV8 2AH Codsall
    West Midlands
    Geschäftsführer
    Oaken Lodge
    Oaken Lanes
    WV8 2AH Codsall
    West Midlands
    United KingdomBritishDirector151578950001
    GOODENOUGH, Donald James
    Blandings Sunnydale
    Farnborough Park
    BR6 8LZ Orpington
    Kent
    Geschäftsführer
    Blandings Sunnydale
    Farnborough Park
    BR6 8LZ Orpington
    Kent
    BritishRetired27348410001
    HARVEY, Dennis
    22 Kenilworth Gardens
    IG3 8DU Ilford
    Essex
    Geschäftsführer
    22 Kenilworth Gardens
    IG3 8DU Ilford
    Essex
    BritishCompany Director64906120001
    HARVEY, Dennis John
    45 Northbrook Road
    IG1 3BP Ilford
    Essex
    Geschäftsführer
    45 Northbrook Road
    IG1 3BP Ilford
    Essex
    BritishSalesman45591860001
    MAJID, Shabir
    22 Westbourne Road
    B15 3TX Edgbaston
    Birmingham
    Geschäftsführer
    22 Westbourne Road
    B15 3TX Edgbaston
    Birmingham
    United Arab EmiratesBritishDirector67515050003
    MARZETTI, Tony Phillip
    48 Balstonia Drive
    SS17 8HX Stanford Le Hope
    Essex
    Geschäftsführer
    48 Balstonia Drive
    SS17 8HX Stanford Le Hope
    Essex
    BritishSales Director64906090001
    MCDONOUGH, Brigid Mary
    245 Manor Road
    IG7 6HL Chigwell
    Essex
    Geschäftsführer
    245 Manor Road
    IG7 6HL Chigwell
    Essex
    BritishSales65329940001
    MONAGHAN, Mark
    39 St James Place 34 George Road
    Edgbaston
    B15 1PQ Birmingham
    Geschäftsführer
    39 St James Place 34 George Road
    Edgbaston
    B15 1PQ Birmingham
    BritishGroup Finance Director120881120003
    MOSLEY, Darren James
    Bilbrook 50 West End
    TN15 6QB Kemsing
    Kent
    Geschäftsführer
    Bilbrook 50 West End
    TN15 6QB Kemsing
    Kent
    United KingdomBritishManaging117533900001
    QUINEY, Nigel Evans
    12 Ripplevale Grove
    N1 1HU London
    Geschäftsführer
    12 Ripplevale Grove
    N1 1HU London
    United KingdomBritishDirector21986500002
    SINCLAIR, Colin
    49 Chalkwell Esplanade
    SS0 8JH Westcliff On Sea
    Essex
    Geschäftsführer
    49 Chalkwell Esplanade
    SS0 8JH Westcliff On Sea
    Essex
    BritishSales65068220001
    TAYLOR, Paul Nigel
    215 South Croxted Road
    West Dulwich
    SE21 8AY London
    Geschäftsführer
    215 South Croxted Road
    West Dulwich
    SE21 8AY London
    BritishSalesman27348430001
    UNADKAT, Birju
    22 Greenwich Way
    EN9 3YB Waltham Abbey
    Essex
    Geschäftsführer
    22 Greenwich Way
    EN9 3YB Waltham Abbey
    Essex
    BritishFinancial Director93667180001
    WALSH, Stephen
    26 Cardinal Way
    RM13 9RB Rainham
    Essex
    Geschäftsführer
    26 Cardinal Way
    RM13 9RB Rainham
    Essex
    BritishAccountant64906050001
    WINDLE, Paul Stephen
    203 Bagnall Road
    NG6 8SJ Nottingham
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    203 Bagnall Road
    NG6 8SJ Nottingham
    Nottinghamshire
    EnglandBritishDirector117533470001
    WRIGHT, Christopher Sydney
    69 Galleywood Road
    Great Baddow
    CM2 8DN Chelmsford
    Essex
    Geschäftsführer
    69 Galleywood Road
    Great Baddow
    CM2 8DN Chelmsford
    Essex
    BritishDirector8530320001
    WRIGHT, David
    10 Morhen Close
    ME6 5LZ Snodland
    Kent
    Geschäftsführer
    10 Morhen Close
    ME6 5LZ Snodland
    Kent
    United KingdomBritishSales Director69860240001

    Hat RIDLEY QUINEY LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Security accession deed
    Erstellt am 07. Dez. 2006
    Geliefert am 15. Dez. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties (Thesecurity Agent)
    Transaktionen
    • 15. Dez. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 20. Aug. 1999
    Geliefert am 26. Aug. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    22 ferry lane industrial estate lamson road rainham essex. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Aug. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Nov. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 27. Feb. 1996
    Geliefert am 07. März 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. März 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Nov. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 27. Feb. 1996
    Geliefert am 29. Feb. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H-land to the north east and land to the north west of ferry land rainham k/a 22 lamson road rainham essex in the borough of havering t/nos-EGL80221, EGL215310 and EGL93252 and the proceeds of sale thereof.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 29. Feb. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Nov. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 14. Feb. 1989
    Geliefert am 28. Feb. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All that land lying to the north east of ferry lane rainham in the l/borough of havering t/no 8:- egl 80221 egl 93252 and egl 215310.
    Berechtigte Personen
    • 31 PLC
    Transaktionen
    • 28. Feb. 1989Registrierung einer Belastung
    • 15. Mai 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 30. Jan. 1989
    Geliefert am 06. Feb. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A charge over 22 lamson road, rainham, essex. Title nos etl 80221, etl 93252 & etl 215310 and the proceeds of sale thereof.. A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 06. Feb. 1989Registrierung einer Belastung
    • 07. März 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 20. Okt. 1988
    Geliefert am 26. Okt. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land adjoining land on north side of ferry lane industrial estate rainham title no egl 215310.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Okt. 1988Registrierung einer Belastung
    • 31. Okt. 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 12. Okt. 1983
    Geliefert am 19. Okt. 1983
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H. premises 32-38 safton hill, london EC1 8BS.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Investors in Industry PLC.
    Transaktionen
    • 19. Okt. 1983Registrierung einer Belastung
    • 15. Mai 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge
    Erstellt am 19. Sept. 1983
    Geliefert am 26. Sept. 1983
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All book debts and other debts owing to the company.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Sept. 1983Registrierung einer Belastung
    • 31. Okt. 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 28. Feb. 1979
    Geliefert am 08. März 1979
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Freehold land hereditaments and premises land on the north side of ferry lane industrial estate rainham together with all fixtures present & future.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 08. März 1979Registrierung einer Belastung
    • 31. Okt. 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge
    Erstellt am 05. Feb. 1979
    Geliefert am 08. Feb. 1979
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Floating charge over. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 08. Feb. 1979Registrierung einer Belastung
    • 31. Okt. 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0